WILLMOT PERTWEE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | WILLMOT PERTWEE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03206948 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WILLMOT PERTWEE LIMITED?
- Actividades de apoyo a la producción de cultivos (01610) / Agricultura, silvicultura y pesca
¿Dónde se encuentra WILLMOT PERTWEE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Station Road Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Gloucestershire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WILLMOT PERTWEE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CELANDOR LIMITED | 03 jun 1996 | 03 jun 1996 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WILLMOT PERTWEE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 jul 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WILLMOT PERTWEE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 2 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado de capital el 18 feb 2022
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2021 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2020 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Stephen Matthews como director el 27 feb 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2019 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Neil Reid como director el 19 nov 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Michael Dunne como director el 19 nov 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2018 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Marshall Rennie como director el 20 feb 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Peter Dunne como director el 28 feb 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Imelda Hurley como director el 28 feb 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2017 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Declan Patrick Giblin como director el 21 jul 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Stewart Downie como director el 24 jul 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de WILLMOT PERTWEE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVANS, Spencer Gareth | Director | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire | England | British | 227570820001 | |||||
| HUGHES, Ronan Andrew | Director | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire United Kingdom | England | Irish | 164466890001 | |||||
| REID, Neil | Director | Riverwalk Citywest Business Campus Dublin 24 4-6 D24 Dcw0 Ireland | Ireland | Irish | 266176680001 | |||||
| RENNIE, James Marshall | Director | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire | United Kingdom | British | 245275770001 | |||||
| BADBERG, Sue Ellen | Secretario | 1245 North 13th Street 68410 Nebraska City Nebraska Usa | British | 47974150003 | ||||||
| BRENNAN, Thomas Patrick | Secretario | 1 Penrwyn Court PE19 2SU St Neots Cambridgeshire | British | 202542640001 | ||||||
| MURRAY, David Souter | Secretario | . GL54 4LZ Cheltenham Andoversford Gloucestershire United Kingdom | 164578240001 | |||||||
| RB SECRETARIAT LIMITED | Secretario designado corporativo | Beaufort House Tenth Floor 15 St Botolph Street EC3A 7EE London | 900006270001 | |||||||
| BOLDING, Jay Douglas | Director | 3325 North 134 Circle Omaha Nebraska 68164 Usa | American | 65252730002 | ||||||
| BROWN, Richard | Director | Manor Farmhouse Manor Farm, Eddlethorpe YO17 9QT Malton North Yorkshire | United Kingdom | British | 111686890001 | |||||
| CASEY, Walter | Director | 414 Martin Drive North Bellevue 68005 Nebraska Usa | Amercian | 50862220001 | ||||||
| DERBYSHIRE, Stephen | Director | The Gables Pump Lane, Fenton NG23 5DF Newark Nottinghamshire | England | British | 64532980001 | |||||
| DIFONZO, Kenneth Wayne | Director | 16646 Howard Circle Omaha 68118 Nebraska Usa | Us Citizen | 40453120001 | ||||||
| DOWNIE, David Stewart | Director | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire | England | British | 101857040001 | |||||
| DUNNE, Peter Michael | Director | Riverwalk Citywest Business Campus Dublin 24 4-6 Ireland | Ireland | Irish | 296556910001 | |||||
| FITZGERALD, Brendan | Director | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire United Kingdom | Ireland | Irish | 142986030014 | |||||
| GIBLIN, Declan Patrick | Director | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire United Kingdom | England | Irish | 33529010002 | |||||
| HECKMAN, Gregory Allen | Director | 6711 Davenport Street Omaha Nebraska 681342 Usa | American | 90638610004 | ||||||
| HURLEY, Imelda | Director | Riverwalk Citywest Business Campus Dublin 24 4-6 Ireland | Ireland | Irish | 190470420004 | |||||
| JOHNSON, Owen Charles | Director | 1117 South 113th Court Omaha Nebraska 68144 U S A | U S Citizen | 98512790001 | ||||||
| MATTHEWS, Christopher Stephen | Director | Dale Farm Collingham Road LN6 9JB Swinderby Lincolnshire | England | British | 104573600001 | |||||
| MCKINNERNEY, Floyd | Director | 9309 Fm 462 North Hondo Texas 78861 Usa | American | 48604900002 | ||||||
| MESSEL, Scott Edward | Director | 1124 South 113th Court Omaha Nebraska 68144 U S A | Usa | U S Citizen | 98512890001 | |||||
| MURRAY, David | Director | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire United Kingdom | England | British | 25241430001 | |||||
| O'DONNELL, James Patrick | Director | 1126 S 181 Plaza Omaha Nebraska 68130 U.S.A | Us Citizen | 57520090002 | ||||||
| PRIESTLEY, Richard Paul | Director | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire | United Kingdom | British | 138721210001 | |||||
| ROBERTS, Jamie | Director | Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Station Road Gloucestershire United Kingdom | England | British | 176036360001 | |||||
| SHARP, Barry John | Director | The Old Orchard Bekesbourne Lane Bekesbourne CT4 5DY Canterbury Kent | England | British | 35545820002 | |||||
| THOMAS, Lawrence Bruce | Director | 7813 Pierce Omaha 68124 Nebraska United States Of America | United States | 75675670003 | ||||||
| RB DIRECTORS ONE LIMITED | Director designado corporativo | Beaufort House Tenth Floor 15 St Botolph Street EC3A 7EE London | 900006260001 | |||||||
| RB DIRECTORS TWO LIMITED | Director designado corporativo | Beaufort House Tenth Floor 15 St Botolph Street EC3A 7EE London | 900006250001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de WILLMOT PERTWEE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleancrop Uk Limited | 06 abr 2016 | Station Road Andoversford GL54 4LZ Cheltenham Agrii England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene WILLMOT PERTWEE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 18 abr 2008 Entregado el 29 abr 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| All assets debenture | Creado el 28 abr 2005 Entregado el 07 may 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage | Creado el 28 abr 2005 Entregado el 05 may 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property k/a or being land and buildings on the east side of gorse lane harlaxton linciolnshire t/no LL59771 all book and other debts, any amounts owing by way of rent licence fee service charge or dilapidations. By way of floating charge all stock goods moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. By way of assignment the goodwill, the benefit of all guarantees and the intellectual property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage | Creado el 28 abr 2005 Entregado el 05 may 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property k/a or being land and buildings on the west side of asperton road wigtoft lincolnshire t/no LL117979. All book and other debts, any amounts owing by way of rent licence fee service charge or dilapidations. By way of floating charge all stock goods moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. By way of assignment the goodwill, the benefit of all guarantees and the intellectual property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0