WILLMOT PERTWEE LIMITED

WILLMOT PERTWEE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWILLMOT PERTWEE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03206948
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WILLMOT PERTWEE LIMITED?

    • Actividades de apoyo a la producción de cultivos (01610) / Agricultura, silvicultura y pesca

    ¿Dónde se encuentra WILLMOT PERTWEE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Station Road
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WILLMOT PERTWEE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CELANDOR LIMITED03 jun 199603 jun 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WILLMOT PERTWEE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 jul 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WILLMOT PERTWEE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    2 páginasDS01

    Estado de capital el 18 feb 2022

    • Capital: GBP 0.50
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2021

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2020

    17 páginasAA

    Cese del nombramiento de Christopher Stephen Matthews como director el 27 feb 2021

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2019

    18 páginasAA

    Nombramiento de Mr Neil Reid como director el 19 nov 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Peter Michael Dunne como director el 19 nov 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2018

    17 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr James Marshall Rennie como director el 20 feb 2018

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Peter Dunne como director el 28 feb 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Imelda Hurley como director el 28 feb 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2017

    17 páginasAA

    Cese del nombramiento de Declan Patrick Giblin como director el 21 jul 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Stewart Downie como director el 24 jul 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de WILLMOT PERTWEE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    EVANS, Spencer Gareth
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    Director
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    EnglandBritish227570820001
    HUGHES, Ronan Andrew
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Director
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandIrish164466890001
    REID, Neil
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    4-6
    D24 Dcw0
    Ireland
    Director
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    4-6
    D24 Dcw0
    Ireland
    IrelandIrish266176680001
    RENNIE, James Marshall
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    Director
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United KingdomBritish245275770001
    BADBERG, Sue Ellen
    1245 North 13th Street
    68410 Nebraska City
    Nebraska
    Usa
    Secretario
    1245 North 13th Street
    68410 Nebraska City
    Nebraska
    Usa
    British47974150003
    BRENNAN, Thomas Patrick
    1 Penrwyn Court
    PE19 2SU St Neots
    Cambridgeshire
    Secretario
    1 Penrwyn Court
    PE19 2SU St Neots
    Cambridgeshire
    British202542640001
    MURRAY, David Souter
    .
    GL54 4LZ Cheltenham
    Andoversford
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Secretario
    .
    GL54 4LZ Cheltenham
    Andoversford
    Gloucestershire
    United Kingdom
    164578240001
    RB SECRETARIAT LIMITED
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    Secretario designado corporativo
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    900006270001
    BOLDING, Jay Douglas
    3325 North 134 Circle
    Omaha
    Nebraska 68164
    Usa
    Director
    3325 North 134 Circle
    Omaha
    Nebraska 68164
    Usa
    American65252730002
    BROWN, Richard
    Manor Farmhouse
    Manor Farm, Eddlethorpe
    YO17 9QT Malton
    North Yorkshire
    Director
    Manor Farmhouse
    Manor Farm, Eddlethorpe
    YO17 9QT Malton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish111686890001
    CASEY, Walter
    414 Martin Drive North
    Bellevue
    68005 Nebraska
    Usa
    Director
    414 Martin Drive North
    Bellevue
    68005 Nebraska
    Usa
    Amercian50862220001
    DERBYSHIRE, Stephen
    The Gables
    Pump Lane, Fenton
    NG23 5DF Newark
    Nottinghamshire
    Director
    The Gables
    Pump Lane, Fenton
    NG23 5DF Newark
    Nottinghamshire
    EnglandBritish64532980001
    DIFONZO, Kenneth Wayne
    16646 Howard Circle
    Omaha
    68118 Nebraska
    Usa
    Director
    16646 Howard Circle
    Omaha
    68118 Nebraska
    Usa
    Us Citizen40453120001
    DOWNIE, David Stewart
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    Director
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    EnglandBritish101857040001
    DUNNE, Peter Michael
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    4-6
    Ireland
    Director
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    4-6
    Ireland
    IrelandIrish296556910001
    FITZGERALD, Brendan
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Director
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    IrelandIrish142986030014
    GIBLIN, Declan Patrick
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Director
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandIrish33529010002
    HECKMAN, Gregory Allen
    6711 Davenport Street
    Omaha
    Nebraska 681342
    Usa
    Director
    6711 Davenport Street
    Omaha
    Nebraska 681342
    Usa
    American90638610004
    HURLEY, Imelda
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    4-6
    Ireland
    Director
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    4-6
    Ireland
    IrelandIrish190470420004
    JOHNSON, Owen Charles
    1117 South 113th Court
    Omaha
    Nebraska 68144
    U S A
    Director
    1117 South 113th Court
    Omaha
    Nebraska 68144
    U S A
    U S Citizen98512790001
    MATTHEWS, Christopher Stephen
    Dale Farm
    Collingham Road
    LN6 9JB Swinderby
    Lincolnshire
    Director
    Dale Farm
    Collingham Road
    LN6 9JB Swinderby
    Lincolnshire
    EnglandBritish104573600001
    MCKINNERNEY, Floyd
    9309 Fm 462 North
    Hondo
    Texas 78861
    Usa
    Director
    9309 Fm 462 North
    Hondo
    Texas 78861
    Usa
    American48604900002
    MESSEL, Scott Edward
    1124 South 113th Court
    Omaha
    Nebraska 68144
    U S A
    Director
    1124 South 113th Court
    Omaha
    Nebraska 68144
    U S A
    UsaU S Citizen98512890001
    MURRAY, David
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Director
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish25241430001
    O'DONNELL, James Patrick
    1126 S 181 Plaza
    Omaha
    Nebraska 68130
    U.S.A
    Director
    1126 S 181 Plaza
    Omaha
    Nebraska 68130
    U.S.A
    Us Citizen57520090002
    PRIESTLEY, Richard Paul
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    Director
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United KingdomBritish138721210001
    ROBERTS, Jamie
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Director
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Station Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish176036360001
    SHARP, Barry John
    The Old Orchard
    Bekesbourne Lane Bekesbourne
    CT4 5DY Canterbury
    Kent
    Director
    The Old Orchard
    Bekesbourne Lane Bekesbourne
    CT4 5DY Canterbury
    Kent
    EnglandBritish35545820002
    THOMAS, Lawrence Bruce
    7813 Pierce
    Omaha 68124
    Nebraska
    United States Of America
    Director
    7813 Pierce
    Omaha 68124
    Nebraska
    United States Of America
    United States75675670003
    RB DIRECTORS ONE LIMITED
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    Director designado corporativo
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    900006260001
    RB DIRECTORS TWO LIMITED
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    Director designado corporativo
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    900006250001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de WILLMOT PERTWEE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Station Road
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Agrii
    England
    06 abr 2016
    Station Road
    Andoversford
    GL54 4LZ Cheltenham
    Agrii
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05300865
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene WILLMOT PERTWEE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 18 abr 2008
    Entregado el 29 abr 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 29 abr 2008Registro de un cargo (395)
    • 22 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    All assets debenture
    Creado el 28 abr 2005
    Entregado el 07 may 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 07 may 2005Registro de un cargo (395)
    • 24 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 28 abr 2005
    Entregado el 05 may 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a or being land and buildings on the east side of gorse lane harlaxton linciolnshire t/no LL59771 all book and other debts, any amounts owing by way of rent licence fee service charge or dilapidations. By way of floating charge all stock goods moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. By way of assignment the goodwill, the benefit of all guarantees and the intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 05 may 2005Registro de un cargo (395)
    • 24 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 28 abr 2005
    Entregado el 05 may 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a or being land and buildings on the west side of asperton road wigtoft lincolnshire t/no LL117979. All book and other debts, any amounts owing by way of rent licence fee service charge or dilapidations. By way of floating charge all stock goods moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. By way of assignment the goodwill, the benefit of all guarantees and the intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 05 may 2005Registro de un cargo (395)
    • 24 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0