TIME OUT NOMINEES LIMITED

TIME OUT NOMINEES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTIME OUT NOMINEES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03210982
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TIME OUT NOMINEES LIMITED?

    • Edición de libros (58110) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra TIME OUT NOMINEES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    172 Drury Lane 1st Floor
    WC2B 5QR London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TIME OUT NOMINEES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TIME OUT GUIDES LIMITED06 jun 199606 jun 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TIME OUT NOMINEES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TIME OUT NOMINEES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 09 abr 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2021

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Julio Bruno Castellanos como director el 29 oct 2021

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Sven Torbjorn Ohlund como director el 29 oct 2021

    2 páginasAP01

    Cancelación total de la carga 7

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 09 abr 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de 77 Wicklow Street London WC1X 9JY England a 172 Drury Lane 1st Floor London WC2B 5QR el 16 jun 2021

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    7 páginasAA

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2020 au 30 jun 2021

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Adam Silver como director el 31 jul 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 09 abr 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 09 abr 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    2 páginasAA

    Nombramiento de Mr Adam Silver como director el 24 sept 2018

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 09 abr 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Julio Bruno Castellanos el 23 ene 2018

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de 4th Floor 125 Shaftesbury Avenue London WC2H 8AD a 77 Wicklow Street London WC1X 9JY el 19 dic 2017

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 09 abr 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    2 páginasAA

    Cese del nombramiento de Matthew James White como director el 30 abr 2016

    2 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de TIME OUT NOMINEES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    OHLUND, Sven Torbjorn
    1st Floor
    WC2B 5QR London
    172 Drury Lane
    England
    Director
    1st Floor
    WC2B 5QR London
    172 Drury Lane
    England
    SwitzerlandSwedishChief Executive285847720001
    ELLIS, Kevin
    77 Belgrave Road
    E11 3QP London
    Secretario
    77 Belgrave Road
    E11 3QP London
    BritishCompany Director15707530002
    WATERLOW, Richard John
    85 Redston Road
    Crouch End
    N8 7HG London
    Secretario
    85 Redston Road
    Crouch End
    N8 7HG London
    BritishCompany Director87462480002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secretario designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BRUNO CASTELLANOS, Julio
    1st Floor
    WC2B 5QR London
    172 Drury Lane
    England
    Director
    1st Floor
    WC2B 5QR London
    172 Drury Lane
    England
    EnglandSpanish,United StatesExecutive Chairman207866410002
    ELLIOTT, Anthony Michael Manton
    125 Shaftesbury Avenue
    WC2H 8AD London
    4th Floor
    United Kingdom
    Director
    125 Shaftesbury Avenue
    WC2H 8AD London
    4th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director40950620002
    ELLIOTT, Anthony Michael Manton
    65 Marlborough Place
    NW8 0PT London
    Director
    65 Marlborough Place
    NW8 0PT London
    United KingdomBritishCompany Director40950620001
    ELLIS, Kevin
    77 Belgrave Road
    E11 3QP London
    Director
    77 Belgrave Road
    E11 3QP London
    BritishCompany Director15707530002
    FIENNES, Peter Guildford
    60 Thurleigh Road
    SW12 8UD London
    Director
    60 Thurleigh Road
    SW12 8UD London
    EnglandBritishManaging Director95079550001
    GARNER, Gareth
    26 Kimberley Road
    AL3 5PX St. Albans
    Hertfordshire
    Director
    26 Kimberley Road
    AL3 5PX St. Albans
    Hertfordshire
    BritishCompany Director120647130001
    HARDWICK, Michael William
    45 High Road
    Cookham
    SL6 9HR Maidenhead
    Berkshire
    Director
    45 High Road
    Cookham
    SL6 9HR Maidenhead
    Berkshire
    BritishCompany Director15707550001
    RAKKAR, Paul
    Stuart Road
    SW19 8DJ London
    1
    United Kingdom
    Director
    Stuart Road
    SW19 8DJ London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director146796510001
    SILVER, Adam
    Wicklow Street
    WC1X 9JY London
    77
    England
    Director
    Wicklow Street
    WC1X 9JY London
    77
    England
    United KingdomBritishDirector160628980001
    VAN DER WAL, Aksel
    251 - 255 Tottenham Court Road
    W1T 7AB London
    Universal House
    United Kingdom
    Director
    251 - 255 Tottenham Court Road
    W1T 7AB London
    Universal House
    United Kingdom
    United KingdomDutchCeo172989880001
    WATERLOW, Richard John
    85 Redston Road
    Crouch End
    N8 7HG London
    Director
    85 Redston Road
    Crouch End
    N8 7HG London
    EnglandBritishCompany Director87462480002
    WHITE, Matthew James
    125 Shaftesbury Avenue
    WC2H 8AD London
    4th Floor
    United Kingdom
    Director
    125 Shaftesbury Avenue
    WC2H 8AD London
    4th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant61409620006
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Director designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TIME OUT NOMINEES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Time Out Digital Limited
    Shaftesbury Avenue
    4th Floor
    WC2H 8AD London
    125
    England
    06 abr 2016
    Shaftesbury Avenue
    4th Floor
    WC2H 8AD London
    125
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalEngland And Wales
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro02250222
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene TIME OUT NOMINEES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security accession deed
    Creado el 23 nov 2010
    Entregado el 04 dic 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Oakley Capital Limited as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Note Security Agent")
    Transacciones
    • 04 dic 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 18 ago 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    All assets debenture
    Creado el 23 feb 2006
    Entregado el 01 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 01 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 27 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 26 oct 2005
    Entregado el 27 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 27 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 27 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 26 oct 2005
    Entregado el 27 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 27 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 27 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 30 abr 2002
    Entregado el 20 may 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All estates and interests in any f/h or l/h property now or at any time during the continuance of the security belonging to the company stocks shares and other securities now or at any time during the continuance of this security belonging to the company in any subsidiary or associated companies goodwill debts and all other assets copyright material and rights whatever and wheresoever situate present and future (including its uncalled capital).
    Personas con derecho
    • Anthony Michael Manton Elliott
    Transacciones
    • 20 may 2002Registro de un cargo (395)
    • 27 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creado el 27 feb 2002
    Entregado el 12 mar 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transacciones
    • 12 mar 2002Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 02 ago 1999
    Entregado el 06 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 03 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0