ESI LTD
Visión general
Nombre de la empresa | ESI LTD |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03212832 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ESI LTD?
- Actividades de consultoría ambiental (74901) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ESI LTD?
Dirección de la sede social | Buckingham Court Kingsmead Business Park London Road HP11 1JU High Wycombe Buckinghamshire England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ESI LTD?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
ENVIRONMENTAL SIMULATIONS INTERNATIONAL LIMITED | 28 oct 1999 | 28 oct 1999 |
ENVIRONMENTAL SIMULATIONS LIMITED | 17 jun 1996 | 17 jun 1996 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ESI LTD?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ESI LTD?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 30 sept 2019
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2018 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 jun 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
legacy | 8 páginas | RP04CS01 | ||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 09 ago 2018
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Buckingham Court Frederick Place London Road High Wycombe Bucks HP11 1JU England a Kelsey House Paper Mill Drive Redditch B98 8QJ | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 jun 2018 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
| ||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Aaron & Partners Llp Lakeside House Oxon Business Park Shrewsbury SY3 5HJ England a Buckingham Court Frederick Place London Road High Wycombe Bucks HP11 1JU | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado Buckingham Court Kingsmead Business Park London Road High Wycombe Buckinghamshire HP11 1JU | 1 páginas | AD04 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de New Zealand House 160-162 Abbey Foregate Shrewsbury Shropshire SY2 6FD a Buckingham Court Kingsmead Business Park London Road High Wycombe Buckinghamshire HP11 1JU el 26 mar 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 jun 2018 au 31 dic 2018 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cessation de Mark Fermor en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 mar 2018 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Notification de Stantec Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 mar 2018 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael James Streetly como director el 23 mar 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Adrian Fermor como director el 23 mar 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Derek John Harbour como director el 23 mar 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Francis Crozier como director el 23 mar 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jonathan Peter Cooke como director el 23 mar 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Victoria Jayne Hall-Sturt como secretario el 23 mar 2018 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ESI LTD?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALL-STURT, Victoria Jayne | Secretario | One Papermill Drive B98 8QJ Redditch Kelsey House Worcestershire England | 244567110001 | |||||||
ALPERN, Paul Jeremy David | Director | Edmonton T5K2L6 Alberta 10160 - 112 Street Canada | Canada | Canadian | General Counsel | 244566810001 | ||||
HALL-STURT, Victoria Jayne | Director | One Papermill Drive B98 8QJ Redditch Kelsey House Worcestershire England | England | British | Managing Counsel | 156571450001 | ||||
SCHEFER, Catherine Margaret | Director | Temple Court Birchwood WA3 6GD Warrington Dominion House Chesire England | England | British | Senior Vice President | 237762920002 | ||||
ABEL, Karl Gifford | Secretario | New Zealand House 160-162 Abbey Foregate SY2 6FD Shrewsbury Shropshire | 194404780001 | |||||||
JOHNSON, Sylvia Ann | Secretario | 25 Orsons Meadow Gains Park SY3 5DL Shrewsbury Shropshire | British | 81525160001 | ||||||
LANDON, Adrian John | Secretario | New Zealand House 160-162 Abbey Foregate SY2 6FD Shrewsbury Shropshire | 209667650001 | |||||||
MILLER FERMOR, Karen | Secretario | Acorn Villa Oak Street SY3 7RQ Shrewsbury Shropshire | British | 57826030001 | ||||||
SYKES, Stephen Michael | Secretario | New Zealand House 160-162 Abbey Foregate SY2 6FD Shrewsbury Shropshire | British | Enviromental Business Consultant | 136138150001 | |||||
ALDOUS, Philip John, Dr | Director | New Zealand House 160-162 Abbey Foregate SY2 6FD Shrewsbury Shropshire | England | British | Director | 165326400001 | ||||
COOKE, Jonathan Peter | Director | New Zealand House 160-162 Abbey Foregate SY2 6FD Shrewsbury Shropshire | Wales | British | Environmental Consultant | 176219610001 | ||||
CROZIER, Francis | Director | New Zealand House 160-162 Abbey Foregate SY2 6FD Shrewsbury Shropshire | England | Irish | Director | 220268080001 | ||||
ELLIS, Paul Austin | Director | New Zealand House 160-162 Abbey Foregate SY2 6FD Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | Environmental Consultant | 181281280001 | ||||
FERMOR, Mark Adrian | Director | New Zealand House 160-162 Abbey Foregate SY2 6FD Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | Hydro Geologist | 111888580003 | ||||
FRASER, Hannah | Director | New Zealand House 160-162 Abbey Foregate SY2 6FD Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | Environmental Consultant | 152595030001 | ||||
HARBOUR, Derek John | Director | New Zealand House 160-162 Abbey Foregate SY2 6FD Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | Engineer | 5181680002 | ||||
HARBOUR, Derek John | Director | New Zealand House 160-162 Abbey Foregate SY2 6FD Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | Engineer | 5181680002 | ||||
HERBERT, Alan William, Dr. | Director | Leaton Hall SY4 3AP Leaton Shropshire | England | British | Hydrogeologist | 62404180003 | ||||
LANDON, Adrian John | Director | New Zealand House 160-162 Abbey Foregate SY2 6FD Shrewsbury Shropshire | England | British | Management Accountant | 170118370001 | ||||
MCCAFFREY, Richard George, Mr. | Director | New Zealand House 160-162 Abbey Foregate SY2 6FD Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | Chartered Civil Engineer | 10019740002 | ||||
MILLER FERMOR, Karen | Director | Acorn Villa Oak Street SY3 7RQ Shrewsbury Shropshire | British | Company Director | 57826030001 | |||||
MORGAN, Philip, Prof | Director | 28 Pendle Way SY3 9QH Shrewsbury Shropshire | British | Technical Dir | 91650410001 | |||||
PEARCE, Stuart David | Director | New Zealand House 160-162 Abbey Foregate SY2 6FD Shrewsbury Shropshire | England | British | Director | 134479250001 | ||||
SEARS, Robert Christopher | Director | The Oaks Carrington Close SY3 8DE Shrewsbury Shropshire | British | Hydrogeolgist | 102307480001 | |||||
SMITHSON, Jonathan Tweedy | Director | New Zealand House 160-162 Abbey Foregate SY2 6FD Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | Environmental Consultant | 181661950001 | ||||
STREETLY, Michael James | Director | New Zealand House 160-162 Abbey Foregate SY2 6FD Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | Hydrogeology | 73782560001 | ||||
SYKES, Stephen Michael | Director | Top Road Sharpthorne RH19 4HU East Grinstead The Coach House West Sussex | England | British | Enviromental Business Consultant | 136138150001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ESI LTD?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stantec Uk Limited | 23 mar 2018 | Kingsmead Business Park London Road HP11 1JU High Wycombe Buckingham Court Buckinghamshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Mr Mark Fermor | 30 jun 2016 | New Zealand House 160-162 Abbey Foregate SY2 6FD Shrewsbury Shropshire | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene ESI LTD alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 15 feb 2016 Entregado el 22 feb 2016 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 05 ene 1998 Entregado el 13 ene 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0