ESI LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaESI LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03212832
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ESI LTD?

    • Actividades de consultoría ambiental (74901) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra ESI LTD?

    Dirección de la sede social
    Buckingham Court Kingsmead Business Park
    London Road
    HP11 1JU High Wycombe
    Buckinghamshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ESI LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ENVIRONMENTAL SIMULATIONS INTERNATIONAL LIMITED28 oct 199928 oct 1999
    ENVIRONMENTAL SIMULATIONS LIMITED17 jun 199617 jun 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ESI LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ESI LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 30 sept 2019

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2018

    17 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 17 jun 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    legacy

    8 páginasRP04CS01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 09 ago 2018

    • Capital: GBP 1,125
    3 páginasSH01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Buckingham Court Frederick Place London Road High Wycombe Bucks HP11 1JU England a Kelsey House Paper Mill Drive Redditch B98 8QJ

    1 páginasAD02

    Declaración de confirmación presentada el 17 jun 2018 con actualizaciones

    6 páginasCS01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    09 oct 2018Clarification A second filed CS01 (statement of capital change, trading status, and shareholder information change) was registered on 09/10/18.

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Aaron & Partners Llp Lakeside House Oxon Business Park Shrewsbury SY3 5HJ England a Buckingham Court Frederick Place London Road High Wycombe Bucks HP11 1JU

    1 páginasAD02

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado Buckingham Court Kingsmead Business Park London Road High Wycombe Buckinghamshire HP11 1JU

    1 páginasAD04

    Domicilio social registrado cambiado de New Zealand House 160-162 Abbey Foregate Shrewsbury Shropshire SY2 6FD a Buckingham Court Kingsmead Business Park London Road High Wycombe Buckinghamshire HP11 1JU el 26 mar 2018

    1 páginasAD01

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 jun 2018 au 31 dic 2018

    1 páginasAA01

    Cessation de Mark Fermor en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 mar 2018

    1 páginasPSC07

    Notification de Stantec Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 mar 2018

    2 páginasPSC02

    Cese del nombramiento de Michael James Streetly como director el 23 mar 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark Adrian Fermor como director el 23 mar 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Derek John Harbour como director el 23 mar 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Francis Crozier como director el 23 mar 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jonathan Peter Cooke como director el 23 mar 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Victoria Jayne Hall-Sturt como secretario el 23 mar 2018

    2 páginasAP03

    ¿Quiénes son los directivos de ESI LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HALL-STURT, Victoria Jayne
    One Papermill Drive
    B98 8QJ Redditch
    Kelsey House
    Worcestershire
    England
    Secretario
    One Papermill Drive
    B98 8QJ Redditch
    Kelsey House
    Worcestershire
    England
    244567110001
    ALPERN, Paul Jeremy David
    Edmonton
    T5K2L6 Alberta
    10160 - 112 Street
    Canada
    Director
    Edmonton
    T5K2L6 Alberta
    10160 - 112 Street
    Canada
    CanadaCanadianGeneral Counsel244566810001
    HALL-STURT, Victoria Jayne
    One Papermill Drive
    B98 8QJ Redditch
    Kelsey House
    Worcestershire
    England
    Director
    One Papermill Drive
    B98 8QJ Redditch
    Kelsey House
    Worcestershire
    England
    EnglandBritishManaging Counsel156571450001
    SCHEFER, Catherine Margaret
    Temple Court
    Birchwood
    WA3 6GD Warrington
    Dominion House
    Chesire
    England
    Director
    Temple Court
    Birchwood
    WA3 6GD Warrington
    Dominion House
    Chesire
    England
    EnglandBritishSenior Vice President237762920002
    ABEL, Karl Gifford
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    Secretario
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    194404780001
    JOHNSON, Sylvia Ann
    25 Orsons Meadow
    Gains Park
    SY3 5DL Shrewsbury
    Shropshire
    Secretario
    25 Orsons Meadow
    Gains Park
    SY3 5DL Shrewsbury
    Shropshire
    British81525160001
    LANDON, Adrian John
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    Secretario
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    209667650001
    MILLER FERMOR, Karen
    Acorn Villa Oak Street
    SY3 7RQ Shrewsbury
    Shropshire
    Secretario
    Acorn Villa Oak Street
    SY3 7RQ Shrewsbury
    Shropshire
    British57826030001
    SYKES, Stephen Michael
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    Secretario
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    BritishEnviromental Business Consultant136138150001
    ALDOUS, Philip John, Dr
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritishDirector165326400001
    COOKE, Jonathan Peter
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    WalesBritishEnvironmental Consultant176219610001
    CROZIER, Francis
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandIrishDirector220268080001
    ELLIS, Paul Austin
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritishEnvironmental Consultant181281280001
    FERMOR, Mark Adrian
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritishHydro Geologist111888580003
    FRASER, Hannah
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritishEnvironmental Consultant152595030001
    HARBOUR, Derek John
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritishEngineer5181680002
    HARBOUR, Derek John
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritishEngineer5181680002
    HERBERT, Alan William, Dr.
    Leaton Hall
    SY4 3AP Leaton
    Shropshire
    Director
    Leaton Hall
    SY4 3AP Leaton
    Shropshire
    EnglandBritishHydrogeologist62404180003
    LANDON, Adrian John
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritishManagement Accountant170118370001
    MCCAFFREY, Richard George, Mr.
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritishChartered Civil Engineer10019740002
    MILLER FERMOR, Karen
    Acorn Villa Oak Street
    SY3 7RQ Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    Acorn Villa Oak Street
    SY3 7RQ Shrewsbury
    Shropshire
    BritishCompany Director57826030001
    MORGAN, Philip, Prof
    28 Pendle Way
    SY3 9QH Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    28 Pendle Way
    SY3 9QH Shrewsbury
    Shropshire
    BritishTechnical Dir91650410001
    PEARCE, Stuart David
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritishDirector134479250001
    SEARS, Robert Christopher
    The Oaks
    Carrington Close
    SY3 8DE Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    The Oaks
    Carrington Close
    SY3 8DE Shrewsbury
    Shropshire
    BritishHydrogeolgist102307480001
    SMITHSON, Jonathan Tweedy
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritishEnvironmental Consultant181661950001
    STREETLY, Michael James
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritishHydrogeology73782560001
    SYKES, Stephen Michael
    Top Road
    Sharpthorne
    RH19 4HU East Grinstead
    The Coach House
    West Sussex
    Director
    Top Road
    Sharpthorne
    RH19 4HU East Grinstead
    The Coach House
    West Sussex
    EnglandBritishEnviromental Business Consultant136138150001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ESI LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Stantec Uk Limited
    Kingsmead Business Park
    London Road
    HP11 1JU High Wycombe
    Buckingham Court
    Buckinghamshire
    England
    23 mar 2018
    Kingsmead Business Park
    London Road
    HP11 1JU High Wycombe
    Buckingham Court
    Buckinghamshire
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroRegister Of Companies For England And Wales
    Número de registro01188070
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Mr Mark Fermor
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    30 jun 2016
    New Zealand House
    160-162 Abbey Foregate
    SY2 6FD Shrewsbury
    Shropshire
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 50% pero no más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 50% pero no más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene ESI LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 15 feb 2016
    Entregado el 22 feb 2016
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 22 feb 2016Registro de una carga (MR01)
    • 23 mar 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage debenture
    Creado el 05 ene 1998
    Entregado el 13 ene 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 ene 1998Registro de un cargo (395)
    • 07 sept 2017Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0