OHI BEAUMONT PARK LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaOHI BEAUMONT PARK LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03213741
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de OHI BEAUMONT PARK LTD?

    • Establecimientos residenciales de cuidados de enfermería (87100) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra OHI BEAUMONT PARK LTD?

    Dirección de la sede social
    Tower 42 25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OHI BEAUMONT PARK LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BEAUMONT PARK LIMITED22 may 200222 may 2002
    PINELAKE CARE LIMITED18 jun 199618 jun 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de OHI BEAUMONT PARK LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para OHI BEAUMONT PARK LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Declaración de confirmación presentada el 18 jun 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2016

    21 páginasAA

    legacy

    35 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    2 páginasSH20

    Estado de capital el 27 sept 2017

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduction of share premium account 27/09/2017
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 18 jun 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Notification de Ohi Healthcare Homes (Central) Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    1 páginasPSC02

    Cambio de datos del secretario Daniel J Booth el 01 mar 2017

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Robert Stephenson el 01 mar 2017

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Michael Ritz el 01 mar 2017

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Daniel Booth el 01 mar 2017

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de Citypoint Level 33 1 Ropemaker Street London EC2Y 9UE England a Tower 42 25 Old Broad Street London EC2N 1HQ el 28 abr 2017

    1 páginasAD01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2015

    22 páginasAA

    legacy

    32 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    Segunda presentación de la declaración anual hasta 18 jun 2016

    23 páginasRP04AR01

    Segunda presentación de la declaración anual hasta 18 jun 2015

    23 páginasRP04AR01

    ¿Quiénes son los directivos de OHI BEAUMONT PARK LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BOOTH, Daniel J
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    Secretario
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    197726300001
    BOOTH, Daniel James
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    Director
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    United StatesAmerican265749890001
    RITZ, Michael Daniel
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    Director
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    United StatesAmerican231342520001
    STEPHENSON, Robert
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    Director
    303 International Circle
    Suite 200
    21030 Hunt Valley
    Omega Healthcare Investors, Inc.
    Maryland
    United States
    United StatesAmerican196594350001
    BOCIEK, Martin John
    34 Brockwell
    MK43 7TD Oakley
    Bedfordshire
    Secretario
    34 Brockwell
    MK43 7TD Oakley
    Bedfordshire
    British82185990001
    BOGGON, Deirdre Irene
    Elmbank 36 London Road
    St Ippolyts
    SG4 7NG Hitchin
    Hertfordshire
    Secretario
    Elmbank 36 London Road
    St Ippolyts
    SG4 7NG Hitchin
    Hertfordshire
    British51553190001
    CLOUGH, Richard Stanley
    Hanini 50 Second Avenue
    CO13 9LX Frinton On Sea
    Essex
    Secretario
    Hanini 50 Second Avenue
    CO13 9LX Frinton On Sea
    Essex
    British7897560001
    LOMER, Graham Charles
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Secretario
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    British96916290001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secretario designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BATES, David John
    The Crescent
    CO13 9AP Frinton-On-Sea
    4
    Essex
    United Kingdom
    Director
    The Crescent
    CO13 9AP Frinton-On-Sea
    4
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish96384800003
    BOCIEK, Martin John
    34 Brockwell
    MK43 7TD Oakley
    Bedfordshire
    Director
    34 Brockwell
    MK43 7TD Oakley
    Bedfordshire
    EnglandBritish82185990001
    CHRISTIAN, Deborah Helen
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Director
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    EnglandBritish187897170001
    CLOUGH, Richard Stanley
    Lodge House
    Lodge Lane Langham
    CO4 5NE Colchester
    Essex
    Director
    Lodge House
    Lodge Lane Langham
    CO4 5NE Colchester
    Essex
    EnglandBritish7897560002
    LOMER, Graham Charles
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    Director
    Aldersgate Street
    EC1A 4HY London
    140
    England
    United KingdomBritish147828420021
    ROGERS, Pamela Anne
    Linden House 40 High Street
    Roxton
    MK44 3EB Bedford
    Director
    Linden House 40 High Street
    Roxton
    MK44 3EB Bedford
    British63140670001
    STOTT, Yvette Ann
    36 The Paddocks
    Potton
    SG19 2QD Sandy
    Bedfordshire
    Director
    36 The Paddocks
    Potton
    SG19 2QD Sandy
    Bedfordshire
    British56606030001
    WARD, Gordon Robert
    Rua Do Pombo Corriero
    Vilamoura, 8125, Quarteira
    Algarve
    Portugal
    Director
    Rua Do Pombo Corriero
    Vilamoura, 8125, Quarteira
    Algarve
    Portugal
    British48287480003
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Director designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de OHI BEAUMONT PARK LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Ohi Healthcare Homes (Central) Ltd
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    England
    06 abr 2016
    25 Old Broad Street
    EC2N 1HQ London
    Tower 42
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalEngland
    Lugar de registroEngland
    Número de registro03995046
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene OHI BEAUMONT PARK LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal mortgage
    Creado el 04 abr 2008
    Entregado el 10 abr 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Mill lane nursing home felixstowe suffolk SK275266; the gables nursing home marine parade great yarmouth norfolk NK338434; fornham house fornham st martin bury st edmunds suffolk SK145383 (for further details of properties charged please refer to form 395) and/or its proceeds of sale. Floating charge its undertaking and all its other property assets and rights whatsoever and wheresoever see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Trustee)
    Transacciones
    • 10 abr 2008Registro de un cargo (395)
    • 22 may 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creado el 04 abr 2008
    Entregado el 08 abr 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and trustee for the finance parties) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Mill lane nursing home felixstowe suffolk t/no SK275266 the gables nursing home marine parade great yarmouth norfolk t/no NK338434 fornham house fornham st martin bury st edmunds suffolk t/no SK145383 for details of further properties charged please refer to form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Trustee
    Transacciones
    • 08 abr 2008Registro de un cargo (395)
    • 22 may 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 04 ago 2005
    Entregado el 11 ago 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 ago 2005Registro de un cargo (395)
    • 18 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 01 feb 2002
    Entregado el 12 feb 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 feb 2002Registro de un cargo (395)
    • 23 feb 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 feb 2002
    Entregado el 12 feb 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage over all that freehold property known as west of shortmead street biggleswade and freehold property on the west side of shortmead street biggleswade. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 feb 2002Registro de un cargo (395)
    • 23 feb 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 26 sept 2000
    Entregado el 30 sept 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The land and buildings on the west side of shortmead st biggleswade known as beaumont park shortmead st biggleswade t/no BD123120 BD127708. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 30 sept 2000Registro de un cargo (395)
    • 05 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge over chattels
    Creado el 26 sept 2000
    Entregado el 30 sept 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    With full title guarantee by way of first fixed charge: 1)the fixed assets together with any and all assets subsequently acquired by the company by way of replacement thereof 2)items of real or personal property tangible or intangible . fixed assets: 37 beds 37 wardrobes 37 chairs. For details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 30 sept 2000Registro de un cargo (395)
    • 05 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 21 ago 1996
    Entregado el 31 ago 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The property k/a land and premises at shotmead street, biggleswade bedford t/n's BD123120 and BD127708 assigns the goodwill of the business and the benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 31 ago 1996Registro de un cargo (395)
    • 21 oct 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 ago 1996
    Entregado el 31 ago 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 31 ago 1996Registro de un cargo (395)
    • 17 may 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0