BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED

BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03214421
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o BRUNTWOOD LIMITED
    York House
    York Street
    M2 3BB Manchester
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BRUNTWOOD SECOND PROPERTIES LIMITED12 ago 199612 ago 1996
    BRUNTWOOD SECOND ESTATES LIMITED19 jul 199619 jul 1996
    SLATERSHELFCO 318 LIMITED20 jun 199620 jun 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Bruntwood Limited City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT a C/O Bruntwood Limited York House York Street Manchester M2 3BB el 07 jun 2016

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 abr 2016

    Estado de capital el 12 abr 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 sept 2014

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 abr 2015

    Estado de capital el 09 abr 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 sept 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 abr 2014

    Estado de capital el 08 abr 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Kevin James Crotty el 28 jun 2013

    2 páginasCH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 sept 2012

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Kevin James Crotty como director

    2 páginasAP01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 sept 2011

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Andrew Allan como director

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de * City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT United Kingdom* el 05 ene 2012

    1 páginasAD01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 sept 2010

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Robert Yates como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Marland como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard Malin como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Iain Grant como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Peter Crowther como director

    1 páginasTM01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 sept 2009

    5 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VOKES, Katharine Jane
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Secretario
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    BritishCompany Director96739300002
    CROTTY, Kevin James
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Director
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    EnglandBritishChartered Accountant117797270004
    OGLESBY, Christopher George
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Director
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritishCompany Director53530470002
    OGLESBY, Michael John
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    Director
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritishDirector148307320001
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    Secretario
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    BritishAccountant2582690002
    ORRELL, Jeremy Peter
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    Secretario designado
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    British900005190001
    ALLAN, Andrew John
    c/o Bruntwood Limited
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Director
    c/o Bruntwood Limited
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant80043450001
    CROWTHER, Peter Andrew
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Director
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishSurveyor102710080002
    GRANT, Iain James
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Director
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor45918940003
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    Director
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    United KingdomBritishAccountant2582690002
    GUEST, David Robert James
    21 Beech Road
    Chorlton
    M21 8BX Manchester
    Lancashire
    Director
    21 Beech Road
    Chorlton
    M21 8BX Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritishSurveyor102710440001
    HEWITT, Michael
    11 Marryat Close
    Winwick Park
    WA2 8XS Warrington
    Cheshire
    Director
    11 Marryat Close
    Winwick Park
    WA2 8XS Warrington
    Cheshire
    EnglandBritishDirector108552010001
    MALIN, Richard William
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Director
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishBanker48153170001
    MARLAND, John Roderick
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Director
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritishSurveyor102712120001
    MORRIS, Antony Howard
    17 St Margarets Close
    Prestwich
    M25 2LY Manchester
    Director
    17 St Margarets Close
    Prestwich
    M25 2LY Manchester
    BritishSolicitor48178610001
    OGLESBY, Jean Davies
    Moss Farm Southdowns Road
    Bowdon
    WA14 3DR Altrincham
    Cheshire
    Director
    Moss Farm Southdowns Road
    Bowdon
    WA14 3DR Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishDirector29553390001
    ORRELL, Jeremy Peter
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    Director designado
    2 Greylands Close
    M33 6GS Sale
    Cheshire
    British900005190001
    ROBERTS, Christopher Andrew
    Swann Lane
    Cheadle Hulme
    SK8 7HU Cheadle
    70a
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Swann Lane
    Cheadle Hulme
    SK8 7HU Cheadle
    70a
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSurveyor139641910001
    YATES, Robert David
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    Director
    Piccadilly Plaza
    M1 4BT Manchester
    City Tower
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor30535590006

    ¿Tiene BRUNTWOOD (OVERSEAS HOUSE) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    B2000 borrower security agreement
    Creado el 06 feb 2007
    Entregado el 20 feb 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Borrower Security Trustee) (Whether from Its Own Account Oras Trustee for the Borrower Secured Creditors)
    Transacciones
    • 20 feb 2007Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 23 jun 2004
    Entregado el 01 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the banks on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a overseas house, quay street t/no LA355462 together with all buildings, fixtures and fittings and fixed plant and machinery thereon, all plant, machinery, implements, utensils, building materials, carpets, furniture andequipment now or in the future placed on or used in or about the mortgaged prope. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Agent and Trustee for the Banks)
    Transacciones
    • 01 jul 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 18 dic 2003
    Entregado el 03 ene 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the banks and each of them on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage the freehold property known as overseas house quay street t/n LA355462 by way of fixed charge all plant machinery implements building materials all of the companys rights and benefits under any agreements and the benefit of each and all of the personal covenants by the lesses underlesses or licensees under the occupational leases. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 03 ene 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 14 nov 2000
    Entregado el 24 nov 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land adjoining marsland house,marsland rd,sale,gt.manchester.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 24 nov 2000Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 jun 1999
    Entregado el 30 jun 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage f/h land and buildings k/a lancastrian office buildings talbot road stretford greater manchester t/n-LA234523.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 30 jun 1999Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 ago 1998
    Entregado el 27 ago 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H land and and buildings k/a bank house faulkner street manchester t/no.LA360892. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 27 ago 1998Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 ago 1998
    Entregado el 27 ago 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the l/h land and buildings k/a bank chambers adjoining bank house faulkner street manchester being the whole of the land under t/nos.GM789357 and GM789673. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 27 ago 1998Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 05 jun 1998
    Entregado el 15 jun 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land and buildings k/a marsland house marsland road sale t/nos.GM53071 and GM323015 and goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 15 jun 1998Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 dic 1996
    Entregado el 03 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a quay house 28 quay street manchester t/n GM66438 the goodwill of the business and the proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 03 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 07 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 13 nov 1996
    Entregado el 19 nov 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 19 nov 1996Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0