PHIP CH LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPHIP CH LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03217536
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PHIP CH LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra PHIP CH LIMITED?

    Dirección de la sede social
    5th Floor Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PHIP CH LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CATHEDRAL HEALTHCARE LIMITED11 may 200411 may 2004
    MOUNT ANVIL HEALTHCARE LIMITED12 may 199912 may 1999
    PRIMARY PARTNERSHIPS LIMITED01 may 199801 may 1998
    ANVIL LONDON LIMITED27 jun 199627 jun 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PHIP CH LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PHIP CH LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 10 jul 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 8

    4 páginasMR04

    Nombramiento de Mr David Christopher Austin como director el 01 abr 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Timothy David Walker Arnott como director el 01 abr 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Richard Howell como director el 01 abr 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Philip John Holland como director el 01 abr 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 10 jul 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Philip John Holland el 08 jul 2016

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 10 jul 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 jul 2015

    Estado de capital el 10 jul 2015

    • Capital: GBP 1,333
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    13 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 02 jul 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital30 jul 2014

    Estado de capital el 30 jul 2014

    • Capital: GBP 1,333
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Timothy David Walker Arnott el 01 may 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Timothy David Walker Arnott el 22 jul 2014

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Nexus Management Services Limited como secretario

    3 páginasAP04

    Domicilio social registrado cambiado de * Ryder Court, Ground Floor 14 Ryder Street London SW1Y 6QB* el 07 may 2014

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Margaret Vaughan como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de J O Hambro Capital Management Limited como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 25 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 jul 2013

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 22 jul 2013

    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    5 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de PHIP CH LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    NEXUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Secretario corporativo
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro4187765
    57253330002
    AUSTIN, David Christopher
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Director
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    United KingdomBritish131339590001
    HOWELL, Richard
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Director
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    EnglandBritish164790590001
    HYMAN, Harry Abraham
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    Director
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    EnglandBritish35560380005
    DEAMER, Kenneth
    Lucky Stones Rowhill Road
    DA2 7QQ Wilmington
    Kent
    Secretario
    Lucky Stones Rowhill Road
    DA2 7QQ Wilmington
    Kent
    British8521670002
    HURLEY, Cornelius Killian
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Secretario
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Irish47179960002
    SCOTT, Christopher Richard
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    Secretario
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    British81998190003
    STEVENS, Philip Martin
    Forge House Maiden Street
    Weston
    SG4 7AA Hitchin
    Hertfordshire
    Secretario
    Forge House Maiden Street
    Weston
    SG4 7AA Hitchin
    Hertfordshire
    British102528350001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secretario designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor, Ryder Court
    England
    Secretario corporativo
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor, Ryder Court
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2176004
    117915530003
    BENNETT, Barry John
    Meadowdown
    Doggetts Wood Close
    HP8 4TL Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Director
    Meadowdown
    Doggetts Wood Close
    HP8 4TL Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomIrish14707370002
    BORER, Derek
    133 Ridge Lane
    WD17 4SX Watford
    Hertfordshire
    Director
    133 Ridge Lane
    WD17 4SX Watford
    Hertfordshire
    British60451400001
    HAMBRO, James Daryl
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Director
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    United KingdomBritish53684400001
    HOLLAND, Philip John
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    Director
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    EnglandBritish163838050001
    HURLEY, Cornelius Killian
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Director
    28 Millenium Wharf
    WD3 1AZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomIrish47179960002
    ISAACS, Paul Samuel
    Rosemead
    Woodhill Road
    CM3 4DY Danbury
    Essex
    Director
    Rosemead
    Woodhill Road
    CM3 4DY Danbury
    Essex
    EnglandBritish141827450001
    NEWMAN, Victor Edward
    70 Oakfield Road
    Southgate
    N14 6LX London
    Director
    70 Oakfield Road
    Southgate
    N14 6LX London
    British23635170001
    SCOTT, Christopher Richard
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    Director
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish81998190003
    UPTON, Richard
    Old Bearhurst
    Battenhurst Road
    TN5 7DU Stonegate
    East Sussex
    Director
    Old Bearhurst
    Battenhurst Road
    TN5 7DU Stonegate
    East Sussex
    EnglandBritish204950320001
    VAUGHAN, Margaret Helen
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Director
    Ryder Court, Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    United KingdomBritish123167120001
    WALKER ARNOTT, Timothy David
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    Director
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    United KingdomBritish61889360004
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Director designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Director designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PHIP CH LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Primary Health Properties Plc
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor Greener House
    England
    01 jun 2016
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor Greener House
    England
    No
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro3033634
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene PHIP CH LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 02 abr 2012
    Entregado el 04 abr 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 04 abr 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 13 abr 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 17 mar 2008
    Entregado el 28 mar 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    (For details of properties charged please refer to form 395) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transacciones
    • 28 mar 2008Registro de un cargo (395)
    • 02 abr 2008
    • 16 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed and floating security agreement
    Creado el 01 jun 2007
    Entregado el 14 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transacciones
    • 14 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 16 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 01 jun 2007
    Entregado el 14 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    For details of property charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 16 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 13 jun 2006
    Entregado el 15 jun 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that f/h property k/a 250-262 high street sheerness kent. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 15 jun 2006Registro de un cargo (395)
    • 10 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 ene 2006
    Entregado el 17 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 10 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 09 ene 2006
    Entregado el 11 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land forming part of the old A23 road west of high street handcross. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 10 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 26 nov 2004
    Entregado el 02 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 10 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0