MICROPONENTS (PLATES) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MICROPONENTS (PLATES) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03218207 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 11 Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ODDJOB QUEENSVILLE 1 LIMITED | 28 jun 1996 | 28 jun 1996 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado de capital el 10 sept 2018
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ago 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 12 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Taylor como director el 21 abr 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ian Robert, Mark Mcmurray como director el 21 abr 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Marina Louise Thomas como director el 21 abr 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Keith Pargeter como director el 21 abr 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Derek John O'neill como director el 21 abr 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Robert Grant como secretario el 21 abr 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Atlantic House Aviation Park West, Bournemouth International Airport Christchurch Dorset BH23 6EW a 11 Vantage Way Erdington Birmingham B24 9GZ el 23 abr 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ago 2017 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Robert Grant como secretario el 28 oct 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Marina Thomas como secretario el 28 oct 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 ago 2016 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Detalles de la variación de los derechos vinculados a las acciones | 3 páginas | SH10 | ||||||||||
Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones | 2 páginas | SH08 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCMURRAY, Ian Robert, Mark | Director | Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham 11 England | England | British | 153191380001 | |||||
| TAYLOR, Michael | Director | Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham 11 England | England | British | 245595040001 | |||||
| CLOWES, Stephen | Secretario | 24 Willesley Gardens LE65 2QF Ashby De La Zouch Leicestershire | British | 1764410001 | ||||||
| GRANT, Simon Robert | Secretario | Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham 11 England | 217318510001 | |||||||
| HINCHLEY, Karen Jane | Secretario | 66 Stone Road ST16 2RS Stafford | British | 50580120001 | ||||||
| KERIN, John Brendan | Secretario | Precision Micro, Vantage Way Erdington B24 9GX Birmingham 11 Uk | British | 56704130004 | ||||||
| THOMAS, Marina | Secretario | Aviation Park West Bournemouth International Airport BH23 6EW Christchurch Atlantic House Dorset England | British | 170765880001 | ||||||
| CLOWES, Stephen | Director | 24 Willesley Gardens LE65 2QF Ashby De La Zouch Leicestershire | England | British | 1764410001 | |||||
| GOLESTANI, Kian | Director | 2 Hawkesmoor Drive WS14 9YH Lichfield Staffordshire | British | 46764350001 | ||||||
| GREEN, Philip Ernest | Director | Aviation Park West Bournemouth International Airport BH23 6EW Christchurch Atlantic House Dorset England | England | British | 5495960002 | |||||
| HUTCHISON MOSS, James | Director | 455 Lichfield Road B74 4DJ Four Oaks Sutton Coldfield | British | 86536870001 | ||||||
| KERIN, John Brendan | Director | Precision Micro, Vantage Way Erdington B24 9GX Birmingham 11 Uk | England | British | 56704130004 | |||||
| MARRETT, Anthony Rex | Director | Precision Micro, Vantage Way Erdington B24 9GX Birmingham 11 Uk | England | British | 68981240003 | |||||
| MARRETT, Nicola Kathryn | Director | 17 Bishops Road B73 6HX Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | 86353140001 | |||||
| MARRETT, Norman Rex | Director | Joberns Cottage Little Hay Lane WS14 0QD Lichfield Staffordshire | British | 1764420002 | ||||||
| MARRETT, Zoe Louise | Director | 8 Woodside Road HP9 1JG Beaconsfield Buckinghamshire | British | 86353350001 | ||||||
| O'NEILL, Derek John | Director | Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham 11 England | United Kingdom | British | 87573010001 | |||||
| PARGETER, Ian Keith | Director | Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham 11 England | England | British | 123123230001 | |||||
| THOMAS, Marina Louise | Director | Vantage Way Erdington B24 9GZ Birmingham 11 England | England | British | 183635400001 | |||||
| TWIGGER, Terence | Director | Aviation Park West Bournemouth International Airport BH23 6EW Christchurch Atlantic House Dorset England | England | British | 45754710002 | |||||
| YOUNG, Mark Lees | Director | Aviation Park West Bournemouth International Airport BH23 6EW Christchurch Atlantic House Dorset England | England | British | 85330350002 | |||||
| YOUNG, Stephen Gareth | Director | Aviation Park West Bournemouth International Airport BH23 6EW Christchurch Atlantic House Dorset England | United Kingdom | British | 21273730002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MICROPONENTS (PLATES) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotomechanix Limited | 06 abr 2016 | Aviation Park West Bournemouth International Airport BH23 6EW Christchurch Atlantic House Dorset England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene MICROPONENTS (PLATES) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Creado el 01 nov 2003 Entregado el 05 nov 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| All assets debenture deed | Creado el 10 dic 2002 Entregado el 18 dic 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 05 ago 1998 Entregado el 11 ago 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed charge | Creado el 10 oct 1997 Entregado el 16 oct 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 1 x new atotech pre clean machine ref. 8609-005 serial no. 070-5462. 1 x new atotech developer ref. 8609-002, serial no. 070-5459. 1 x new atotech stripper ref. 8609-004, serial no. 070-5461.. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0