BMG (MANSFIELD) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BMG (MANSFIELD) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03224318 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BMG (MANSFIELD) LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra BMG (MANSFIELD) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 30 Finsbury Square EC2P 2YU London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BMG (MANSFIELD) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BAA-MCARTHUR/GLEN (MANSFIELD) LIMITED | 03 dic 1996 | 03 dic 1996 |
| SHELFCO (NO. 1205) LIMITED | 12 jul 1996 | 12 jul 1996 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BMG (MANSFIELD) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BMG (MANSFIELD) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 8 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU el 03 may 2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Poultry London EC2R 8EJ a No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP el 06 ene 2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 2 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Rowan Tracy Hostler como director el 09 dic 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Anthony Diemer como director el 09 dic 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Barry Steven Hill como director el 09 dic 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Rowley Rose como director el 09 dic 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 jul 2016 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2015 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 jul 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Barry Steven Hill como director el 20 jul 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Justin Mark Brand como director el 10 jul 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Bryan Womack como director el 30 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Anthony Diemer como director el 18 jun 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2014 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 jul 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 14 Cornhill London EC3V 3ND England a St Helen's 1 Undershaft London EC3P 3DQ | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2013 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Jones como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 jul 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado | 1 páginas | AD04 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BMG (MANSFIELD) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom |
| 1278390004 | ||||||||||
| HOSTLER, Rowan Tracy | Director | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom | United Kingdom | British | 201266610001 | |||||||||
| ROSE, David Rowley | Director | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom | United Kingdom | British | 89567200001 | |||||||||
| LEWIS, Maria Bernadette | Secretario | 1 Scriveners Close Hillfield Road HP2 4XP Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 54836960001 | ||||||||||
| WILLIAMS HAMER, Gabrielle Mary | Secretario | 25 Elspeth Road Battersea SW11 1DW London | British | 45555320001 | ||||||||||
| EPS SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | 67339580001 | |||||||||||
| BECKETT, Barbara Ann | Director | 3 Lees Cottages Pyrford Road GU22 8UF Woking Surrey | England | British | 36403110001 | |||||||||
| BENNETT, George Morgan | Director | Flat 22 35 Grosvenor Square W1 London | United States | 50870930001 | ||||||||||
| BRAND, Justin Mark | Director | Poultry EC2R 8EJ London 1 Uk | England | English | 254970510001 | |||||||||
| CALABRESE, Julia Jean | Director | 14 Hans Crescent SW1X 0LJ London | United Kingdom | American | 63214460001 | |||||||||
| COPPOCK, Lawrence Patrick | Director | The Close Church Lane SO51 0QH Braishfield Hampshire | England | United Kingdom | 152718990001 | |||||||||
| DIEMER, David Anthony | Director | Poultry EC2R 8EJ London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 79053460001 | |||||||||
| EDINGTON, George Gordon | Director | 7 St Simons Avenue Putney SW15 6DU London | United Kingdom | British | 1386790001 | |||||||||
| GIBSON, John Michael Barry | Director | 51 Lower Belgrave Street SW1W 0LP London | British | 82660110001 | ||||||||||
| GOTTLIEB, Julius | Director | 8 Southway Totteridge N20 8EA London | England | British | 32807790002 | |||||||||
| HILL, Barry Steven | Director | Poultry EC2R 8EJ London 1 | United Kingdom | British | 165034590001 | |||||||||
| JONES, Peter Joseph | Director | 8 Montpelier Villas BN1 3DH Brighton East Sussex | British | 49764720002 | ||||||||||
| JONES, Richard Peter | Director | Poultry EC2R 8EJ London 1 Uk | England | British | 76584200002 | |||||||||
| KAEMPFER, Joseph Wallach | Director | 15 Blomfield Road W9 1AD London | United Kingdom | American | 48577420002 | |||||||||
| LAXTON, Chris James Wentworth | Director | Poultry EC2R 8EJ London 1 Uk | United Kingdom | British | 198871760001 | |||||||||
| LIGHTFOOT, William Vincent | Director | Tipnoaks London Road BN6 9BJ Albourne West Sussex | British | 78739030001 | ||||||||||
| MANSLEY, Nicholas John Fermor | Director | 4 Willis Road CB1 2AQ Cambridge | England | British | 73817060002 | |||||||||
| MURPHY, James Byrne | Director | 14 Kensington Gate W8 5NA London | American | 50871010002 | ||||||||||
| NASH, Peter Baird | Director | 91 Clifton Hill NW8 0JW London | American | 60917560001 | ||||||||||
| NICOLOSI, John | Director | 2 Cambridge Terrace Regents Park NW1 4JL London | American | 67480450001 | ||||||||||
| RICKETTS, Brian Hugh | Director | The Tudors Nyetimber Copse RH20 2NE West Chiltington West Sussex | British | 7340390001 | ||||||||||
| SAYERS, David | Director | 32 The Chase RH2 7DH Reigate Surrey | British | 65829520001 | ||||||||||
| SOLLER, Brad | Director | 53 Windermere Avenue Finchley N3 3RD London | British | 67373440001 | ||||||||||
| WADDELL, Ronald Winsor | Director | 4 The Cloisters Forelands Way HP5 1QR Chesham Buckinghamshire | British | 34743860003 | ||||||||||
| WALLS, John Russell Fotheringham | Director | 40 Ibis Lane Grove Park Chiswick W4 3UP London | United Kingdom | British | 43558350002 | |||||||||
| WISE, David Andrew | Director | 5 Orchid Grange Orchid Road Southgate N14 5HH London | British | 74016310002 | ||||||||||
| WOMACK, Ian Bryan | Director | Poultry EC2R 8EJ London 1 Uk | England | British | 33902000006 | |||||||||
| WRIGHT, Adrian James | Director | North Field House 9a Coniston Road CB1 4BZ Cambridge | British | 40406910001 | ||||||||||
| MIKJON LIMITED | Director corporativo | 50 Stratton Street W1X 5FL London | 44503290001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BMG (MANSFIELD) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Designer Retail Outlet Centres (General Partner) Limited | 06 abr 2016 | Poultry EC2R 8EJ London No. 1 England England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene BMG (MANSFIELD) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Original debenture amendment and accession deed (for amending the debenture and security trust deed dated 23 june 1997) | Creado el 16 abr 1999 Entregado el 30 abr 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the beneficiaries (as defined) or any of them on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 23 jun 1997 Entregado el 02 jul 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee and the beneficiaries or any one of them pursuant to the bmg (mh) facility letter, the v&p facility letter or this debenture and on any account whatsoever | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge | Creado el 04 mar 1997 Entregado el 06 mar 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada In favour of the chargee the property price as defined in an agreement dated 4TH march 1997 or such part as shall be outstanding from time to time and any interest thereon or in respect thereof | |
Breve descripción By way of first legal mortgage of land on the south east side of mansfield road south normanton bolsover derbyshire t/no.DY206374. By way of floating charge the company's undertaking and all its assets both present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene BMG (MANSFIELD) LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0