VICKERS ELECTRONICS LIMITED

VICKERS ELECTRONICS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaVICKERS ELECTRONICS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03227029
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de VICKERS ELECTRONICS LIMITED?

    • fabricación de otros equipos eléctricos (27900) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra VICKERS ELECTRONICS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VICKERS ELECTRONICS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HELPDEAN LIMITED19 jul 199619 jul 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de VICKERS ELECTRONICS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 jul 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para VICKERS ELECTRONICS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Aviso de cambio de la administración a la disolución

    38 páginasAM23

    Cese del nombramiento de Stephen Martin Blank como director el 17 ene 2018

    1 páginasTM01

    Informe de progreso del administrador

    44 páginasAM10

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    3 páginasAM06

    Declaración de asuntos con el formulario AM02SOA

    16 páginasAM02

    Declaración de la propuesta del administrador

    108 páginasAM03

    Domicilio social registrado cambiado de Unit 14 Westpoint Enterprise Park Clarence Avenue Trafford Park Manchester M17 1QS a C/O Duff & Phelps Ttd the Chancery 58 Spring Gardens Manchester M2 1EW el 06 jun 2017

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    3 páginasAM01

    Cancelación total de la carga 12

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 19 jul 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Registro de la carga 032270290014, creada el 08 jun 2016

    34 páginasMR01

    Cese del nombramiento de David James Hilton como director el 13 may 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Alison Jacqueline Hilton como director el 13 may 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2015

    20 páginasAA

    Registro de la carga 032270290013, creada el 29 feb 2016

    38 páginasMR01

    Nombramiento de Mr Raymond David Breckon como director el 28 jul 2015

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 19 jul 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 jul 2015

    Estado de capital el 29 jul 2015

    • Capital: GBP 177
    SH01

    Nombramiento de Mr Peter Andrew Turnbull como secretario el 28 jul 2015

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de David James Hilton como secretario el 28 jul 2015

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Nicholas Richard Duncan Owen como director el 05 jun 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2014

    17 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 19 jul 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 jul 2014

    Estado de capital el 23 jul 2014

    • Capital: GBP 177
    SH01

    Cambio de datos del director David James Hilton el 19 jul 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Alison Jacqueline Hilton el 19 jul 2014

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de VICKERS ELECTRONICS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TURNBULL, Peter Andrew
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    Secretario
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    199769460001
    BRECKON, Raymond David
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    Director
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    EnglandBritishCompany Director70834670002
    THOMAS, Wayne
    Park Clarence Avenue
    Trafford Park
    M17 1QS Manchester
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    United Kingdom
    Director
    Park Clarence Avenue
    Trafford Park
    M17 1QS Manchester
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector161712760001
    BARLOW, Ian
    11 Durnford Close
    Norden
    OL12 7RX Rochdale
    Greater Manchester
    Secretario
    11 Durnford Close
    Norden
    OL12 7RX Rochdale
    Greater Manchester
    BritishDirector74332640001
    HILTON, David James
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    Secretario
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    BritishCompany Director107482670001
    LEUTTON, John Frederick
    5 The Retreat
    Romiley
    SK6 3LF Stockport
    Cheshire
    Secretario
    5 The Retreat
    Romiley
    SK6 3LF Stockport
    Cheshire
    BritishDirector9181840002
    WYSE, Ewan Gordon
    6 Ruins Lane
    Harwood
    BL2 3JG Bolton
    Secretario
    6 Ruins Lane
    Harwood
    BL2 3JG Bolton
    British84738140001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secretario designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BARLOW, Ian
    11 Durnford Close
    Norden
    OL12 7RX Rochdale
    Greater Manchester
    Director
    11 Durnford Close
    Norden
    OL12 7RX Rochdale
    Greater Manchester
    BritishDirector74332640001
    BERRY, Keith
    40 Wood Hey Grove
    Skye
    OL12 9UA Rochdale
    Lancashire
    Director
    40 Wood Hey Grove
    Skye
    OL12 9UA Rochdale
    Lancashire
    EnglandBritishDirector60151490001
    BLANK, Stephen Martin
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    Director
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    C/O Duff & Phelps Ttd The Chancery 58
    United KingdomBritishDirector5733490001
    CAMERON, Ian Thomas
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    Director
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    United KingdomBritishDirector156147320001
    HILTON, Alison Jacqueline
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    Director
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    United KingdomBritishSales Manager117736760003
    HILTON, David James
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    Director
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    EnglandBritishCompany Director107482670005
    HILTON-TAPP, David
    9 Bayliss Close
    N21 1SP London
    Director
    9 Bayliss Close
    N21 1SP London
    BritishDirector67068110003
    HOYLE, John Roger Horrocks
    The Riggs
    Victoria Road Heaton
    BL1 5AN Bolton
    Director
    The Riggs
    Victoria Road Heaton
    BL1 5AN Bolton
    EnglandBritishCompany Director3986300001
    LEUTTON, John Frederick
    5 The Retreat
    Romiley
    SK6 3LF Stockport
    Cheshire
    Director
    5 The Retreat
    Romiley
    SK6 3LF Stockport
    Cheshire
    BritishDirector9181840002
    OWEN, Nicholas Richard Duncan
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    Director
    Unit 14 Westpoint Enterprise
    Park Clarence Avenue
    M17 1QS Trafford Park Manchester
    United KingdomBritishDirector1800950002
    THACKRAY, Adam Matthew
    Orchard Drive
    WA15 8BB Hale
    13
    Cheshire
    Director
    Orchard Drive
    WA15 8BB Hale
    13
    Cheshire
    United KingdomBritishOperations Manager117737630002
    THACKRAY, Simon
    St Johns Avenue
    WA16 1DH Knutsford
    1
    Cheshire
    Uk
    Director
    St Johns Avenue
    WA16 1DH Knutsford
    1
    Cheshire
    Uk
    EnglandBritishDirector67197060005
    WYSE, Ewan Gordon
    6 Ruins Lane
    Harwood
    BL2 3JG Bolton
    Director
    6 Ruins Lane
    Harwood
    BL2 3JG Bolton
    EnglandBritishAccountant84738140001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Director designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de VICKERS ELECTRONICS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Business Engagement Limited
    Westpoint Enterprise Park, Clarence Avenue
    Trafford Park
    M17 1QS Manchester
    Unit 14
    England
    06 abr 2016
    Westpoint Enterprise Park, Clarence Avenue
    Trafford Park
    M17 1QS Manchester
    Unit 14
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro05488174
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene VICKERS ELECTRONICS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 08 jun 2016
    Entregado el 22 jun 2016
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Enterprise Ventures Growth Fund LP
    Transacciones
    • 22 jun 2016Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 29 feb 2016
    Entregado el 02 mar 2016
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Evbl(General Partner Ev Sme Loans) Limited
    Transacciones
    • 02 mar 2016Registro de una carga (MR01)
    Debenture
    Creado el 13 jul 2011
    Entregado el 21 jul 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transacciones
    • 21 jul 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 07 abr 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creado el 13 jul 2011
    Entregado el 19 jul 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Enterprise Ventures Growth Fund LP (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 19 jul 2011Registro de un cargo (MG01)
    Assignment of life policy
    Creado el 12 ene 2007
    Entregado el 17 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The policy in respect of alison bagnall, policy no: L0195619092DQ with aegon scottish equitable in the sum of £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 ene 2007Registro de un cargo (395)
    • 19 abr 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Assignment of life policy
    Creado el 12 ene 2007
    Entregado el 17 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The policy in respect of david hilton, policy no: L0198455092DX with aegon scottish equitable in the sum of £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 ene 2007Registro de un cargo (395)
    • 19 abr 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Assignment of life policy
    Creado el 12 ene 2007
    Entregado el 17 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The policy in respect of simon thackray, policy no: 223890 with lutine assurance services limited in the sum of £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 ene 2007Registro de un cargo (395)
    • 19 abr 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 12 ene 2007
    Entregado el 17 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 ene 2007Registro de un cargo (395)
    • 16 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of assignment of keyman life policy
    Creado el 09 ago 2005
    Entregado el 19 ago 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Legal and general policy number 011443517-5 dated 4 july 2005 for the sum of £100,000 life assured david hilton together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 ago 2005Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of assignment of keyman life policy
    Creado el 09 ago 2005
    Entregado el 19 ago 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Lutine assurance services limited policy number 219871 dated 29 june 2005 for the sum of £200,000 life assured simon thackray together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 ago 2005Registro de un cargo (395)
    • 19 abr 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of assignment of keyman life policy
    Creado el 09 ago 2005
    Entregado el 19 ago 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Its title right and interest in the policy. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 ago 2005Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 09 ago 2005
    Entregado el 19 ago 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 ago 2005Registro de un cargo (395)
    • 19 abr 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 01 nov 1999
    Entregado el 04 nov 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 nov 1999Registro de un cargo (395)
    • 18 ago 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 nov 1996
    Entregado el 06 nov 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the finance documents (as defined) and/or on any other account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Mr David Russell
    Transacciones
    • 06 nov 1996Registro de un cargo (395)
    • 18 ago 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene VICKERS ELECTRONICS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    19 abr 2017Inicio de la administración
    22 mar 2018Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sarah Helen Bell
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Profesional
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Steven Muncaster
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Profesional
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0