AMDOCS SYSTEMS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | AMDOCS SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03230725 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de AMDOCS SYSTEMS LIMITED?
- Actividades de consultoría en tecnología de la información (62020) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra AMDOCS SYSTEMS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 3rd Floor Chiswick Park Estate 566 Chiswick High Road W4 5YE London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AMDOCS SYSTEMS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CRAMER SYSTEMS LIMITED | 28 ago 1996 | 28 ago 1996 |
| SYNTEX SOFTWARE LIMITED | 29 jul 1996 | 29 jul 1996 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de AMDOCS SYSTEMS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para AMDOCS SYSTEMS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2020 | 24 páginas | AA | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2019 | 24 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 jul 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2018 | 19 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF United Kingdom a 3rd Floor Chiswick Park Estate 566 Chiswick High Road London W4 5YE el 01 jul 2019 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Janett Kristina Sarfert como director el 31 oct 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Janett Kristina Sarfert como secretario el 31 oct 2018 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 jul 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2017 | 19 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Martin Joseph Barry como secretario el 01 may 2018 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Alexis Alexandrou como secretario el 01 may 2018 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mr Martin Joseph Barry como director el 01 may 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Alexis Alexandrou como director el 01 may 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Alexis Alexandrou como director el 12 dic 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Eli Tuson como secretario el 12 dic 2017 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Neville Thomas Walker como director el 12 dic 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Alexis Alexandrou como secretario el 12 dic 2017 | 2 páginas | AP03 | ||
Modification des détails de Amdocs Systems Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 may 2017 | 2 páginas | PSC05 | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 jul 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Cannon Place, 78 Cannon Street London EC4N 6AF England a Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF el 23 may 2017 | 1 páginas | AD01 | ||
¿Quiénes son los directivos de AMDOCS SYSTEMS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRY, Martin Joseph | Secretario | 566 Chiswick High Road W4 5YE London 3rd Floor Chiswick Park Estate England | 246234420001 | |||||||
| BARRY, Martin Joseph | Director | 566 Chiswick High Road W4 5YE London 3rd Floor Chiswick Park Estate England | Ireland | Irish | 289643060001 | |||||
| ALEXANDROU, Alexis | Secretario | 141 Omonia Avenue The Maritime Centre, Block B 3045 Limassol Amdocs Development Ltd Cyprus | 242168490001 | |||||||
| BISHOP, Nicholas | Secretario | Fernbank Lower North Street BS27 3HA Cheddar Somerset | British | 63670130001 | ||||||
| COOPER, Ann Marie | Secretario | E14 | British | 134905670001 | ||||||
| CRATON, Jonathan Peter Michael | Secretario | Cote Drive Westbury On Trym BS9 3UP Bristol The Lodge Avon | British | 132512230001 | ||||||
| CRATON, Jonathan | Secretario | 53 Devonshire Road Westbury Park BS6 7NQ Bristol | British | 56548370002 | ||||||
| FENNER, Robert Matthew | Secretario | 33 Sheldon Avenue N6 4JP London | British | 29115130002 | ||||||
| OLIVER, Matthew | Secretario | 4 Manor Farm Crescent Bradley Stoke BS32 9BD Bristol Avon | British | 79877370001 | ||||||
| RICE JONES, David Wyndham | Secretario | Longacres Wellingtonia Avenue RG45 6AF Crowthorne Berkshire | British | 75440480002 | ||||||
| SARFERT, Janett Kristina | Secretario | c/o Amdocs Management Limited Wharfedale Road RG41 5RD Winnersh Berkshire Place Berkshire United Kingdom | British | 169994940001 | ||||||
| TOMSON, Rachel | Secretario | 1 Church Close Bathford BA1 7RP Bath Avon | British | 120269260001 | ||||||
| TUSON, Eli | Secretario | First Floor, Block S East Point Business Park Dublin 3 Amdocs Software Systems Limited Ireland | British | 161234470001 | ||||||
| WALKER, Neville | Secretario | Hillcrest Station Road Lusk Dublin Ireland | Irish | 114729350001 | ||||||
| WALSH, John | Secretario | 12 Treesdale Stillorgan Co Dublin Ireland | British | 138981910001 | ||||||
| TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||
| ALEXANDROU, Alexis | Director | 141 Omonia Avenue The Maritime Centre, Block B 3045 Limassol Amdocs Development Ltd Cyprus | Cyprus | Cypriot | 132891760001 | |||||
| BISHOP, Nicholas | Director | Fernbank Lower North Street BS27 3HA Cheddar Somerset | British | 63670130001 | ||||||
| CARRATT, David Jonathan | Director | Glenridge Lodge Callow Hill GU25 4LF Virginia Water Surrey | United Kingdom | British | 22585710002 | |||||
| COOPER, Ann Marie | Director | E14 | United Kingdom | British | 134905670001 | |||||
| CRATON, Jonathan Peter Michael | Director | Cote Drive Westbury On Trym BS9 3UP Bristol The Lodge Avon | England | British | 132512230001 | |||||
| EMBLETON, David Thomas | Director | Temple Manor Upton Scudamore BA12 0AQ Warminster Wiltshire | British | 3281930002 | ||||||
| FARMER, Mark | Director | Le Courtil Au Pretre Les Merriennes, St. Martin GY4 6NP Guernsey Channel Islands | British | 66425600002 | ||||||
| FARMER, Mark | Director | 147 Amyand Park Road TW1 3HN Twickenham Middlesex | British | 66425600001 | ||||||
| GIBSON, Donald Robert | Director | Charlecombe Grove House Charlcombe BA1 9BQ Bath | United Kingdom | British | 142808670001 | |||||
| HEXT, Rebecca Jane | Director | 51 Lower Chapel Court South Horrington BA5 3DF Wells Somerset | British | 116738070001 | ||||||
| OLIVER, Matthew | Director | 4 Manor Farm Crescent Bradley Stoke BS32 9BD Bristol Avon | England | British | 79877370001 | |||||
| SANKER, Ganesh | Director | Martins Drive RG41 1NY Wokingham 20 Berkshire | Uk | Indian | 126134190002 | |||||
| SARFERT, Janett Kristina | Director | c/o Amdocs Management Limited Wharfedale Road RG41 5RD Winnersh Berkshire Place Berkshire United Kingdom | England | German | 169884040002 | |||||
| SWINN, Andrea Karen | Director | 15 Fetter Lane EC4A 1BR London Amdocs Management Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 177018050001 | |||||
| TOMSON, Rachel | Director | 1 Church Close Bathford BA1 7RP Bath Avon | England | British | 120269260001 | |||||
| TUSON, Eli | Director | 150 Howth Road IRISH Dublin Ireland | Israeli | 116737310001 | ||||||
| WALKER, Neville Thomas | Director | First Floor, Block S East Point Business Park Dublin 3 Amdocs Software Systems Limited Ireland | Ireland | Irish | 187981100001 | |||||
| COMPANY DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de AMDOCS SYSTEMS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amdocs Systems Group Limited | 06 abr 2016 | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene AMDOCS SYSTEMS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 21 may 2000 Entregado el 25 may 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 24 sept 1998 Entregado el 30 sept 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rent deposit agreement | Creado el 20 dic 1996 Entregado el 24 dic 1996 | Pendiente | Cantidad garantizada The liabilities pursuant to a lease between the company and the chargee | |
Breve descripción Rent deposit of £2,000. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0