CELLULAR OPERATIONS LIMITED

CELLULAR OPERATIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCELLULAR OPERATIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03231393
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CELLULAR OPERATIONS LIMITED?

    • Otras actividades de telecomunicaciones (61900) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra CELLULAR OPERATIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CELLULAR OPERATIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GUARDSURE PLC30 jul 199630 jul 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CELLULAR OPERATIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CELLULAR OPERATIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017

    6 páginasAA

    Cancelación total de la carga 4

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 12

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 13

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 10

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 9

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 11

    2 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Nombramiento de Ms Diane Mcintyre como director el 01 ene 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Peregrine Douglas Gonzague Riviere como director el 01 ene 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 mar 2016

    7 páginasAA

    legacy

    207 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    Cese del nombramiento de Diego Galli como director el 01 may 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Peregrine Douglas Gonzague Riviere como director el 01 may 2016

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 14 feb 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 mar 2016

    Estado de capital el 15 mar 2016

    • Capital: GBP 150,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015

    5 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de CELLULAR OPERATIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2357692
    75473330004
    EVANS, David Nigel
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector134975040001
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director173703620001
    BUNTER, Nigel Stephen Gilmore
    3 Poughcombe Cottages
    Ogbourne St. Andrew
    SN8 1SE Marlborough
    Wiltshire
    Secretario
    3 Poughcombe Cottages
    Ogbourne St. Andrew
    SN8 1SE Marlborough
    Wiltshire
    BritishCompany Director69955750001
    DAVIS, Clive Clayton
    Hill Farm House
    Little Rissington
    GL54 2NA Cheltenham
    Gloucestershie
    Secretario
    Hill Farm House
    Little Rissington
    GL54 2NA Cheltenham
    Gloucestershie
    British92013820001
    EMETULU, Lola
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British88619360002
    WRIGHT, Garth Howard
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    England
    Secretario
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    England
    British130769810001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secretario designado corporativo
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishDirector123612980001
    BREWER, Stephen
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Director
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director79186090002
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Director
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    BritishDirector83126790001
    BUNTER, Nigel Stephen Gilmore
    3 Poughcombe Cottages
    Ogbourne St. Andrew
    SN8 1SE Marlborough
    Wiltshire
    Director
    3 Poughcombe Cottages
    Ogbourne St. Andrew
    SN8 1SE Marlborough
    Wiltshire
    BritishCompany Director69955750001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishDirector99525280001
    DARBY, Gavin John
    Rodona House
    Rodona Road St Georges Hill
    KT13 0NP Weybridge
    Surrey
    Director
    Rodona House
    Rodona Road St Georges Hill
    KT13 0NP Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishDirector99277850001
    DAVIS, Clive Clayton
    Hill Farm House
    Little Rissington
    GL54 2NA Cheltenham
    Gloucestershie
    Director
    Hill Farm House
    Little Rissington
    GL54 2NA Cheltenham
    Gloucestershie
    BritishChartered Accountant92013820001
    DEV, Vivek
    Connought House
    Ledborough Gate Ledborough Lane
    HP9 2DQ Beaconsfield
    Director
    Connought House
    Ledborough Gate Ledborough Lane
    HP9 2DQ Beaconsfield
    BritishChartered Accountant79178710001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishChief Financial Officer127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishSenior Finance Manager158146620001
    GALLI, Diego
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomItalianCompany Director171566420001
    HARRIS, Brian Athol
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)AustralianHead Of Enterprise Finance135937300001
    KNIGHT, Nigel Phillip
    The Old Barn, Formby Hall
    Southport Old Road, Formby
    L37 0AB Liverpool
    Merseyside
    Director
    The Old Barn, Formby Hall
    Southport Old Road, Formby
    L37 0AB Liverpool
    Merseyside
    BritishCompany Director70898900001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Director
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritishDirector24471140001
    LEE, Richard Ashleigh
    29 Cheyne Walk
    Chelsea
    SW3 5HH London
    Director
    29 Cheyne Walk
    Chelsea
    SW3 5HH London
    United KingdomBritishCompany Director11980050001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Director
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishDirector86697870001
    LOGAN, Hugh
    7 Tresham Drive
    Grappenhall
    WA4 3DU Warrington
    Cheshire
    Director
    7 Tresham Drive
    Grappenhall
    WA4 3DU Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishM.D.119332280001
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director173703620001
    MOFFAT, Simon Alexander
    Greyfriars
    17 Pony Chase
    KT11 2PF Cobham
    Surrey
    Director
    Greyfriars
    17 Pony Chase
    KT11 2PF Cobham
    Surrey
    BritishFinance Director41139540002
    NOWAK, Thomas, Dr
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomGermanDirector174443800001
    PURKESS, Martin John
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritishDirector139360020001
    QADRI, Sohail
    122 Somerset Road
    Wimbledon
    SW19 5HP London
    Director
    122 Somerset Road
    Wimbledon
    SW19 5HP London
    BritishManager52341900001
    READ, Nicholas Jonathan
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector87149560001
    RIVIERE, Peregrine Douglas Gonzague
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritishDirector207135750001
    SCHA*FER, Richard Wolfgang Henry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Finance Technology & Support150941520001
    TOURNON, Emanuele
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomItalianDirector103542080002
    TOWNSEND, John Raymond
    Knowle House
    Chapel Corner Hamstead Marshall
    RG20 0HP Newbury
    Berkshire
    Director
    Knowle House
    Chapel Corner Hamstead Marshall
    RG20 0HP Newbury
    Berkshire
    BritishFinancial Director95223480001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CELLULAR OPERATIONS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3942192
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro2227940
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 50% pero no más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 50% pero no más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene CELLULAR OPERATIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal mortgage
    Creado el 22 ene 2003
    Entregado el 08 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All that f/h property k/a sites 1 and 2 and the land at the north side of peatmoor way hillmead t/n WT177342 and WT190205.
    Personas con derecho
    • Nigel Bunter
    Transacciones
    • 08 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 09 nov 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 22 ene 2003
    Entregado el 08 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All that f/h property k/a sites 1 and 2 and the land at the north side of peatmoor way hillmead t/n WT177342 and WT190205.
    Personas con derecho
    • Richard Lee
    Transacciones
    • 08 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 09 nov 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of charge (the supplemental charge) which is supplemental to a deed of charge made on 11 may 2000 between the company and vodafone limited
    Creado el 16 feb 2001
    Entregado el 05 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Vodafone Limited
    Transacciones
    • 05 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 17 oct 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of charge
    Creado el 29 ago 2000
    Entregado el 15 sept 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of a service provider agreement dated 28 june 2000
    Breve descripción
    First fixed charge all claims choses in action intellectual property goodwill under the service provider agreement and all book debts; floating charge the remainder of the subscriber base. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Telecom Securicor Cellular Radio Limited
    Transacciones
    • 15 sept 2000Registro de un cargo (395)
    • 27 oct 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of charge
    Creado el 11 may 2000
    Entregado el 27 may 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the service provider agreement of even date
    Breve descripción
    First fixed charge choses in action intellectual property goodwill and alll book debts; floating charge the remainder of the subscriber base. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Vodafone Limited
    Transacciones
    • 27 may 2000Registro de un cargo (395)
    • 17 oct 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Chattel mortgage
    Creado el 30 mar 1999
    Entregado el 01 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,000,000 and all other sums due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Computer equipment/telephone system as per goods listed. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 01 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 06 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Second legal charge
    Creado el 01 mar 1999
    Entregado el 17 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as set out in clause 21 and schedule 4 of a development agreement dated 10.12.1998 (as defined),payments from the building contractor relating to the office development of the premises charged,fees of ec harris and curona designs limited in connection with the said development and any additional amounts payable under the agreement dated 10.12.1998
    Breve descripción
    F/Hold land at hillmead way,swindon,wiltshire.
    Personas con derecho
    • Highbridge Properties PLC
    Transacciones
    • 17 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of security assignment and agreement
    Creado el 23 feb 1999
    Entregado el 12 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan agreements (as defined)
    Breve descripción
    All the company's right title and interest in and all benefits to accrue to it in respect of the building contract, the parent company guarantee, the appointments and the performance bond under the first deed of assignment and the development agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 12 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage debenture
    Creado el 26 nov 1998
    Entregado el 08 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 08 dic 1998Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 20 nov 1998
    Entregado el 11 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a site off meadway hillmead enterprise park swindon wiltshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 11 dic 1998Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Deposit deed
    Creado el 03 jul 1998
    Entregado el 09 jul 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of two leases both of even date
    Breve descripción
    A deposit of £138,000 held by the chargee with lloyds bank PLC covent garden branch.
    Personas con derecho
    • Sun Alliance & London Assurance Company Limited
    Transacciones
    • 09 jul 1998Registro de un cargo (395)
    • 20 abr 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 27 mar 1997
    Entregado el 04 abr 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to airtime charges
    Breve descripción
    Second fixed and floating charge over custoner recievables.
    Personas con derecho
    • Telecom Securicor Cellular Radio Limited
    Transacciones
    • 04 abr 1997Registro de un cargo (395)
    • 20 abr 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 mar 1997
    Entregado el 04 abr 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 27TH march 1997
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Telecom Securicor Cellular Radio Limited
    Transacciones
    • 04 abr 1997Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0