ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED

ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaECD (COOKHAM WOOD) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03241233
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED?

    • Construcción de edificios comerciales (41201) / Construcción
    • Educación secundaria técnica y profesional (85320) / Educación

    ¿Dónde se encuentra ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Smith & Williamson Llp Portwall Place
    Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    14 páginasLIQ13

    Cambio de datos del director Mr Chris Burlton el 26 ene 2018

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de Third Floor Broad Quay House Prince Street Bristol BS1 4DJ a C/O Smith & Williamson Llp Portwall Place Portwall Lane Bristol BS1 6NA el 15 jun 2017

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 30 may 2017

    LRESSP

    Cambio de datos del secretario Semperian Secretariat Services Limited el 19 may 2017

    1 páginasCH04

    Cese del nombramiento de Alan Campbell Ritchie como director el 31 mar 2017

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 1

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 jun 2016

    Estado de capital el 28 jun 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cese del nombramiento de Paul Roger Cook como director el 18 may 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Gawie Murray Nienaber como director el 18 may 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Parker como director el 18 may 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Vaishali Jagdish Patel como director el 18 may 2016

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 22 ago 2015 avec liste complète des actionnaires

    9 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 ago 2015

    Estado de capital el 24 ago 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Paul Roger Cook el 01 jul 2015

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2015

    18 páginasAA

    Nombramiento de Mr Chris Burlton como director el 02 dic 2014

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Vaishali Jagdish Patel como director el 17 nov 2014

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SEMPERIAN SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    4th Floor
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    4th Floor
    United Kingdom
    107624260005
    BURLTON, Chris
    Broad Quay House
    Prince Street
    BS1 4DJ Bristol
    Third Floor
    United Kingdom
    Director
    Broad Quay House
    Prince Street
    BS1 4DJ Bristol
    Third Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish191923330001
    ANDERSON, David Alexander John
    4 Elm Tree Avenue
    KT10 8JG Esher
    Surrey
    Secretario
    4 Elm Tree Avenue
    KT10 8JG Esher
    Surrey
    British94497310001
    BARLOW, Suzanne
    22 Monteagle Drive
    DY6 7RY Kingswinford
    West Midlands
    Secretario
    22 Monteagle Drive
    DY6 7RY Kingswinford
    West Midlands
    British49252810001
    HERZBERG, Francis Robin
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    Secretario
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    British52429400001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secretario designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    ANDERSON, David Alexander John
    4 Elm Tree Avenue
    KT10 8JG Esher
    Surrey
    Director
    4 Elm Tree Avenue
    KT10 8JG Esher
    Surrey
    British94497310001
    BANKS, Andrew David
    St. Marys
    Cowl Lane, Winchcombe
    GL54 5RA Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    St. Marys
    Cowl Lane, Winchcombe
    GL54 5RA Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish164295230001
    BIRCH, Alan Edward
    Broad Quay House
    Prince Street
    BS1 4DJ Bristol
    Third Floor
    United Kingdom
    Director
    Broad Quay House
    Prince Street
    BS1 4DJ Bristol
    Third Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish90700330001
    BIRCH, Alan Edward
    7 Silsbury Grove
    Standish
    WN6 0EY Wigan
    Lancashire
    Director
    7 Silsbury Grove
    Standish
    WN6 0EY Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish90700330001
    BROWN, Matthew Charles
    Southside
    105 Victoria Street
    SW1E 6QT London
    G4s
    England
    England
    Director
    Southside
    105 Victoria Street
    SW1E 6QT London
    G4s
    England
    England
    EnglandBritish181465860001
    BROWN, Stephen Richard
    8 Arbour Close
    GL55 6RR Mickleton
    Gloucestershire
    Director
    8 Arbour Close
    GL55 6RR Mickleton
    Gloucestershire
    British15085940005
    COOK, Paul Roger
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    United Kingdom
    Director
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    United Kingdom
    UkBritish117120110001
    DALGLEISH, Bruce Warren
    Post Box House
    Abinger Road
    RH5 6HD Coldharbour
    Surrey
    Director
    Post Box House
    Abinger Road
    RH5 6HD Coldharbour
    Surrey
    United KingdomBritish106281140002
    DALGLEISH, Bruce Warren
    Post Box House
    Abinger Road
    RH5 6HD Coldharbour
    Surrey
    Director
    Post Box House
    Abinger Road
    RH5 6HD Coldharbour
    Surrey
    United KingdomBritish106281140002
    ELLIOTT, Christopher
    Woodcote House
    Broad Lane Bishampton
    WR10 2LY Pershore
    Worcestershire
    Director
    Woodcote House
    Broad Lane Bishampton
    WR10 2LY Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritish64082070001
    FARLEY, Graham
    9 Manor Close
    Hinstock
    TF9 2TZ Market Drayton
    Salop
    Director
    9 Manor Close
    Hinstock
    TF9 2TZ Market Drayton
    Salop
    United KingdomBritish183764380001
    GILBEY, Hannah
    14 Dane Park
    CM23 2PR Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Director
    14 Dane Park
    CM23 2PR Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British78180430001
    GIRLING, Christopher Francis
    12 Spithead Close
    PO34 5AZ Seaview
    Isle Of Wight
    Director
    12 Spithead Close
    PO34 5AZ Seaview
    Isle Of Wight
    British67125270002
    HARROWER, James Arthur
    24 Lifford Gardens
    WR12 7DA Broadway
    Worcestershire
    Director
    24 Lifford Gardens
    WR12 7DA Broadway
    Worcestershire
    British12257110001
    HERZBERG, Francis Robin
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    Director
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    EnglandBritish52429400001
    HERZBERG, Francis Robin
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    Director
    Connaught Gardens
    HP4 1SF Berkhamsted
    6
    Hertfordshire
    EnglandBritish52429400001
    JONES, Stuart Nigel
    23 Old Farm Drive
    Codsall
    WV8 1GF Wolverhampton
    West Midlands
    Director
    23 Old Farm Drive
    Codsall
    WV8 1GF Wolverhampton
    West Midlands
    British79744320001
    LAVERS, Michael John
    2 Binden Road
    W12 9RJ London
    Director
    2 Binden Road
    W12 9RJ London
    EnglandBritish3090450001
    MALMBERG, Louis Joannes
    Scheveningseslag 87
    2586 KW The Hague
    Netherlands
    Director
    Scheveningseslag 87
    2586 KW The Hague
    Netherlands
    Dutch45086130001
    MCCORMACK, James Joseph
    Broome House
    Chapel Lane Knockin Heath
    SY10 8EB Oswestry
    Shropshire
    Director
    Broome House
    Chapel Lane Knockin Heath
    SY10 8EB Oswestry
    Shropshire
    British678610003
    MCCULLOCH, Paul
    33 Southwood Avenue
    Highgate
    N6 5SA London
    Director
    33 Southwood Avenue
    Highgate
    N6 5SA London
    British101810930001
    MCEWAN, Euan
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    Director
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    British110597480001
    MORGAN, David Keir Ewart
    Care And Justice
    5th Floor, Southside 105 Victoria Street
    SW1E 6QT London
    G4s
    England
    England
    Director
    Care And Justice
    5th Floor, Southside 105 Victoria Street
    SW1E 6QT London
    G4s
    England
    England
    EnglandBritish106484320002
    MORRIS, Richard
    Old Park Lane
    M41 7HA Manchester
    1
    United Kingdom
    Director
    Old Park Lane
    M41 7HA Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish159675380001
    NIENABER, Gawie Murray
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    England
    England
    Director
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    England
    England
    EnglandBritish187146260001
    OSBORNE, Robert Charles
    Heath View
    Bromstead Common
    TF10 9DG Newport
    Shropshire
    Director
    Heath View
    Bromstead Common
    TF10 9DG Newport
    Shropshire
    British68448420001
    PARKER, John
    Chalgrove Field
    Oakhill
    MK5 6AJ Milton Keynes
    Oakhill Stc
    England
    England
    Director
    Chalgrove Field
    Oakhill
    MK5 6AJ Milton Keynes
    Oakhill Stc
    England
    England
    United KingdomEnglish182836610001
    PATEL, Vaishali Jagdish
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    United Kingdom
    Director
    105 Victoria St
    SW1E 6QT London
    Southside
    United Kingdom
    United KingdomBritish192721880001
    PELLARD, Brian
    33 Wyvern Road
    B74 2PS Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    33 Wyvern Road
    B74 2PS Sutton Coldfield
    West Midlands
    British33408310001

    ¿Tiene ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 19 nov 2004
    Entregado el 24 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H property k/a cookham wood secure training centre cookham wood rochester kent.
    Personas con derecho
    • Abn Amro Bank N.V.
    Transacciones
    • 24 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 20 may 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 21 mar 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental fixed charge
    Creado el 31 ene 2002
    Entregado el 20 feb 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest in and to the equipment including all moneyspayable and the proceeds of any claims awards or judgements together with interest. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Her Majesty's Principal Secretary of State for the Home Department (Including His Successors or Assigns or the Person Deriving Title Through or Under Him in Whole or in Part and Whether at Law or in Equity)
    Transacciones
    • 20 feb 2002Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage
    Creado el 31 ene 2002
    Entregado el 20 feb 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The sums payable by her majesty's principal secretary of state for the home department (the "authority") to the company pursuant to schedule u of an agreement (the "dcmf contract") dated 3RD march 1997 between the mortgagor and the authority for the design construction maintenance and operation of a secure training centre at medway kent.
    Personas con derecho
    • Carillion Construction Limited
    Transacciones
    • 20 feb 2002Registro de un cargo (395)
    • 18 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed and floating charge debenture
    Creado el 03 mar 1997
    Entregado el 10 mar 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any banks financing document
    Breve descripción
    .Leasehold property known as cookham wood, rochester, kent.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Abn Amro Bank N.V.(As Trustee for the Bank Secured Creditors)
    Transacciones
    • 10 mar 1997Registro de un cargo (395)
    • 11 may 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 21 mar 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 03 mar 1997
    Entregado el 10 mar 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or connection with any banks financing document
    Breve descripción
    All that leasehold property knoen as cookham wood secure training centre, cookham wood, rochester, kent.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Abn Amro Bank N.V.(As Trustee for the Banks Secured Creditors)
    Transacciones
    • 10 mar 1997Registro de un cargo (395)
    • 11 may 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 21 mar 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of fixed charge
    Creado el 03 mar 1997
    Entregado el 08 mar 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The obligation of the company owed to the chargee under or pursuant to clause 17.2 of the agreement dated 3RD march 1997 between the chargee and the company (as therein defined) ("the dcmf contract") to transfer title to the equipment (as therein defined) upon termination of the "dcmf contract" together with any damages payable by the company to the chargee by reason of a failure to comply with clause 17.2 of the "dcmf contract"
    Breve descripción
    All the company's right title and interest (present and future) to and in the equipment being all the property referred to in schedule b of the dcmf contract and all the plant machinery and other equipment referred to in schedule a of the dcmf contract by way of first fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Her Majesty's Principal Secretary of State for the Home Department(Including His Successors or Assigns or the Person Deriving Title Through or Under Him in Wholeor in Part and Whether at Law or in Equity)
    Transacciones
    • 08 mar 1997Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2017Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene ECD (COOKHAM WOOD) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    30 may 2017Inicio de la liquidación
    02 may 2018Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Gilbert J Lemon
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Avon
    Profesional
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Avon
    Richard Lewis
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Profesional
    Portwall Place Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0