TD PACKAGING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTD PACKAGING LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03243491
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TD PACKAGING LIMITED?

    • Actividades de embalaje (82920) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra TD PACKAGING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Ashfield House
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Leicestershire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TD PACKAGING LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BORDERS PACKAGING LIMITED29 ago 199629 ago 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TD PACKAGING LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TD PACKAGING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Nombramiento de Andrew Martin Morrow como secretario el 15 oct 2021

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Damien Moynagh como secretario el 15 oct 2021

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 02 sept 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2020

    14 páginasAA

    Nombramiento de Alison Richardson como director el 24 sept 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Birtles como director el 24 sept 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 02 sept 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2019

    13 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 sept 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2018

    13 páginasAA

    Nombramiento de Mr David Birtles como director el 01 oct 2018

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Louise Tallon como director el 01 oct 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Alan Ralph como director el 01 oct 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Sean Gerard Coyle como director el 26 sept 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 29 ago 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2017

    13 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 29 ago 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2016

    15 páginasAA

    Nombramiento de Mr Damien Moynagh como secretario el 03 may 2017

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Tara Grimley como secretario el 03 may 2017

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 29 ago 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Michael Gannon como director el 30 jun 2016

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de TD PACKAGING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MORROW, Andrew Martin
    Church Way
    N20 0LA London
    30
    United Kingdom
    Secretario
    Church Way
    N20 0LA London
    30
    United Kingdom
    288464390001
    RICHARDSON, Alison
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    Director
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    EnglandBritish251246230001
    TALLON, Louise
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    20
    Dublin
    Ireland
    Director
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    20
    Dublin
    Ireland
    IrelandIrish251371350001
    DALY, Barbara
    19 High Street
    Cricklade
    SN6 6AP Swindon
    Wiltshire
    Secretario
    19 High Street
    Cricklade
    SN6 6AP Swindon
    Wiltshire
    British49255000003
    DALY, Mark Shaun
    19 High Street
    Cricklade
    SN6 6AP Swindon
    Wiltshire
    Secretario
    19 High Street
    Cricklade
    SN6 6AP Swindon
    Wiltshire
    British49254940003
    GANNON, Michael
    Stillorgan Park
    Blackrock
    Co. Dublin
    7
    Ireland
    Secretario
    Stillorgan Park
    Blackrock
    Co. Dublin
    7
    Ireland
    177394180001
    GEOGHEGAN, Karen
    8 Woodstown Parade
    16 Knocklyon
    Dublin
    Ireland
    Secretario
    8 Woodstown Parade
    16 Knocklyon
    Dublin
    Ireland
    Irish126163560001
    GOUGH, Philip
    17 Badgers Brook
    Wroughton
    SN4 9DG Swindon
    Wiltshire
    Secretario
    17 Badgers Brook
    Wroughton
    SN4 9DG Swindon
    Wiltshire
    British103829140002
    GRIMLEY, Tara
    Linseys Hill
    BT61 9HD Armagh
    34
    Northern Ireland
    Secretario
    Linseys Hill
    BT61 9HD Armagh
    34
    Northern Ireland
    188265530001
    MOYNAGH, Damien
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    Secretario
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    231205960001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secretario designado corporativo
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BIRTLES, David Warren
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    Director
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    United KingdomBritish251208900001
    CLOW, Karen Susan
    Sanctuary Cottage Upper Lynch Road
    France Lynch
    GL6 8LZ Stroud
    Gloucestershire
    Director
    Sanctuary Cottage Upper Lynch Road
    France Lynch
    GL6 8LZ Stroud
    Gloucestershire
    British52324430002
    COYLE, Sean Gerard
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    Director
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    IrelandIrish253248680001
    DALY, Mark Shaun
    19 High Street
    Cricklade
    SN6 6AP Swindon
    Wiltshire
    Director
    19 High Street
    Cricklade
    SN6 6AP Swindon
    Wiltshire
    British49254940003
    FITZGERALD, Liam Michael
    32 Grosvenor Road
    IRISH Rathgar
    Dublin 6
    Ireland
    Director
    32 Grosvenor Road
    IRISH Rathgar
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrish70358960003
    FLYNN, Annette
    Magna Drive
    Magna Business Park
    Citywest Road
    United Drug House
    Dublin 24
    Ireland
    Director
    Magna Drive
    Magna Business Park
    Citywest Road
    United Drug House
    Dublin 24
    Ireland
    IrishIrish153801960001
    GANNON, Michael
    Magna Drive
    Magna Business Park
    Citywest Road
    United Drug House
    Dublin 24
    Ireland
    Director
    Magna Drive
    Magna Business Park
    Citywest Road
    United Drug House
    Dublin 24
    Ireland
    IrelandIrish281260700001
    MCGRANE, Barry
    72 Holywell
    Upper Kilmacud Road
    IRISH Dublin 6
    Ireland
    Director
    72 Holywell
    Upper Kilmacud Road
    IRISH Dublin 6
    Ireland
    Irish76789920001
    RALPH, Alan
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    Director
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    IrelandIrish168997940001
    SCOTT, Enda John
    Magna Business Park
    Citywest Road
    Dublin
    United Drug House Magna Drive
    24
    Ireland
    Director
    Magna Business Park
    Citywest Road
    Dublin
    United Drug House Magna Drive
    24
    Ireland
    EnglandIrish172282060001
    TEDHAM, Martin John
    South Farm
    Chiseldon
    SN4 0JF Swindon
    Mulburry House
    Wiltshire
    Director
    South Farm
    Chiseldon
    SN4 0JF Swindon
    Mulburry House
    Wiltshire
    EnglandBritish139879690001
    VAN BIJLEVELD, Anthonius Jan
    PO BOX 713
    As Heerenveen
    European Packaging Centre
    8440
    Netherlands
    Director
    PO BOX 713
    As Heerenveen
    European Packaging Centre
    8440
    Netherlands
    NetherlandsDutch153801410001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Director designado corporativo
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TD PACKAGING LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Udg Healthcare (Uk) Holdings Limited
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    England
    06 abr 2016
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2012
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro3384213
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene TD PACKAGING LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Chattel mortgage
    Creado el 19 may 2005
    Entregado el 21 may 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The chattels being 1 x edl john quinn packaging EVP5025 sleeve wrapper serial no 88044 (0013), 1 x pals FL30SWLR 1.8M labeller serial no 175941 (0024), 1 x pals FL30SWLL 1.8M labeller serial no 156030 (0037), for details of further chattels charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 21 may 2005Registro de un cargo (395)
    • 25 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 01 abr 2005
    Entregado el 18 abr 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transacciones
    • 18 abr 2005Registro de un cargo (395)
    • 25 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent security deposit deed
    Creado el 27 sept 2001
    Entregado el 09 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease
    Breve descripción
    The tenant with full title guarantee has charged its interest in the deposit being the sum of £16,750.00 and all interest and other monies paid or credited to the deposit account or paid by the company to the chargee pursuant to the deed.
    Personas con derecho
    • Winterthur Life UK Limited
    Transacciones
    • 09 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 25 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 17 dic 1999
    Entregado el 21 dic 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Various chattels under the mortgage bearing reference number 258-092218-17 dated 17TH december 1999. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 21 dic 1999Registro de un cargo (395)
    • 14 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 08 dic 1999
    Entregado el 22 dic 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 22 dic 1999Registro de un cargo (395)
    • 20 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 16 mar 1999
    Entregado el 18 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    First fixed charge on all book debts and other debts present and future as are not sold to and bought by alex. Lawrie receivables financing limited under an agreement dated 16TH march 1999 and by way of floating charge on all proceeds thereof either under or in connection with any agreement or contract at any time subsisting between the company and alex. Lawrie receivables financing for the sale and purchase of debts under or in connection with any bill of exchange or other negotiable instrument to which the company and alex. Lawrie recievables financing limited are parties. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Alex Lawrie Receivables Financing Limited
    Transacciones
    • 18 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 18 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 18 jun 1997
    Entregado el 24 jun 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date
    Breve descripción
    £6,462.50 and interest.
    Personas con derecho
    • Courts PLC
    Transacciones
    • 24 jun 1997Registro de un cargo (395)
    • 07 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0