JHP TRAINING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaJHP TRAINING LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03247918
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de JHP TRAINING LIMITED?

    • Educación secundaria técnica y profesional (85320) / Educación

    ¿Dónde se encuentra JHP TRAINING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Dearing House
    1 Young Street
    S1 4UP Sheffield
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de JHP TRAINING LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CROSSCO (222) LIMITED10 sept 199610 sept 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de JHP TRAINING LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 jul 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para JHP TRAINING LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para JHP TRAINING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cese del nombramiento de Tracie Rose Greenhalgh como director el 04 jul 2014

    1 páginasTM01
    X3CECJBE

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01
    A35YBCPD

    Cese del nombramiento de James Chambers como director

    1 páginasTM01
    X30ZV3LF

    Cancelación total de la carga 3

    4 páginasMR04
    A2NPKY94

    Cancelación total de la carga 6

    4 páginasMR04
    A2NOLY9C

    Déclaration annuelle établie au 10 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 sept 2013

    Estado de capital el 17 sept 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01
    X2H2R9ER

    Cambio de datos del director Mr James Robert Chambers el 30 ago 2013

    2 páginasCH01
    X2H2R9E3

    Cambio de datos del director Mrs Tracie Rose Greenhalgh el 30 ago 2013

    2 páginasCH01
    X2H2R9EB

    Cese del nombramiento de Kristian Henderson-Morrow como director

    1 páginasTM01
    X29GOQS8

    Cese del nombramiento de John Deaville como director

    1 páginasTM01
    X29GOQGX

    Domicilio social registrado cambiado de * 3 Riverstone Court Siskin Drive Middlemarch Business Park Coventry West Midlands CV3 4FJ* el 05 feb 2013

    1 páginasAD01
    X21K3HXE

    Cese del nombramiento de John Swarbrick como director

    1 páginasTM01
    X21HFOEG

    legacy

    3 páginasMG02
    L1N7XXBV

    legacy

    3 páginasMG02
    L1N7XXBN

    legacy

    10 páginasMG01
    L1N2XUZE

    Cese del nombramiento de Gregory Koral como director

    1 páginasTM01
    X1KOUDLS

    Cese del nombramiento de Greg Koral como secretario

    1 páginasTM02
    X1KOU62Q

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2012

    2 páginasAA
    X1KC1Q55

    Déclaration annuelle établie au 10 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    X1HGMOTT

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 jul 2011

    2 páginasAA
    XHV4OZPP

    Déclaration annuelle établie au 10 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    XV9EEXWM

    Nombramiento de Mr Greg Koral como director

    2 páginasAP01
    XT4HKXQI

    Nombramiento de Mr Greg Koral como secretario

    1 páginasAP03
    XT4IDXQC

    ¿Quiénes son los directivos de JHP TRAINING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ANDERSON, Margaret
    5 College Green
    Wanborough
    SN4 0AZ Swindon
    Wiltshire
    Secretario
    5 College Green
    Wanborough
    SN4 0AZ Swindon
    Wiltshire
    British11878420001
    HARRIS, Ralph William
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    Secretario
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    British148241270001
    KORAL, Greg
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    Secretario
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    163187690001
    PITMAN, Helen Ruth
    Foxley House
    SN16 0JJ Malmesbury
    Wiltshire
    Secretario
    Foxley House
    SN16 0JJ Malmesbury
    Wiltshire
    British73397610001
    DICKINSON DEES
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    Secretario designado corporativo
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    900005460001
    CARE, Timothy James
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    Director designado
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    British900005450001
    CHAMBERS, James Robert
    1 Young Street
    S1 4UP Sheffield
    Dearing House
    England
    Director
    1 Young Street
    S1 4UP Sheffield
    Dearing House
    England
    EnglandBritishCompany Director121875910001
    CHARTERIS, William John
    2 Summers Close
    The Hollies
    LE9 7QP Kirkby Mallory
    Leicestershire
    Director
    2 Summers Close
    The Hollies
    LE9 7QP Kirkby Mallory
    Leicestershire
    BritishCompany Director55185140001
    DEAVILLE, John Paul
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    Director
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director99794540001
    GREENHALGH, Tracie Rose
    1 Young Street
    S1 4UP Sheffield
    Dearing House
    England
    Director
    1 Young Street
    S1 4UP Sheffield
    Dearing House
    England
    United KingdomBritishCompany Director148240990001
    HARRIS, Ralph William
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    Director
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director174533780002
    HENDERSON-MORROW, Kristian
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    Director
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director148241030001
    KORAL, Gregory David
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    Director
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    EnglandBritishDirector108145070001
    PETERS, David Charles
    The Elms Broad Street
    OX18 2LS Bampton
    Oxfordshire
    Director
    The Elms Broad Street
    OX18 2LS Bampton
    Oxfordshire
    BritishCompany Director55170460001
    PITMAN, Henry John
    Home Farm
    Bourton On The Hill
    GL56 9AF Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Director
    Home Farm
    Bourton On The Hill
    GL56 9AF Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    BritishProperty Sales Negotiator55231490003
    PITMAN, John Hugh
    Foxley House
    SN16 0JJ Malmesbury
    Wiltshire
    Director
    Foxley House
    SN16 0JJ Malmesbury
    Wiltshire
    BritishChairman1262260001
    PITMAN, Thomas Edward
    Foxley House
    Foxley
    SN16 0JJ Malmesbury
    Wiltshire
    Director
    Foxley House
    Foxley
    SN16 0JJ Malmesbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishCompany Director83610320001
    PITMAN, William Hugh
    18 Macaulay Road
    SW4 0QX London
    Director
    18 Macaulay Road
    SW4 0QX London
    BritishFund Manager104764070001
    RICHARDSON, Helen Kathryn
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    Director
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director147736990001
    SWARBRICK, John Frederick
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    Director
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director84418420005
    WILLIAMS, Stephen Fred
    81 Links Drive
    B91 2DJ Solihull
    West Midlands
    England
    Director
    81 Links Drive
    B91 2DJ Solihull
    West Midlands
    England
    BritishCompany Director34195840001

    ¿Tiene JHP TRAINING LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 30 nov 2012
    Entregado el 04 dic 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee, the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Development Capital Holdings Limited (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 04 dic 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 21 dic 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debentures
    Creado el 08 ene 2010
    Entregado el 20 ene 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the security trustee and the beneficiaries to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transacciones
    • 20 ene 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 06 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 08 ene 2010
    Entregado el 15 ene 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee, the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • John Hugh Pitman as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 15 ene 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 06 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 08 ene 2010
    Entregado el 15 ene 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transacciones
    • 15 ene 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 21 dic 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creado el 25 jul 2000
    Entregado el 02 ago 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Five Arrows Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 02 ago 2000Registro de un cargo (395)
    • 18 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0