GYROSOFT APPLIED SOLUTIONS LIMITED

GYROSOFT APPLIED SOLUTIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGYROSOFT APPLIED SOLUTIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03252373
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GYROSOFT APPLIED SOLUTIONS LIMITED?

    • (7487) /

    ¿Dónde se encuentra GYROSOFT APPLIED SOLUTIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    10 Sedfield House Dairy Sandy Lane
    Shedfield
    SO32 2HQ Southampton
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GYROSOFT APPLIED SOLUTIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GLOTEL ACCOUNTING SYSTEMS LIMITED18 mar 200418 mar 2004
    GLOTEL ACCOUNTING SYSTEMS PLC16 sept 199616 sept 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GYROSOFT APPLIED SOLUTIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GYROSOFT APPLIED SOLUTIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 ene 2013

    3 páginas4.68

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    3 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de The Old Coach House Grange Court, Grange Road Tongham Farnham Surrey GU10 1DW United Kingdom el 13 feb 2012

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 02 feb 2012

    LRESSP

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 jul 2011

    Estado de capital el 05 jul 2011

    • Capital: GBP 50,002
    SH01

    Cambio de datos del director Dinah Margaret Hudson el 30 jun 2011

    2 páginasCH01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    9 páginasAA

    Cese del nombramiento de Mark Howe como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Dinah Margaret Hudson el 30 jun 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Leslie Charles Clark el 30 jun 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Dinah Margaret Hudson el 30 jun 2010

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Dinah Margaret Hudson el 26 mar 2010

    2 páginasCH01

    legacy

    5 páginasMG01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    10 páginasAA

    Nombramiento de Mr Mark Howe como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Matthew Fleming como director

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de River Court Mill Lane Godalming Surrey GU7 1EY el 16 dic 2009

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Susan Westlake como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de GYROSOFT APPLIED SOLUTIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HUDSON, Dinah Margaret
    Sandy Lane
    Shedfield
    SO32 2HQ Southampton
    10 Sedfield House Dairy
    Secretario
    Sandy Lane
    Shedfield
    SO32 2HQ Southampton
    10 Sedfield House Dairy
    British96705560001
    CLARK, Leslie Charles
    Silver Birches
    Nightingales Lane
    HP8 4SL Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Director
    Silver Birches
    Nightingales Lane
    HP8 4SL Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish22206230002
    FLEMING, Matthew
    Sandy Lane
    Shedfield
    SO32 2HQ Southampton
    10 Sedfield House Dairy
    Director
    Sandy Lane
    Shedfield
    SO32 2HQ Southampton
    10 Sedfield House Dairy
    EnglandBritish118538710001
    HUDSON, Dinah Margaret
    Sandy Lane
    Shedfield
    SO32 2HQ Southampton
    10 Sedfield House Dairy
    Director
    Sandy Lane
    Shedfield
    SO32 2HQ Southampton
    10 Sedfield House Dairy
    United KingdomBritish49497570004
    ADKINS, Christopher James
    Whinthorpe
    Oxford Road
    SL9 7DL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secretario
    Whinthorpe
    Oxford Road
    SL9 7DL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British57087870002
    CLARK, Leslie Charles
    Silver Birches
    Nightingales Lane
    HP8 4SL Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Secretario
    Silver Birches
    Nightingales Lane
    HP8 4SL Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British22206230002
    SAFFER, Alan
    3 Heathfield Road
    WD23 2LH Bushey
    Hertfordshire
    Secretario
    3 Heathfield Road
    WD23 2LH Bushey
    Hertfordshire
    British72309130002
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretario designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    ADKINS, Christopher James
    Whinthorpe
    Oxford Road
    SL9 7DL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Whinthorpe
    Oxford Road
    SL9 7DL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British57087870002
    BAKER, Andrew Arthur Edward
    1070 Fisher Lane
    Winnetka
    Il 60093
    Usa
    Director
    1070 Fisher Lane
    Winnetka
    Il 60093
    Usa
    British22206240004
    CLARK, Leslie Charles
    Silver Birches
    Nightingales Lane
    HP8 4SL Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Director
    Silver Birches
    Nightingales Lane
    HP8 4SL Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish22206230002
    HOWE, Mark Richard
    Grange Court, Grange Road
    Tongham
    GU10 1DW Farnham
    The Old Coach House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Grange Court, Grange Road
    Tongham
    GU10 1DW Farnham
    The Old Coach House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish147984270001
    SAFFER, Alan
    3 Heathfield Road
    WD23 2LH Bushey
    Hertfordshire
    Director
    3 Heathfield Road
    WD23 2LH Bushey
    Hertfordshire
    EnglandBritish72309130002
    WESTLAKE, Susan Elizabeth
    2 Nutham Lane
    Southwater
    RH13 9GG Horsham
    West Sussex
    Director
    2 Nutham Lane
    Southwater
    RH13 9GG Horsham
    West Sussex
    British96392250003
    WHITE, Malcolm John
    The Octagon
    103 Chertsey Lane
    TW18 3LQ Staines
    Director
    The Octagon
    103 Chertsey Lane
    TW18 3LQ Staines
    EnglandBritish185833590001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Director designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Director corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    38524190001

    ¿Tiene GYROSOFT APPLIED SOLUTIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rent deposit deed
    Creado el 22 feb 2010
    Entregado el 24 feb 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £5,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The deposit being £5,500 plus vat and any interest.
    Personas con derecho
    • Burlingdale Limited
    Transacciones
    • 24 feb 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 19 ene 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creado el 13 jul 2005
    Entregado el 20 jul 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    £9,176.00.
    Personas con derecho
    • Matune Bv
    Transacciones
    • 20 jul 2005Registro de un cargo (395)
    • 03 sept 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed charge on book and other debts
    Creado el 22 mar 2004
    Entregado el 30 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due up to an amount of £100,000 (plus interest and costs) from the company formerly known as glotel accounting systems limited to the chargee
    Breve descripción
    All book debts both present and future due or owing to the chargor and the benefit of all rights relating thereto; all other monetary debts and claims due or owing to the chargor and the benefit of all rights relating thereto;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Glotel Holdings PLC
    Transacciones
    • 30 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 22 mar 2004
    Entregado el 27 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly known as glotel accounting systems limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 27 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 15 sept 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 14 abr 1999
    Entregado el 22 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 22 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 03 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene GYROSOFT APPLIED SOLUTIONS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    21 abr 2013Fecha de disolución
    02 feb 2012Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Judith Carolyn Wade-Duffee
    Ten Shedfield House Dairy Sandy Lane
    Shedfield
    SO32 2HQ Southampton
    Profesional
    Ten Shedfield House Dairy Sandy Lane
    Shedfield
    SO32 2HQ Southampton

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0