QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED

QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaQUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03260375
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    • Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Asticus Building 2nd Floor
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HUDSON HOMES LIMITED08 oct 199608 oct 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 11 sept 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 11 sept 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    2 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 11 sept 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Déclaration annuelle établie au 11 sept 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 oct 2015

    Estado de capital el 01 oct 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cambio de datos del secretario Sanne Group Secretaries (Uk) Limited el 20 jul 2015

    1 páginasCH04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    2 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Sanne Group 2nd Floor Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP a Asticus Building 2nd Floor 21 Palmer Street London SW1H 0AD el 05 ago 2015

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Jonathan David Farkas como director el 27 ene 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Mathieu Streiff como director el 27 ene 2015

    1 páginasTM01

    legacy

    28 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT1

    legacy

    3 páginasGUARANTEE1

    Déclaration annuelle établie au 11 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 sept 2014

    Estado de capital el 18 sept 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Mathieu Streiff el 31 mar 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Sanne Group Secretaries (Uk) Limited el 31 mar 2014

    1 páginasCH04

    Domicilio social registrado cambiado de * Sanne Group 1 Berkeley Street London W1J 8DJ United Kingdom* el 07 abr 2014

    1 páginasAD01

    Exercice comptable en cours raccourci du 31 mar 2014 au 31 dic 2013

    3 páginasAA01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013

    10 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 11 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 oct 2013

    Estado de capital el 07 oct 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Secretario corporativo
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro8334728
    175738460001
    FARKAS, Jonathan David
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    Director
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    LuxembourgAmerican193539990001
    SAUNDERS, Clare
    The Pound
    67 High Street
    SN6 8AW Shrivenham Swindon
    Wiltshire
    Secretario
    The Pound
    67 High Street
    SN6 8AW Shrivenham Swindon
    Wiltshire
    British155548170001
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Secretario
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    British52338530002
    CO FORM (SECRETARIES) LIMITED
    Dominions House North
    Queen Street
    CF1 4AR Cardiff
    Secretario designado corporativo
    Dominions House North
    Queen Street
    CF1 4AR Cardiff
    900001870001
    HILL, Peter Martin
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Director
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritish130983750002
    JEFFERY, Paul Anthony Keith
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Director
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritish119804090001
    SAUNDERS, Clare
    The Pound
    67 High Street
    SN6 8AW Shrivenham Swindon
    Wiltshire
    Director
    The Pound
    67 High Street
    SN6 8AW Shrivenham Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish155548170001
    SAUNDERS, Peter Michael, Cllr
    67 High Street
    Shrivenham
    SN6 8AW Swindon
    Wiltshire
    Director
    67 High Street
    Shrivenham
    SN6 8AW Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish65642810001
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Director
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritish148139420001
    STREIFF, Mathieu Bernard
    c/o Sanne Group
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor Pollen House
    Director
    c/o Sanne Group
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor Pollen House
    United StatesAmerican200529310001
    TRANTER, Wilfred
    Wayside
    Townsend Road
    SN6 8HR Shrivenham
    Oxfordshire
    Director
    Wayside
    Townsend Road
    SN6 8HR Shrivenham
    Oxfordshire
    British18193010002
    WHITE, Ian James
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Director
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritish133383410003
    CO FORM (NOMINEES) LIMITED
    Dominions House North
    Queen Street
    CF1 4AR Cardiff
    Director designado corporativo
    Dominions House North
    Queen Street
    CF1 4AR Cardiff
    900001860001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    06 abr 2016
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUk
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro04258255
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene QUALITY CARE (WILTSHIRE) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 28 jul 2010
    Entregado el 06 ago 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transacciones
    • 06 ago 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 19 sept 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 16 nov 2007
    Entregado el 27 nov 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tynet/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 27 nov 2007Registro de un cargo (395)
    • 14 sept 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 13 jun 2007
    Entregado el 19 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H miranda house high street wooton bassett swindon wiltshire t/no WT139689. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 14 sept 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 13 jun 2007
    Entregado el 19 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H the old presbytery high street wooton bassett swindon wiltshire t/no WT131191. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 14 sept 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 13 jun 2007
    Entregado el 19 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 19 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 14 sept 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage
    Creado el 03 nov 1999
    Entregado el 24 nov 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The freehold property known as the old presbytery 77 high street, wootton bassett wilts title number WT131191. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 24 nov 1999Registro de un cargo (395)
    • 28 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 03 abr 1997
    Entregado el 19 abr 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a miranda house nursing home high street wootton bassett t/no: WT139689.
    Personas con derecho
    • Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 19 abr 1997Registro de un cargo (395)
    • 28 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 03 abr 1997
    Entregado el 19 abr 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 19 abr 1997Registro de un cargo (395)
    • 28 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0