RINGDANE LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | RINGDANE LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03277059 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RINGDANE LIMITED?
- Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra RINGDANE LIMITED?
Dirección de la sede social | C/O Mazars Llp 90 Victoria Street BS1 6DP Bristol |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RINGDANE LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
TAMARIS (ENGLAND) LIMITED | 22 abr 1997 | 22 abr 1997 |
ROSS PEAR LIMITED | 11 feb 1997 | 11 feb 1997 |
CONTINENTAL SHELF 74 LIMITED | 12 nov 1996 | 12 nov 1996 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RINGDANE LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RINGDANE LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||
Aviso de cambio de la administración a la disolución | 29 páginas | AM23 | ||
Informe de progreso del administrador | 23 páginas | AM10 | ||
Informe de progreso del administrador | 30 páginas | AM10 | ||
Aviso de extensión del período de la administración | 4 páginas | AM19 | ||
Informe de progreso del administrador | 26 páginas | AM10 | ||
Informe de progreso del administrador | 43 páginas | AM10 | ||
Aviso de extensión del período de la administración | 4 páginas | AM19 | ||
Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 3 | 2 páginas | MR05 | ||
Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 4 | 2 páginas | MR05 | ||
Informe de progreso del administrador | 47 páginas | AM10 | ||
Cese del nombramiento de Maureen Claire Royston como director el 30 abr 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Benjamin Robert Taberner como director el 30 jun 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 3 | 2 páginas | MR05 | ||
Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 4 | 2 páginas | MR05 | ||
Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 3 | 2 páginas | MR05 | ||
Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 3 | 2 páginas | MR05 | ||
Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 4 | 2 páginas | MR05 | ||
Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 4 | 2 páginas | MR05 | ||
Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 3 | 2 páginas | MR05 | ||
Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 4 | 2 páginas | MR05 | ||
Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 3 | 2 páginas | MR05 | ||
Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 4 | 2 páginas | MR05 | ||
Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 4 | 2 páginas | MR05 | ||
Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 5 | 2 páginas | MR05 | ||
¿Quiénes son los directivos de RINGDANE LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTISON, Abigail | Secretario | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | 188580660001 | |||||||
BAINES, Philip | Secretario | 97 Hangleton Road BN3 7GH Hove East Sussex | British | 3470830001 | ||||||
CROWE, Geoffrey Michael | Secretario | 51 Oakwood Lane Bowdon WA14 3DL Altrincham Cheshire | British | Commercial Director | 38256680007 | |||||
GRAHAM, Donald Cameron | Secretario | 152 Eastwoodmains Road Clarkston G76 7HF Glasgow Lanarkshire | British | Finance Director | 26178630002 | |||||
KAY, Dominic Jude | Secretario | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | British | Solicitor | 145920530001 | |||||
MURPHY, John | Secretario | 21 Montgreenan View KA13 7NL Kilwinning Ayrshire | British | 26177180002 | ||||||
SIZER, Graham Kevin | Secretario | Woodburn Patrick Brompton DL8 1JN Bedale North Yorkshire | British | Chartered Accountant | 77274540002 | |||||
MD SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | C/0 Mcgrigors Llp 141 Bothwell Street G2 7EQ Glasgow | 900005110001 | |||||||
ANSTEAD, Hamilton Douglas | Director | 5 Heald Court 34 Hawthorn Lane SK9 5DG Wilmslow Cheshire | British | Chief Executive | 107751890001 | |||||
CALVELEY, Peter, Dr | Director | Canwick Hill Canwick LN4 2RF Lincoln The Old Vicarage Lincolnshire | United Kingdom | British | Ceo | 131468590001 | ||||
CHURCHLEY, Peter Knight | Director | Rosevale House Woodside Lane SL4 2DW Windsor Forest Berkshire | England | British | Director | 77173520001 | ||||
CROWE, Geoffrey Michael | Director | 51 Oakwood Lane Bowdon WA14 3DL Altrincham Cheshire | British | Commercial Director | 38256680007 | |||||
ELLIOTT, Graham Nicholas | Director | 9 Bowmans Close BN44 3SR Steyning West Sussex | England | British | Company Director | 38064300002 | ||||
FITCH, William | Director | Foxhall 19 Broomhill Park BT9 6JB Belfast Antrim | British | Company Director | 49478560001 | |||||
GRAHAM, Donald Cameron | Director | 152 Eastwoodmains Road Clarkston G76 7HF Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Finance Director | 26178630002 | ||||
HAMMOND, Timothy Richard William | Director | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | England | British | Company Director | 205777760001 | ||||
HEALY, Martin William Oliver | Director | 90 Victoria Street BS1 6DP Bristol C/O Mazars Llp | United Kingdom | Irish | Accountant | 134003120002 | ||||
HEYWOOD, Anthony George | Director | Harborough Hall Lane CO5 9UA Messing Harborough Hall Essex | England | British | Chief Executive | 131288260001 | ||||
HOW, Alistair Maxwell | Director | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | Director | 169139000001 | ||||
KAY, Dominic Jude | Director | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | United Kingdom | British | Solicitor | 145920530001 | ||||
MAXWELL, Barbara Ann | Director | 17 Crieff Road SW18 2EB London | Irish | Company Director | 41693200001 | |||||
MITCHELL, Nicholas John | Director | Lymbrook 53 Dore Road Dore S17 3NA Sheffield South Yorkshire | Great Britain | British | Director | 145102120001 | ||||
MURPHY, John | Director | 21 Montgreenan View KA13 7NL Kilwinning Ayrshire | British | Managing Director | 26177180002 | |||||
O'REILLY, Michael Patrick | Director | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | Director | 40241900001 | ||||
ROYSTON, Maureen Claire, Dr | Director | 90 Victoria Street BS1 6DP Bristol C/O Mazars Llp | United Kingdom | British | Company Director | 184190020002 | ||||
SCOTT, Philip Henry | Director | Garden View 5a Pelling Hill SL4 2LL Old Windsor Berkshire | Irish | Managing Director | 80396000001 | |||||
SIZER, Graham Kevin | Director | Woodburn Patrick Brompton DL8 1JN Bedale North Yorkshire | British | Chartered Accountant | 77274540002 | |||||
SMITH, Ian Richard | Director | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | Company Director | 181082310001 | ||||
TABERNER, Benjamin Robert | Director | 90 Victoria Street BS1 6DP Bristol C/O Mazars Llp | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 150511890001 | ||||
TALBOT-MARTIN, David Robert | Director | 3 Chartwell Place KT18 5JH Epsom Surrey | British | Finance Director | 56941360001 | |||||
WILLIS, Graeme | Director | 3 Carrwood Road SK9 5DJ Wilmslow Cheshire | British | Finance Director | 71527500002 | |||||
MD DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | 70 Wellington Street G2 6SB Glasgow Pacific House | 900005100001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de RINGDANE LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elli Finance (Uk) Plc | 06 abr 2016 | Suite 3 Regency House 91 Western Road BN1 2NW Brighton C/O Alvarez & Marsal Europe Llp United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Four Seasons Health Care Group Limited | 06 abr 2016 | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene RINGDANE LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A security deed | Creado el 30 oct 2006 Entregado el 17 nov 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 17 may 1999 Entregado el 28 may 1999 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease dated 14TH april and 17TH may 1999 ("the lease") and all other liabilities incurred by the company to the chargee under the lease and all other monies and liabilities payable or to be payable under or pursuant to any of the clauses of the charge | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on the 28TH may 1999 | Creado el 14 may 1999 Entregado el 05 jun 1999 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descripción Leasehold interest in havencourt nursing home stonehaven. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 31 mar 1998 Entregado el 21 abr 1998 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date | |
Breve descripción Property charged being coventry beaumont nursing home 56 kenilworth road coventry t/no;-WM321229, south park 1 and south park ii nursing homes gale lane acomb york t/no's;-NYK111658 and NYK113035 south quay I and south quay ii nursing homes cowpen road blyth ND73211 and ND72660 south bebside nursing home patterdale road blyth northumberland ND53158, ringshill nursing home sallowbush road huntingdon cambridgeshire, dane house beaumont nursing home 52 dyke road brighton ESX18133 and cameron HOUSE2 cameron street elton bury gm 517590. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 20 mar 1997 Entregado el 08 abr 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a lease of even date | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 20 mar 1997 Entregado el 08 abr 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a lease of even date | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene RINGDANE LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| En administración |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0