READING ROOM LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | READING ROOM LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03280127 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de READING ROOM LIMITED?
- Desarrollo de software para negocios y hogares (62012) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra READING ROOM LIMITED?
| Dirección de la sede social | 2nd Floor Waterside 1310 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de READING ROOM LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para READING ROOM LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas no auditadas abreviadas presentadas hasta el 31 mar 2018 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Comptes modifiés pour une société dormante établis au 31 mar 2017 | 16 páginas | AAMD | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew John Riley como director el 03 mar 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew John Riley como director el 03 mar 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Miss Jane Mackie como director el 23 ene 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas no auditadas abreviadas presentadas hasta el 31 mar 2017 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 nov 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2016 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 nov 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Graham Quinton Kellett-Clarke como director el 09 nov 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2015 | 27 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 nov 2015 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 10 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Charles Burgess como director el 07 oct 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sarah Vick como director el 07 oct 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jane Elizabeth Vinson como director el 07 oct 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Mark Usher como director el 07 oct 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Tom Hempenstall como director el 07 oct 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Margaret Ann Manning como director el 07 oct 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Adam Philip David Portlock como secretario el 07 oct 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Jane Mackie como secretario el 07 oct 2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de READING ROOM LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACKIE, Jane | Secretario | 95 Bothwell Street G2 7JZ Glasgow Idox, 7th Floor Scotland | 201667150001 | |||||||
| MACKIE, Jane | Director | Waterside 1310 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor | Scotland | British | 242347680001 | |||||
| MANNING, Margaret Ann | Secretario | 127 Caribbean 46 Keppel Bay Drive 098635 Keppel Bay #10 Singapore Singapore | British | 50411660005 | ||||||
| PORTLOCK, Adam Philip David | Secretario | Waterside 1310 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor England | 182192830001 | |||||||
| BRIGHTON SECRETARY LIMITED | Secretario designado corporativo | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex | 900004700001 | |||||||
| ANDERSON, David Colin | Director | 4 Grass Yard Kimbolton PE18 0HQ Huntingdon Cambridgeshire | British | 62161260001 | ||||||
| BERGIN, Joseph Damien | Director | Springwood House Davey Lane SK9 7NZ Alderley Edge Cheshire | United Kingdom | British | 113935400001 | |||||
| BRODE, Andrew Stephen | Director | Walkwood House 65 Burkes Road HP9 1PW Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 24654990006 | |||||
| BURGESS, David Charles | Director | Waterside 1310 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor England | United Kingdom | British | 118238760003 | |||||
| BURKE, Scott Lee | Director | Flat 3 28 Underhill Road Dulwich SE22 0AH London | British | 105259580001 | ||||||
| CACKETT, Paul | Director | 63 Ufton Road N1 4HE London | British | 78417590002 | ||||||
| COPPING, Richard John Alan | Director | 15 Osier Close CB7 4AY Ely Cambridgeshire | British | 78417910002 | ||||||
| CROUCHER, Kristian | Director | Bayfield Drive Burwell CB2 0NU Cambridge 8 Cb25 0je England | England | British | 100949100003 | |||||
| DAVIS, Neil Alan | Director | 12 Hunters Way Cippenham SL1 5UB Slough Berkshire | British | 112814980001 | ||||||
| DINNICK, Richard | Director | 153 Ravenslea Road SW12 8RT London | England | British | 69024950001 | |||||
| DRURY, Stefan | Director | Flat 1 210 Tufnell Park Road Tufnell Park N7 0PZ London | British | 78417970001 | ||||||
| HEMPENSTALL, Tom | Director | The Thatchway Angmering BN16 4HJ Littlehampton Glenelg West Sussex England | United Kingdom | British | 190152240001 | |||||
| HORSMAN, Stephen John | Director | 6 Henley House Friern Park N12 9UE London | British | 57116520002 | ||||||
| JONES, Philip Joseph | Director | Flat 8 23-24 Great James Street Bloomsbury WC1N 3ES London | United Kingdom | British | 97434300002 | |||||
| KELLETT-CLARKE, Richard Graham Quinton | Director | Waterside 1310 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor England | England | British | 138013280002 | |||||
| MANNING, Margaret Ann | Director | 127 Caribbean 46 Keppel Bay Drive 098635 Keppel Bay #10 Singapore Singapore | Singapore | British | 50411660006 | |||||
| MCQUEEN, Catherine Anne Maartje | Director | 144 Bayham Street NW1 0BA London | England | British | 67354000001 | |||||
| MCQUEEN, Johannes Herman Janzen | Director | 47 Barnton Avenue EH4 6JJ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 26088500001 | |||||
| MCQUEEN, Neil Alexander Max | Director | Drumveigh 47 Barnton Avenue EH4 6JJ Edinburgh Scotland | British | 67353980002 | ||||||
| PROCTER, Jane Hilary Elizabeth | Director | 20 Shrewsbury House Cheyne Walk SW3 5LN London | British | 78488480001 | ||||||
| RILEY, Andrew John | Director | Waterside 1310 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading 2nd Floor England | England | British | 199618290001 | |||||
| SCOTCHER, Philip Brett | Director | 32 Long Street GL8 8AQ Tetbury Gloucestershire | British | 63263900002 | ||||||
| SCOTCHER, Phillip | Director | 17a Bridgnorth Road DY7 6RP Stourton Stourbridge | British | 90524680001 | ||||||
| SEFTON, Adam | Director | 65-66 Frith Street London W1D 3JR | United Kingdom | British | 170514390001 | |||||
| SMITH, Jonathan | Director | 69 Berwick Street Soho W1F 8SZ London | British | 86229900001 | ||||||
| THOMAS, David Andrew | Director | Old Post Office Cottage Trap Street SK11 9EG Lower Withington Cheshire | United Kingdom | British | 127531730001 | |||||
| USHER, Simon Mark | Director | 127 Caribbean 46 Keppel Bay Drive Keppel Bay 098635 Singapore #10 Singapore | Singapore | British | 50411720006 | |||||
| VARY, Lorne Alan | Director | Southmont Road KT10 9BG Esher 14 Surrey United Kingdom | England | British | 139325690001 | |||||
| VICK, Sarah | Director | Whittell Gardens SE26 4LN London 46 England | England | British | 108117670002 | |||||
| VICK, Sarah | Director | Whittell Gardens SE26 4LN London 46 | England | British | 108117670002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de READING ROOM LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idox Plc | 19 nov 2016 | Arlington Business Park, Theale RG7 4SA Reading 1310 Waterside England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene READING ROOM LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 02 ago 2007 Entregado el 03 ago 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A rent deposit deed | Creado el 18 dic 2000 Entregado el 29 dic 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada An initial rent deposit of £38,995.31 together with all further monies due or to become due from the company to the chargee in accordance with charge 7 of the rent deposit deed | |
Breve descripción All monies deposited by the tenant and all monies due to the landlord under the terms of the deed. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 22 sept 2000 Entregado el 28 sept 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rental deposit agreement | Creado el 10 dic 1999 Entregado el 15 dic 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a lease of even date | |
Breve descripción The sum of £18,750 and any replacement sums. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0