PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED

PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPENN HOUSE PROPERTIES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03287110
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    • (7011) /
    • (7020) /

    ¿Dónde se encuentra PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    3rd Floor 5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CIVILEMPLOY LIMITED03 dic 199603 dic 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cambio de datos del director Christopher George White el 01 may 2010

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Maurice Moses Benady el 01 may 2010

    3 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 03 dic 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 feb 2010

    Estado de capital el 10 feb 2010

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cambio de datos del director Trafalgar Officers Limited el 03 dic 2009

    1 páginasCH02

    Cambio de datos del secretario Reit(Corporate Services) Limited el 03 dic 2009

    1 páginasCH04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2009

    5 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    1 páginas190

    legacy

    1 páginas287

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2008

    14 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    4 páginas288a

    legacy

    4 páginas288a

    Resoluciones

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Section 175 10/11/2008
    RES13
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    1 páginas190

    ¿Quiénes son los directivos de PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Secretario corporativo
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro3143222
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Director
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Director
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Director corporativo
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro6745658
    135316290001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    Secretario
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    British74688330002
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    Secretario
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Director
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish11296610002
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Director
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Director
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116927100001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish163838050001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British60687110001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Director corporativo
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    ¿Tiene PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 15 sept 2004
    Entregado el 29 sept 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of fixed charge the real property other than the real property listed in part ii of schedule 2 of the debenture; all plant and machinery etc. and all related property rights; all debts; all of its securities and intellectual property rights; all goodwill and uncalled capital; and the insurance policies and the insurance proceeds. By way of assignment the insurance policies and the insurance proceeds; all rental income; any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document; any hedging arrangements; each managing agent agreement; and each building contract and all related property rights. By way of first floating charge (I) the whole of its assets present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 29 sept 2004Registro de un cargo (395)
    Supplemental deed
    Creado el 30 oct 1997
    Entregado el 11 nov 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys and indebtedness due from and all moneys covenanted to be paid by any group member to norwich union mortgage finance limited as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 30 october 1997
    Breve descripción
    The properties listed below together with all buildings, erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon and all improvements and additions thereto and all easements, rights and licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases, underleases, tenancies, agreements to lease, rights, covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance. Land an buildings on the south west side of crown street manchester GM52341. L/h land and buildings on the west side of sidcup road and the north side of tilson road wythenshawe manchester LA328553.
    Personas con derecho
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transacciones
    • 11 nov 1997Registro de un cargo (395)
    • 18 ene 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge
    Creado el 22 ago 1997
    Entregado el 23 ago 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising under or in connection with a sale and purchase agreement dated 23RD december 1996 and on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a land and buildings on the south west side of crown street manchester and land on the south side of silvercroft street hulme t/nos: GM52341 and GM189836; l/h property k/a land and buildings on the west side of sidcup road and the north side of tilson road wythenshawe manchester t/no: LA328553 all fittings plant equipment machinery tools vehicles furniture and other tangible movable property including any items at the original property; any proceeds of any insurance of the original real property; and a fixed charge over the rental income of the borrower. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Canada Life Assurance Company
    Transacciones
    • 23 ago 1997Registro de un cargo (395)
    • 18 ene 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of legal charge
    Creado el 23 dic 1996
    Entregado el 09 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and any holding or subsidiary company or any other group member to the chargee (as trustee for itself and the other lenders) on any account whatsoever or in any manner whatsoever
    Breve descripción
    F/H land and premises on the west side of windsor bridge road bath north estate somerset AV81568 somerset hall somerset street bath AV33403 and AV33404 and AV184057 and all buildings and erections and by way of floating charge all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transacciones
    • 09 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 19 feb 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 23 dic 1996
    Entregado el 04 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a sale and purchase agreement between the company the chargee and estates & general PLC dated 23RD december 1996 on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a 13/15 old steine and 1A/1B st. James' street brighton t/n: ESX21909; l/h property k/a land and buildings on the south west side of crown street manchester and land on south side of silvercroft street hulme t/nos: GM52341 and GM189836 and other properties referred to in schedule together with all fittings plant equipment machinery tools vehicles furniture and other tangible movable property, its goodwill and uncalled capital floating charge over the undertaking and property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Canada Life Assurance Company
    Transacciones
    • 04 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 18 ene 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0