GNS PROPERTY SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GNS PROPERTY SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03296707 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 2 Crown Way NN10 6BS Rushden England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 nov 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Terry Morris como director el 01 dic 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 28 feb 2017 au 31 dic 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 nov 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 feb 2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Dreier como director el 10 nov 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Dave Lissy como director el 10 nov 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Elizabeth Boland como director el 10 nov 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Kramer como secretario el 10 nov 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Walter Tugendhat como director el 10 nov 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Company Secretary Asquith House 34 Germain Street Chesham Buckinghamshire HP5 1LH a 2 Crown Way Rushden NN10 6BS el 14 nov 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Adam David Sage como secretario el 10 nov 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 nov 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 nov 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2014 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 nov 2013 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * C/O Company Secretary Asquith House 34 Germain Street Chesham Bucks HP5 1SJ England* el 11 dic 2012 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 nov 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAMER, Stephen | Secretario | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 England | 218500000001 | |||||||
| BOLAND, Elizabeth | Director | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 England | United States | American | 70853820001 | |||||
| DREIER, Stephen | Director | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 England | United States | American | 211308080001 | |||||
| LISSY, Dave | Director | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 England | United States | American | 218331690001 | |||||
| TUGENDHAT, James Walter | Director | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 England | United Kingdom | British | 218306870001 | |||||
| ALLY, Bibi Rahima | Secretario | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | British | 38963210003 | ||||||
| AUGHTERSON, Peter William | Secretario | Farley Hill House Church Lane RG7 1UP Farley Hill Berkshire | British Australian | 37698830004 | ||||||
| BROWNE, Lorna Barrington | Secretario | 26 Hallmead Road SM1 1RP Sutton Surrey | British | 42236390001 | ||||||
| BUXTON-SMITH, Maria Rita | Secretario | 1 Whitsun Pasture Willen Park MK15 9DQ Milton Keynes Buckinghamshire | British | 39442340001 | ||||||
| FAIRHURST, Russell William | Secretario | Flat 1 Elaine Court 123 Haverstock Hill NW3 4RT London | British | 44556020002 | ||||||
| HENDRIE, Neal Malcolm | Secretario | 74 The Drive UB10 8AQ Uxbridge Middlesex | British | 40848270002 | ||||||
| SAGE, Adam David | Secretario | c/o Company Secretary 34 Germain Street HP5 1LH Chesham Asquith House Buckinghamshire United Kingdom | 156315510001 | |||||||
| YARROW, Nicholas John | Secretario | Chiltern View, 27 Cobbetts Ride HP23 4BZ Tring Hertfordshire | British | 127478700001 | ||||||
| AUGHTERSON, Peter William | Director | Farley Hill House Church Lane RG7 1UP Farley Hill Berkshire | British Australian | 37698830004 | ||||||
| CLARKE, James | Director | Jade Place Wendover Road HP17 0TU Butlers Cross Buckinghamshire | British | 84641000001 | ||||||
| COLLETT, Brian | Director | 254 Old Church Road Chingford E4 8BT London | British | 32267100002 | ||||||
| FORD, Russell Mark | Director | Elm Field House Moreton OX9 2HS Thame South Oxfordshire | United Kingdom | British | 108597900005 | |||||
| HENDRIE, Neal Malcolm | Director | 74 The Drive UB10 8AQ Uxbridge Middlesex | England | British | 40848270002 | |||||
| MORRIS, Andrew Terry | Director | The Kiln Malthouse Close Ashbury SN6 8LN Swindon Wiltshire | England | British | 123609540001 | |||||
| PHILLIPS, Mark Randall | Director | Scotts Cottage Scots Lane MK18 2HX Adstock Buckinghamshire | United Kingdom | British | 80508130001 | |||||
| PHILPOTT, Stephen John Randall | Director | St John's Cottage Cherry Tree Lane SL3 6JE Fulmer Berkshire | United Kingdom | British | 45243130001 | |||||
| RHODES, Phillip Baverstock | Director | 12 Peterborough Villas SW6 2AT London | United Kingdom | British | 103078920001 | |||||
| RING, Ronald Arthur | Director | 7 Georgian Close Abbeydale GL4 5DG Gloucester Gloucestershire | United Kingdom | British | 52543770001 | |||||
| SAGE, Adam David | Director | Orbital House Park View Road HP4 3EY Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 216961780001 | |||||
| YARROW, Nicholas John | Director | Chiltern View, 27 Cobbetts Ride HP23 4BZ Tring Hertfordshire | England | British | 127478700001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asquith Court Holdings Limited | 30 nov 2016 | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
¿Tiene GNS PROPERTY SERVICES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 11 jun 2002 Entregado el 21 jun 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| By a security accession deed between the company, chestnutbay limited (the "parent") and dresdner bank ag, london branch (the "security agent") the company acceded to a debenture dated 10 may 2001, between inter alia, the parent and the security agent | Creado el 10 may 2001 Entregado el 23 may 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies or liabilities due, owing or incurred to any secured party by any charging company or any other obligor at present or in the future, including all liabilities in connection with any notes, bills or other instruments accepted by any secured party for or at the request of an obligor and all losses incurred by any secured party in connection therewith (all terms as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 07 jun 1999 Entregado el 17 jun 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Plot 4, south east of cloverfield hinkley leicestershire t/n LT228396, land on the south of milford road walton on the hill staffordshire t/n SF301213 and land lying to the north of lowry road west ardsley west yorkshire t/n WYK506006. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 07 jun 1999 Entregado el 10 jun 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0