CAPE CALSIL INTERNATIONAL LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | CAPE CALSIL INTERNATIONAL LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03299540 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CAPE CALSIL INTERNATIONAL LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra CAPE CALSIL INTERNATIONAL LIMITED?
Dirección de la sede social | Building 2, Fields End Business Park Davey Road Thurnscoe S63 0JF Goldthorpe Rotherham England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CAPE CALSIL INTERNATIONAL LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
CAPE MANUFACTURING INTERNATIONAL LIMITED | 02 abr 1998 | 02 abr 1998 |
DEALCLEAN LIMITED | 07 ene 1997 | 07 ene 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CAPE CALSIL INTERNATIONAL LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 ago 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CAPE CALSIL INTERNATIONAL LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 ene 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2020 | 12 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 ene 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2019 | 12 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 ene 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Padraig Somers como director el 27 jun 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Cape Admin 1 Limited como director el 27 jun 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2018 | 12 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Cape Admin 1 Limited el 04 feb 2019 | 1 páginas | CH02 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Drayton Hall Church Road West Drayton Middlesex England UB7 7PS a Building 2, Fields End Business Park Davey Road Thurnscoe Goldthorpe Rotherham S63 0JF el 30 ene 2019 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 ene 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Cape Calsil Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 15 páginas | AA | ||
Exercice comptable en cours raccourci du 31 dic 2018 au 31 ago 2018 | 1 páginas | AA01 | ||
Nombramiento de Cape Admin 1 Limited como director el 25 may 2018 | 3 páginas | AP02 | ||
Cese del nombramiento de Mark Hooper como director el 25 may 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Mr John Anthony Meade Walsh el 08 feb 2018 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 ene 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr John Anthony Meade Walsh como director el 31 ene 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Victoria Anne George como director el 15 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 14 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de CAPE CALSIL INTERNATIONAL LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOMERS, Padraig | Director | Island Ganniv Greenville Listowel 3 Co. Kerry Ireland | Ireland | Irish | Director | 259818620001 | ||||||||
WALSH, John Anthony Meade | Director | Davey Road Thurnscoe S63 0JF Goldthorpe Building 2, Fields End Business Park Rotherham England | United Kingdom | British | Uk Finance Director | 238138720001 | ||||||||
ALLAN, Richard Friend | Secretario | Drayton Hall Church Road UB7 7PS West Drayton Cape Intermediate Holdings Plc Middlesex United Kingdom | 181728690001 | |||||||||||
CRAIGIE, Claire Louise | Secretario | 15 Marlborough Square LS29 8PU Ilkley West Yorkshire | British | Company Secretary | 82905830001 | |||||||||
GORMAN, Jeremy Philip | Secretario | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | 160675810001 | |||||||||||
JUDD, Christopher Francis | Secretario | Millenia Tower One Temasek Avenue 039192 Singapore #09-03 Singapore | 169527740001 | |||||||||||
PITT-PAYNE, Michael George | Secretario | 18 Church Way Stone HP17 8RG Aylesbury Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 829660002 | |||||||||
RHODES, Jeremy | Secretario | Grevel Lane GL55 6HS Chipping Campden Kelmscott Gloucestershire | British | 129206660001 | ||||||||||
SMITH, Stephen Harry | Secretario | 17 Wilhelmina Avenue CR5 1NL Coulsdon Surrey | British | Company Secretary | 64449570001 | |||||||||
TURNER, Lucy Finch | Secretario | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | British | 133976740001 | ||||||||||
WHITWORTH, Benjamin Warwick | Secretario | Raskelf YO61 3LW York Sam House Farm | British | Solicitor | 99402260002 | |||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
ALLAN, Richard Friend | Director | Drayton Hall Church Road UB7 7PS West Drayton Cape Intermediate Holdings Plc Middlesex United Kingdom | England | British | Company Secretary | 183409640001 | ||||||||
AMEY, Rachel Nancye | Director | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 133976650005 | ||||||||
BINGHAM, Richard Keith | Director | Church Road Brasted TN16 1HZ Westerham Beechcroft Kent | British | Accountant | 131046090001 | |||||||||
CARTWRIGHT, Paul Ian | Director | 195 Highbury Quadrant N5 2TE London | British | Chartered Accountant | 40873830002 | |||||||||
CRAIGIE, Claire Louise | Director | 15 Marlborough Square LS29 8PU Ilkley West Yorkshire | British | Company Secretary | 82905830001 | |||||||||
DUPONT, Louis Ferdinand Marie | Director | 36 Rue Des Sablons Herblay 95120 France | French | Director/General Manager | 61572530001 | |||||||||
FLYNN, David Francis | Director | Tamia Ridge Diamond Hill GU15 4LE Camberley Surrey | British | Company Director | 37405900001 | |||||||||
GAUNTLEY, Simon Paul | Director | 6 Butlers Court Road HP9 1SF Beaconsfield Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 59315600001 | |||||||||
GEORGE, Victoria Anne | Director | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Tax Adviser | 134024500001 | ||||||||
GILLESPIE, Andrew James | Director | 5 White Moss Close Ackworth WF7 7QT Pontefract West Yorkshire | England | British | Chartered Accountant | 89560440001 | ||||||||
HOOPER, Mark | Director | Church Road West Drayton UB7 7PS Middlesex Drayton Hall England England | United Kingdom | British | Company Director | 183414240001 | ||||||||
MORTON, Peter | Director | Fairview Marston Hill Oving HP22 4HB Aylesbury Buckinghamshire | England | British | Chemical Engineer | 54495130001 | ||||||||
PITT-PAYNE, Michael George | Director | 18 Church Way Stone HP17 8RG Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 829660002 | ||||||||
SKIPP, Richard John | Director | Church Road West Drayton UB7 7PS Middlesex Drayton Hall England England | England | British | Company Director | 164010970001 | ||||||||
SKIPP, Richard John | Director | Church Road West Drayton UB7 7PS Middlesex Drayton Hall England England | England | British | Company Director | 164010970001 | ||||||||
SMITH, Stephen Harry | Director | 17 Wilhelmina Avenue CR5 1NL Coulsdon Surrey | British | Company Secretary | 64449570001 | |||||||||
STEVENSON, John David Oswald | Director | 89 Tarrant Street BN18 9DN Arundel West Sussex | British | Company Director | 71850830001 | |||||||||
WHITWORTH, Benjamin Warwick | Director | Raskelf YO61 3LW York Sam House Farm | England | British | Solicitor | 99402260002 | ||||||||
WIDDOWSON, Ian Richard | Director | 49 Eghams Wood Road HP9 1JX Beaconsfield Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 16941000001 | |||||||||
WILLIAMS, Glyn Rees | Director | 12 Greenway Manor Park SG6 3UG Letchworth Hertfordshire | British | Accountant | 38897320001 | |||||||||
ZILLEN, Joachim Thomas | Director | Heidedyke 49 Krefeld 47802 Germany | German | Manager | 66382830001 | |||||||||
CAPE ADMIN 1 LIMITED | Director corporativo | Davey Road Thurnscoe S63 0JF Goldthorpe Building 2 Rotherham United Kingdom |
| 194285370001 | ||||||||||
CAPE CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Director corporativo | Red Hall Avenue WF1 2UL Wakefield Cape House, 3 West Yorkshire United Kingdom | 131421100001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CAPE CALSIL INTERNATIONAL LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Calsil Group Limited | 06 abr 2016 | Church Road UB7 7PS West Drayton Drayton Hall Middlesex United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene CAPE CALSIL INTERNATIONAL LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating security document | Creado el 20 jul 2001 Entregado el 26 jul 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any creditor (as defined) | |
Breve descripción Freehold properties,(i) palmers moor and woodlands park,iver lane,iver,bucks;SGL49469;(ii)botleybrickworks,leyhill,chesham,bucks; (iii) cowley bridge works,iver lane,uxbridge UB8 2JQ; agl 60617 and ag 60620 plus various other properties listed;and all real property,as defined, listed in schedule 6 of the security document and by way of first fixed charge over all its book debts,bank accounts,investments and dividends,uncalled capital and goodwill,intellectual property,plant,machinery,insurances and all related proceeds; floating charge over the undertaking and all assets present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0