CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD

CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03302431
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?

    • Educación preescolar (85100) / Educación

    ¿Dónde se encuentra CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?

    Dirección de la sede social
    2 Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    Northamptonshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HATTON HILL DAY NURSERY LIMITED 04 mar 199704 mar 1997
    128 QUARRY STREET LIMITED14 ene 199714 ene 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 02 dic 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 dic 2015

    Estado de capital el 17 dic 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 18 nov 2015

    • Capital: GBP 100
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Share premium account be cancelled 03/11/2015
    RES13

    Cese del nombramiento de Mary Ann Tocio como director el 01 jun 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 ene 2015

    Estado de capital el 22 ene 2015

    • Capital: GBP 104
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    10 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 feb 2014

    Estado de capital el 06 feb 2014

    • Capital: GBP 104
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    10 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Stephen Kramer como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Stephen Dreier como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    12 páginasAA

    Nombramiento de Stephen Dreier como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Elizabeth Boland como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de David Lissy como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mary Ann Tocio como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Ussy como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mary Tocio como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Elizabeth Boland como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KRAMER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Secretario
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    171973630001
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican70853820001
    DREIER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican170443250001
    LISSY, Dave
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican218331690001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secretario
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British68848420004
    HAYNES, David Charles
    9 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    Secretario
    9 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    British27595320001
    HERRINGTON, Denise Elaine
    8 Springfield Crescent
    RH12 2PP Horsham
    West Sussex
    Secretario
    8 Springfield Crescent
    RH12 2PP Horsham
    West Sussex
    British39340000001
    HURRAN, Anthony Robert
    10 St Marks Road
    Ealing
    W5 3JS London
    Secretario
    10 St Marks Road
    Ealing
    W5 3JS London
    British104970440001
    KRAMER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Secretario
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    British169843310001
    MOORE, Matthew Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secretario
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British134350220001
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    United StatesAmerican70853820001
    BROSNAN, Paul
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Director
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomIrish102089360002
    BULL, Malcolm Richard
    Verlands Pond Road
    GU22 0JY Woking
    Surrey
    Director
    Verlands Pond Road
    GU22 0JY Woking
    Surrey
    EnglandBritish10155680001
    CARNEY, Joseph Gerard
    272 Gunnersbury Avenue
    W4 5QB London
    Suite 2 Chiswick Place
    Director
    272 Gunnersbury Avenue
    W4 5QB London
    Suite 2 Chiswick Place
    United KingdomIrish89273480001
    DREIER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    United StatesAmerican170443250001
    GOODYEAR, Christine
    Grafton House
    Bentley
    GU10 5HY Farnham
    7 Hatchford Manor
    Surrey
    Director
    Grafton House
    Bentley
    GU10 5HY Farnham
    7 Hatchford Manor
    Surrey
    EnglandBritish38722410001
    HAYNES, David Charles
    9 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    Director
    9 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    British27595320001
    HERRINGTON, Denise Elaine
    8 Springfield Crescent
    RH12 2PP Horsham
    West Sussex
    Director
    8 Springfield Crescent
    RH12 2PP Horsham
    West Sussex
    British39340000001
    HURRAN, Anthony Robert
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Director
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandBritish184743670001
    LEWIS, David
    78 Macdonald Road
    GU18 5XY Lightwater
    Surrey
    Director
    78 Macdonald Road
    GU18 5XY Lightwater
    Surrey
    British51773710002
    MALCOLMSON, John Bryce
    2 Mahonia Close
    West End
    GU24 9NX Woking
    Surrey
    Director
    2 Mahonia Close
    West End
    GU24 9NX Woking
    Surrey
    British51773690002
    MOORE, Matthew Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Director
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritish115340530001
    TICE, Richard James Sunley
    Old Rectory
    Church Lane Lathbury
    MK16 8JY Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Director
    Old Rectory
    Church Lane Lathbury
    MK16 8JY Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish151240670006
    TOCIO, Mary Ann
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    UsaUsa177507090001
    TOCIO, Mary Ann
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    UsaUsa177507090001
    USSY, David
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    UsaUsa169819280001
    WHITLAM, Paul
    Millmoor 18 Drayhorse Drive
    GU19 5RF Bagshot
    Surrey
    Director
    Millmoor 18 Drayhorse Drive
    GU19 5RF Bagshot
    Surrey
    British47737380001

    ¿Tiene CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Accession deed to intercreditor deed
    Creado el 06 jun 2005
    Entregado el 16 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any group company to any finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The company agrees to become a party to and be bound by the intercreditor deed as an obligor, will upon demand by the security trustee pay an amount equal to the amount of all payments or distributions of or in respect of any junior liablities in cash or in kind;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Thefinance Parties
    Transacciones
    • 16 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 07 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security accession deed
    Creado el 06 jun 2005
    Entregado el 16 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to any finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    1) l/h property k/a the old toll house and the new toll house, sandown park, esher, surrey, 2) l/h property k/a the green, frimley green, surrey GU16 6HF, 3) l/h property k/a rushmoor independent school, 40 reading road, farnborough, see form 395 for other properties charged; and any interest in any other land, all shares and all related distribution rights;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Thefinance Parties
    Transacciones
    • 16 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 07 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 27 ene 2003
    Entregado el 08 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a hatton hill day nursery 40 reading road farnborough hampshire GU14 6NB. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 08 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 27 ene 2003
    Entregado el 08 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a hatton hill day nursery 1 the green frimley green camberley surrey GU16 6HF. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 08 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 nov 2002
    Entregado el 17 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that leasehold property known as hatton hill day nursery hatton hill windlesham surrey. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 nov 2002
    Entregado el 17 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that leashold property known as land and premises situate at and known at the old toll house and the new toll house sandown park surrey. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 17 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 nov 2002
    Entregado el 17 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0