CHORLTON CLOUGHLEY GROUP LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CHORLTON CLOUGHLEY GROUP LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03305013 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CHORLTON CLOUGHLEY GROUP LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra CHORLTON CLOUGHLEY GROUP LIMITED?
| Dirección de la sede social | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CHORLTON CLOUGHLEY GROUP LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| REQUESTPHASE LIMITED | 21 ene 1997 | 21 ene 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CHORLTON CLOUGHLEY GROUP LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CHORLTON CLOUGHLEY GROUP LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Stephen Mugge como director el 02 mar 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 6 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 nov 2019 | 6 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 nov 2018 | 6 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Tower Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN a 15 Canada Square London E14 5GL el 15 dic 2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 2 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Christopher Ross como director el 20 dic 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Jacqueline Anne Gregory como secretario el 20 dic 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jennifer Owens como secretario el 01 mar 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 ene 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Mark Stephen Mugge el 25 nov 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Stephen Mugge como director el 11 sept 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Scott Egan como director el 14 sept 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Peter Rea como director el 16 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Renuncia del auditor | 2 páginas | AUD | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 ene 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Steven Hodges como director el 17 oct 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CHORLTON CLOUGHLEY GROUP LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREGORY, Jacqueline Anne | Secretario | Canada Square E14 5GL London 15 | 221961730001 | |||||||
| ROSS, David Christopher | Director | Canada Square E14 5GL London 15 | United Kingdom | Irish | 222326970001 | |||||
| CLARK, Samuel Thomas Budgen | Secretario | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | British | 117669700002 | ||||||
| MC GROGGAN, Francis | Secretario | The Chestnuts 48 Wardle Road M33 3DH Sale Cheshire | Irish | 55775370001 | ||||||
| OWENS, Jennifer | Secretario | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | 183283410001 | |||||||
| BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001550001 | |||||||
| AINSBURY, Barry Dennis | Director | 37 Park Road Disley SK12 2LX Stockport Cheshire | British | 1723230001 | ||||||
| BARR, Graham Maxwell | Director | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | United Kingdom | British | 125097020001 | |||||
| BRADBURY, John Reginald | Director | 23 Belvedere Avenue Greenmount BL8 4ED Bury Lancashire | Uk | British | 9249680001 | |||||
| BROWN, Roger Michael | Director | Staceys Street ME14 1ST Maidstone 2 County Gate Kent | England | British | 134140540001 | |||||
| BRUCE, David James | Director | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | United Kingdom | British | 171398800001 | |||||
| CLARK, Samuel Thomas Budgen | Director | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | England | British | 149939610001 | |||||
| DOLAN, Joseph Gerard | Director | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | England | Irish | 70918260002 | |||||
| EGAN, Scott | Director | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | England | British | 170703910001 | |||||
| HODGES, Mark Steven | Director | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | United Kingdom | British | 58444370003 | |||||
| JOHNSON, Timothy David | Director | The Green Westerham TN16 1AS Kent Nursery Cottage 3a | England | British | 129538180001 | |||||
| KELLS, Ian William Elliott | Director | Staceys Street ME14 1ST Maidstone 2 County Gate Kent | England | British | 120974010001 | |||||
| MALONEY, William Francis | Director | Staceys Street ME14 1ST Maidstone 2 County Gate Kent | England | Irish | 11863380006 | |||||
| MC GROGGAN, Francis | Director | Staceys Street ME14 1ST Maidstone 2 County Gate Kent | United Kingdom | Irish | 55775370001 | |||||
| MUGGE, Mark Stephen | Director | Canada Square E14 5GL London 15 | England | British | 162920630005 | |||||
| PARK, Bryan | Director | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | England | British | 113694470002 | |||||
| REA, Michael Peter | Director | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | England | British | 147194830001 | |||||
| STOLL, Peter David | Director | Bunkers Retreat 26 Wentworth Avenue Whitefield M45 7GQ Manchester Lancashire | British | 104728850001 | ||||||
| DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED | Director designado corporativo | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001540001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CHORLTON CLOUGHLEY GROUP LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawson Pennington & Company Limited | 06 abr 2016 | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CHORLTON CLOUGHLEY GROUP LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 14 sept 2010 Entregado el 18 sept 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of accession to a debenture | Creado el 28 abr 2008 Entregado el 03 may 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene CHORLTON CLOUGHLEY GROUP LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0