PCV HP NOMINEE LIMITED

PCV HP NOMINEE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPCV HP NOMINEE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03309232
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PCV HP NOMINEE LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra PCV HP NOMINEE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PCV HP NOMINEE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    FREEHOLD PORTFOLIOS HP NOMINEE LIMITED23 ene 199723 ene 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PCV HP NOMINEE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PCV HP NOMINEE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 22 sept 2018

    6 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 22 sept 2017

    6 páginasLIQ03

    Presentación de insolvencia

    Insolvency:secretary of state's release of liquidator
    1 páginasLIQ MISC

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 22 sept 2016

    4 páginas4.68

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Orden judicial de insolvencia

    Court order insolvency:court order - removal/ replacement of liquidator
    30 páginasLIQ MISC OC

    Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario

    1 páginas4.40

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 22 sept 2015

    4 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB a 15 Canada Square London E14 5GL el 17 oct 2015

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ a 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB el 16 oct 2014

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    7 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 23 sept 2014

    LRESSP

    Déclaration annuelle établie au 08 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 ene 2014

    Estado de capital el 08 ene 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 08 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Cambio de datos del director Mr Nicholas Mark Leslau el 17 sept 2012

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Nicholas Mark Leslau el 17 sept 2012

    2 páginasCH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2011

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 08 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    6 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de PCV HP NOMINEE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Secretario
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Australian57113450003
    GROSE, David Leonard
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Cavendish House
    Director
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Cavendish House
    United KingdomBritish120479020002
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Director
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandAustralian57113450003
    LESLAU, Nicholas Mark
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Director
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritish6815470021
    MOUSLEY, Emily Ann
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    Director
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    United KingdomBritish155262770001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretario designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    LINEOBTAIN LIMITED
    Mountcliff House
    154 Brent Street
    NW4 2DR London
    Secretario corporativo
    Mountcliff House
    154 Brent Street
    NW4 2DR London
    87536870003
    BRADY, James Michael
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    Director
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish3769730001
    BURROWES, David William
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    Director
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    United KingdomBritish100504300001
    EAST, Stephen John
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    Director
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    EnglandBritish108586450001
    EVANS, Alasdair David
    8 Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Treaton Mill
    Surrey
    Director
    8 Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Treaton Mill
    Surrey
    United KingdomBritish130019430001
    HARROLD, Richard Anthony
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    Director
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    British33048780001
    LEWIS, Gavin Andrew
    10 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    Director
    10 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    British93017010002
    RITBLAT, James William Jeremy
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    Director
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    EnglandBritish38424950003
    WAGMAN, Colin Barry
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    Director
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    United KingdomBritish39329840001
    WARE, Robert Thomas Ernest
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    Director
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    United KingdomBritish4779170003
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Director designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    ¿Tiene PCV HP NOMINEE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental debenture
    Creado el 28 mar 2003
    Entregado el 15 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All shares held by the company and/or any nominee on it's behalf and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft London Branch,(As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transacciones
    • 15 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 11 oct 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 30 jul 2001
    Entregado el 02 ago 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party under each finance document (all terms as defined)
    Breve descripción
    All that f/h land k/a 35 broad street and 29-31 queen victoria street,reading title absolute under t/n BK115467. For further details of all property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, as Agent and Trustee Tothe Finance Parties (The Agent)
    Transacciones
    • 02 ago 2001Registro de un cargo (395)
    • 11 oct 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 18TH february 2000 and
    Creado el 09 feb 2000
    Entregado el 29 feb 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company (formerly known as freehold portfolios hp nominee limited) and/or any other obligor to each senior finance party under each senior finance document or each mezzanine finance party under each mezzanine finance document
    Breve descripción
    All and whole those shop premises with ancillary office accommodation on the basement, ground and first floors in the burgh of falkirk and county of stirling now k/a numbers 118 to 120 high street falkirk t/no STG10222. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank as Agent and Trusteefor Itself and the Other Finance Parties (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 29 feb 2000Registro de un cargo (395)
    • 02 ago 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture between the company (formerly known as freehold portfolios hp nominee limited) each chargor and the security trustee
    Creado el 09 feb 2000
    Entregado el 21 feb 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities whather actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to a). Each senior finance party under each senior finance document; or b). Each mezzanine finance party under each mezzanine finance document except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985.
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutchen Bank, London Branch(As Agent and Trustee for the Senior Finance Parties and the Mezzanine Finance Parties)
    Transacciones
    • 21 feb 2000Registro de un cargo (395)
    • 15 ago 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignation of rents
    Creado el 09 feb 2000
    Entregado el 19 feb 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to each senior finance party under each senior finance document or each mazzanine finance party under each mezzanine finance document (all defined therein)
    Breve descripción
    Right, title and interest in and to the rental income in respect of the subjects (as defined).
    Personas con derecho
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank, London Branch, Asagent and Trustee for Itself and the Other Finance Parties ("the Security Trustee")
    Transacciones
    • 19 feb 2000Registro de un cargo (395)
    • 02 ago 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A standard security dated 05 july 1999 which was registered in scotland on 12 july 1999
    Creado el 12 jul 1999
    Entregado el 28 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or each other borrower to the agent as lender, agent one of the arrangers and original counterparty and its successors and assignees whomsoever and to each other finance party under or pursuant to a credit agreement dated 05 july 1999
    Breve descripción
    Property k/a numbers one hundred and eighteen to one hundred and twenty high street falkirk t/n stg 10222.
    Personas con derecho
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and the Other Financeparties
    Transacciones
    • 28 jul 1999Registro de un cargo (395)
    • 16 feb 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignation of rents
    Creado el 07 jul 1999
    Entregado el 15 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The companys right, title and interest in and to the rental income (as defined in the credit agreement).
    Personas con derecho
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transacciones
    • 15 jul 1999Registro de un cargo (395)
    • 16 feb 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 05 jul 1999
    Entregado el 20 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies whatsoever due or to become due from each borrower (as defined) and fp financial to each finance party (as defined) under each finance document (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft,London Branch,as Agent and Trustee for Thefinance Parties
    Transacciones
    • 20 jul 1999Registro de un cargo (395)
    • 16 feb 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignation of rents
    Creado el 14 ene 1999
    Entregado el 26 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations due or to become due from each borrower (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and the other finance parties (as defined in the credit agreement dated 21ST october 1998) under or pursuant to the credit agreement and any finance document referred to as such in the credit agreement
    Breve descripción
    The company's right title and interest in and to the rental income (as defined in the credit agreement) payable in respect of the leases of the subjects.
    Personas con derecho
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Ag
    Transacciones
    • 26 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 08 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 ene 1999
    Entregado el 19 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each borrower (as defined) to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined)under each finance document (as defined) and on any account whatsoever
    Breve descripción
    16 toll gavel beverley 33 parliament street york f/h property k/a 35 broad street and 29-31 queen victoria street reading t/nos: HS200862 NYK127042 BK115467 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branch
    Transacciones
    • 19 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 08 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 25 january 1999 and
    Creado el 05 ene 1999
    Entregado el 30 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or each other borrower (as defined) under or pursuant to a credit agreement dated 21 october 1998
    Breve descripción
    The property known as 118 to 120 high street falkirk title number STG10222.
    Personas con derecho
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and Theother Finance Parties ("Agent")
    Transacciones
    • 30 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 08 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of legal charge
    Creado el 04 feb 1997
    Entregado el 20 feb 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The properties being 189 high street, southend on sea-EX166546 and the other properties described on the schedule attached to the form M395 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants' fixtures) and fittings thereon, rights, licences, leases and a floating charge over the property, assets, rights and revenues including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transacciones
    • 20 feb 1997Registro de un cargo (395)
    • 27 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment by way of charge
    Creado el 04 feb 1997
    Entregado el 20 feb 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By clause 2 of the assignment all the right, titles, benefits and interests to all monies owing or incurred to the company under the occupational lease/s in respect of 189 high street, southend on sea-EX166546 and all the other properties described in the schedule attached to the form M395. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transacciones
    • 20 feb 1997Registro de un cargo (395)
    • 27 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene PCV HP NOMINEE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    01 feb 2019Fecha de disolución
    23 sept 2014Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Profesional
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0