STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED

STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSTILES HAROLD WILLIAMS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03311644
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?

    • Agencias inmobiliarias (68310) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CANNONGUARD LIMITED03 feb 199703 feb 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    16 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 mar 2017

    15 páginas4.68

    Memorándum y Estatutos

    26 páginasMA

    Domicilio social registrado cambiado de Venture House 27/29 Glasshouse Street London W1B 5DF a 2-3 Pavilion Buildings Brighton East Sussex BN1 1EE el 19 abr 2016

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 29 mar 2016

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de Mr Peter John Sharpe Turner como director el 04 mar 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Sarah Jean Webb como director el 04 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Carol Gillian Williams como director el 04 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Paul Garnett Wade como director el 04 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard James Turner como director el 04 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Peter John Sharpe Turner como director el 04 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Paul Kevin Spruce como director el 04 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark Stephen Skelton como director el 04 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Clive Richardson como director el 04 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Stephen Norton Ray como director el 04 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard William Antranik Pyne como director el 04 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard Neale Todd Plant como director el 04 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Niral Harshadbhai Patel como director el 04 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Robert Fredric Victor Perry como director el 04 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Niall Mcguinness como director el 04 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Haydon Lee Murton como director el 04 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark Scanlan Mcfadden como director el 04 mar 2016

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SCHOLEFIELD, Andrew
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2-3
    East Sussex
    Secretario
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2-3
    East Sussex
    182004020001
    CLARK, Martin Robert
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2-3
    East Sussex
    Director
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2-3
    East Sussex
    EnglandBritish60233030002
    GODFREY, Adam Barnaby
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2-3
    East Sussex
    Director
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2-3
    East Sussex
    United KingdomBritish52957710002
    STAPLETON, Richard Harvey
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2-3
    East Sussex
    Director
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2-3
    East Sussex
    United KingdomBritish52691090001
    TURNER, Peter John Sharpe
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2-3
    East Sussex
    Director
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2-3
    East Sussex
    EnglandBritish59460040001
    DAGWELL, Robert Shawn
    61 Copse Avenue
    Layhams Road
    BR4 9HN West Wickham
    Kent
    Secretario
    61 Copse Avenue
    Layhams Road
    BR4 9HN West Wickham
    Kent
    British148874200001
    POLLARD, Remi Constant Chenery
    6 Babmaes Street
    London
    SW1Y 6HD
    Secretario
    6 Babmaes Street
    London
    SW1Y 6HD
    British52691060001
    M W DOUGLAS & COMPANY LIMITED
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HP London
    Secretario designado corporativo
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HP London
    900007890001
    ALLEN-SHALLESS, Trudi Jane
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Director
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    EnglandBritish21506920002
    ASBURY, Ian
    North Bank House
    Cross Hill Road
    OX17 3EQ West Adderbury
    Oxfordshire
    Director
    North Bank House
    Cross Hill Road
    OX17 3EQ West Adderbury
    Oxfordshire
    British93810120001
    BARKER, Neil Stewart
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Director
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    United KingdomBritish127956210002
    BRADBEER, Nicholas Charles
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Director
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    United KingdomBritish71855470002
    BRADLEY SMITH, Robert Charles
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Director
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    United KingdomBritish82523240002
    CANNING, Spencer George Stratford De Redcliffe, Hon
    1 Church Street
    Little Bedwyn
    SN8 3JQ Marlborough
    Wiltshire
    Director
    1 Church Street
    Little Bedwyn
    SN8 3JQ Marlborough
    Wiltshire
    United KingdomBritish37931560001
    CANTWELL, Philip Joseph
    8 Oak Ridge
    West End
    GU24 9PJ Woking
    Surrey
    Director
    8 Oak Ridge
    West End
    GU24 9PJ Woking
    Surrey
    British66803840001
    CLARK, Vanessa Elizabeth
    11 Annandale Road
    Chiswick
    W4 2HE London
    Director
    11 Annandale Road
    Chiswick
    W4 2HE London
    EnglandBritish56357200002
    CLEVERTON, John Neil
    Maycroft Muddles Green
    BN21 4UP Chiddingly
    East Sussex
    Director
    Maycroft Muddles Green
    BN21 4UP Chiddingly
    East Sussex
    United KingdomBritish8500140003
    COLDBREATH, Peter Stuart
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Director
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    United KingdomBritish86987380002
    COOMBER, Ian Frederick
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Director
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    EnglandBritish150632140001
    COTTELL, Peter Michael
    6 Troymede
    RH17 6LU Haywards Heath
    West Sussex
    Director
    6 Troymede
    RH17 6LU Haywards Heath
    West Sussex
    EnglandBritish115306040001
    COX, Howard Ashley
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Director
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    United KingdomBritish123098020001
    DAGWELL, Robert Shawn
    61 Copse Avenue
    Layhams Road
    BR4 9HN West Wickham
    Kent
    Director
    61 Copse Avenue
    Layhams Road
    BR4 9HN West Wickham
    Kent
    British148874200001
    DAVIES, John Simon
    9 Hyde Park Crescent
    W2 2PY London
    Director
    9 Hyde Park Crescent
    W2 2PY London
    EnglandBritish10482150004
    DICKMAN, Jonathan Saul
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Director
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    United KingdomBritish110260430001
    ENGLISH, Greville John Reginald
    Glebe Cottage
    31 Lower Street
    RH20 2BH Pulborough
    West Sussex
    Director
    Glebe Cottage
    31 Lower Street
    RH20 2BH Pulborough
    West Sussex
    British59459880004
    EVANS, Nigel John Wilson
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Director
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    EnglandBritish59459500001
    FLETCHER, Trevor Peter
    37 Newbolt Avenue
    SM3 8ED Cheam
    Surrey
    Director
    37 Newbolt Avenue
    SM3 8ED Cheam
    Surrey
    British95383350001
    FORD, Nigel Kevin
    67 Stamford Green Road
    KT18 7SR Epsom
    Surrey
    Director
    67 Stamford Green Road
    KT18 7SR Epsom
    Surrey
    British59460170002
    GREENWOOD, Timothy Ian
    46 Bonehurst Road
    RH6 8QG Horley
    Surrey
    Director
    46 Bonehurst Road
    RH6 8QG Horley
    Surrey
    United KingdomBritish74487050002
    HADDEN, David George
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Director
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    EnglandBritish62211360001
    HAMMOND, John Philip Arthur
    The Bothy Tandridge Court
    Tandridge Lane
    RH8 9NJ Oxted
    Director
    The Bothy Tandridge Court
    Tandridge Lane
    RH8 9NJ Oxted
    EnglandBritish52957650002
    HARDWICKE, Timothy Robert
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Director
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    United KingdomBritish98537020002
    HEARD, Robert William
    Brook Cottage
    Wilton
    SN8 3SS Marlborough
    Wiltshire
    Director
    Brook Cottage
    Wilton
    SN8 3SS Marlborough
    Wiltshire
    British72313470001
    HITCH, Nicholas Charles
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Director
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    UkBritish60750750002
    HUNT, Simon Russell
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    Director
    27/29 Glasshouse Street
    W1B 5DF London
    Venture House
    England
    UkBritish110260330001

    ¿Tiene STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 06 ene 2012
    Entregado el 12 ene 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 12 ene 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 11 feb 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit deed
    Creado el 29 jun 1999
    Entregado el 03 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £44,000 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The rent deposit and the deposit balance with full guarantee as security for the performance of the obligations of the tenant under the lease.
    Personas con derecho
    • Hambleden Group Limited
    Transacciones
    • 03 jul 1999Registro de un cargo (395)
    • 26 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 02 feb 1999
    Entregado el 04 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 02 oct 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 abr 1997
    Entregado el 30 abr 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an assets purchase agreement dated 28TH april 1997
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Stiles Harold Williams Limited
    Transacciones
    • 30 abr 1997Registro de un cargo (395)
    • 02 oct 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    29 mar 2016Inicio de la liquidación
    10 ago 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    John Walters
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    Profesional
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    Jonathan James Beard
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    Profesional
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0