STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03311644 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?
- Agencias inmobiliarias (68310) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 2-3 Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton East Sussex |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CANNONGUARD LIMITED | 03 feb 1997 | 03 feb 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 16 páginas | 4.71 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 mar 2017 | 15 páginas | 4.68 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 26 páginas | MA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Venture House 27/29 Glasshouse Street London W1B 5DF a 2-3 Pavilion Buildings Brighton East Sussex BN1 1EE el 19 abr 2016 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Peter John Sharpe Turner como director el 04 mar 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sarah Jean Webb como director el 04 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Carol Gillian Williams como director el 04 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Garnett Wade como director el 04 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard James Turner como director el 04 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter John Sharpe Turner como director el 04 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Kevin Spruce como director el 04 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Stephen Skelton como director el 04 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Clive Richardson como director el 04 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Norton Ray como director el 04 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard William Antranik Pyne como director el 04 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Neale Todd Plant como director el 04 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Niral Harshadbhai Patel como director el 04 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Robert Fredric Victor Perry como director el 04 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Niall Mcguinness como director el 04 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Haydon Lee Murton como director el 04 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Scanlan Mcfadden como director el 04 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHOLEFIELD, Andrew | Secretario | Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton 2-3 East Sussex | 182004020001 | |||||||
| CLARK, Martin Robert | Director | Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton 2-3 East Sussex | England | British | 60233030002 | |||||
| GODFREY, Adam Barnaby | Director | Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton 2-3 East Sussex | United Kingdom | British | 52957710002 | |||||
| STAPLETON, Richard Harvey | Director | Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton 2-3 East Sussex | United Kingdom | British | 52691090001 | |||||
| TURNER, Peter John Sharpe | Director | Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton 2-3 East Sussex | England | British | 59460040001 | |||||
| DAGWELL, Robert Shawn | Secretario | 61 Copse Avenue Layhams Road BR4 9HN West Wickham Kent | British | 148874200001 | ||||||
| POLLARD, Remi Constant Chenery | Secretario | 6 Babmaes Street London SW1Y 6HD | British | 52691060001 | ||||||
| M W DOUGLAS & COMPANY LIMITED | Secretario designado corporativo | Regent House 316 Beulah Hill SE19 3HP London | 900007890001 | |||||||
| ALLEN-SHALLESS, Trudi Jane | Director | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | England | British | 21506920002 | |||||
| ASBURY, Ian | Director | North Bank House Cross Hill Road OX17 3EQ West Adderbury Oxfordshire | British | 93810120001 | ||||||
| BARKER, Neil Stewart | Director | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 127956210002 | |||||
| BRADBEER, Nicholas Charles | Director | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 71855470002 | |||||
| BRADLEY SMITH, Robert Charles | Director | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 82523240002 | |||||
| CANNING, Spencer George Stratford De Redcliffe, Hon | Director | 1 Church Street Little Bedwyn SN8 3JQ Marlborough Wiltshire | United Kingdom | British | 37931560001 | |||||
| CANTWELL, Philip Joseph | Director | 8 Oak Ridge West End GU24 9PJ Woking Surrey | British | 66803840001 | ||||||
| CLARK, Vanessa Elizabeth | Director | 11 Annandale Road Chiswick W4 2HE London | England | British | 56357200002 | |||||
| CLEVERTON, John Neil | Director | Maycroft Muddles Green BN21 4UP Chiddingly East Sussex | United Kingdom | British | 8500140003 | |||||
| COLDBREATH, Peter Stuart | Director | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 86987380002 | |||||
| COOMBER, Ian Frederick | Director | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | England | British | 150632140001 | |||||
| COTTELL, Peter Michael | Director | 6 Troymede RH17 6LU Haywards Heath West Sussex | England | British | 115306040001 | |||||
| COX, Howard Ashley | Director | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 123098020001 | |||||
| DAGWELL, Robert Shawn | Director | 61 Copse Avenue Layhams Road BR4 9HN West Wickham Kent | British | 148874200001 | ||||||
| DAVIES, John Simon | Director | 9 Hyde Park Crescent W2 2PY London | England | British | 10482150004 | |||||
| DICKMAN, Jonathan Saul | Director | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 110260430001 | |||||
| ENGLISH, Greville John Reginald | Director | Glebe Cottage 31 Lower Street RH20 2BH Pulborough West Sussex | British | 59459880004 | ||||||
| EVANS, Nigel John Wilson | Director | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | England | British | 59459500001 | |||||
| FLETCHER, Trevor Peter | Director | 37 Newbolt Avenue SM3 8ED Cheam Surrey | British | 95383350001 | ||||||
| FORD, Nigel Kevin | Director | 67 Stamford Green Road KT18 7SR Epsom Surrey | British | 59460170002 | ||||||
| GREENWOOD, Timothy Ian | Director | 46 Bonehurst Road RH6 8QG Horley Surrey | United Kingdom | British | 74487050002 | |||||
| HADDEN, David George | Director | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | England | British | 62211360001 | |||||
| HAMMOND, John Philip Arthur | Director | The Bothy Tandridge Court Tandridge Lane RH8 9NJ Oxted | England | British | 52957650002 | |||||
| HARDWICKE, Timothy Robert | Director | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | United Kingdom | British | 98537020002 | |||||
| HEARD, Robert William | Director | Brook Cottage Wilton SN8 3SS Marlborough Wiltshire | British | 72313470001 | ||||||
| HITCH, Nicholas Charles | Director | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | Uk | British | 60750750002 | |||||
| HUNT, Simon Russell | Director | 27/29 Glasshouse Street W1B 5DF London Venture House England | Uk | British | 110260330001 |
¿Tiene STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 06 ene 2012 Entregado el 12 ene 2012 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rent deposit deed | Creado el 29 jun 1999 Entregado el 03 jul 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £44,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción The rent deposit and the deposit balance with full guarantee as security for the performance of the obligations of the tenant under the lease. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 02 feb 1999 Entregado el 04 feb 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 28 abr 1997 Entregado el 30 abr 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an assets purchase agreement dated 28TH april 1997 | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene STILES HAROLD WILLIAMS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0