JIMTRACK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaJIMTRACK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03314930
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de JIMTRACK LIMITED?

    • Alquiler y explotación de bienes inmobiliarios de entidades de vivienda (68201) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra JIMTRACK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de JIMTRACK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para JIMTRACK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de 40 Queen Anne Street London W1G 9EL a 26-28 Bedford Row London WC1R 4HE el 07 dic 2015

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 17 nov 2015

    LRESSP

    Nombramiento de Mr Colin Barry Wagman como director el 17 nov 2015

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 31 oct 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 nov 2015

    Estado de capital el 24 nov 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    14 páginasAA

    Nombramiento de Mr James Anthony Piper como director el 31 dic 2014

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Michael George Cohen como director el 31 dic 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ivan Howard Ezekiel como secretario el 28 ene 2015

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Ivan Howard Ezekiel como director el 28 ene 2015

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Timothy Claude Garnham como director el 28 ene 2015

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Paul Jonathan Goswell como director el 31 dic 2014

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Alexander Wilson Lamont como director el 31 dic 2014

    3 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de 42 Wigmore Street London W1U 2RY a 40 Queen Anne Street London W1G 9EL el 02 mar 2015

    2 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 31 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 nov 2014

    Estado de capital el 04 nov 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 nov 2013

    Estado de capital el 06 nov 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    14 páginasAA

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 jun 2012 au 31 dic 2012

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 31 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    legacy

    3 páginasMG02

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2011

    14 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de JIMTRACK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COHEN, Michael George
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    England
    Director
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    England
    EnglandBritish153509790001
    GOSWELL, Paul Jonathan
    Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor
    Uk
    Director
    Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor
    Uk
    United KingdomBritish60475780003
    LAMONT, Alexander Wilson
    10 New Burlington Street
    W1S 3BE London
    6th Floor
    Uk
    Director
    10 New Burlington Street
    W1S 3BE London
    6th Floor
    Uk
    EnglandBritish158518680001
    PIPER, James Anthony
    New Burlington Street
    W1S 3BE London
    Ares Management, 10
    England
    Director
    New Burlington Street
    W1S 3BE London
    Ares Management, 10
    England
    EnglandBritish163685440001
    WAGMAN, Colin Barry
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor, Lansdowne House
    England
    Director
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor, Lansdowne House
    England
    EnglandBritish189915990001
    EZEKIEL, Ivan Howard
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Secretario
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    British56155670004
    KLEINER, Richard Howard
    26 Atwood Avenue
    Kew
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    Secretario
    26 Atwood Avenue
    Kew
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    British29866240002
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretario designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    COSTER, Paul Antony
    Garth Steading
    Walpole Avenue
    CR5 3PN Chipstead
    Surrey
    Director
    Garth Steading
    Walpole Avenue
    CR5 3PN Chipstead
    Surrey
    British35406400003
    EZEKIEL, Ivan Howard
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Director
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    EnglandBritish56155670004
    GARNHAM, Timothy Claude
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Director
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    EnglandBritish66502160002
    HASAN, Salmaan
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Director
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    United KingdomBritish106868320001
    MOODY, Edward Robert William
    24 Coborn Street
    E3 2AB London
    Director
    24 Coborn Street
    E3 2AB London
    Great BritainBritish62122950001
    ROSENFELD, Andrew Ian
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    Director
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    SwitzerlandBritish118467060001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Director designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    ¿Tiene JIMTRACK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 25 oct 1999
    Entregado el 04 nov 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and/or future liabilities of the company to the chargee as agent and security trustee for the lenders (as defined) under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nationwide Building Society
    Transacciones
    • 04 nov 1999Registro de un cargo (395)
    • 15 sept 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge over deposit account
    Creado el 12 may 1997
    Entregado el 29 may 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company,eagleprint limited and tyrecard limited or any of them to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the monies that are now or shall hereafter be standing to the credit of the principal debtor's account with the bank numbered 01571087 and designated "eagleprint limited and others".
    Personas con derecho
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transacciones
    • 29 may 1997Registro de un cargo (395)
    • 29 may 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 12 may 1997
    Entregado el 29 may 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company,eagleprint limited and tyrecard limited to the chargee on any account whatsoever and as agreed in a facility letter dated 2 march 1997
    Breve descripción
    L/H property being unit 21,oliver road,west thurrock t/nos.EX118306 and EX126833 including all rights powers and liberties attached including all buildings erected thereon and all fixtures fittings plant machinery apparatus goods and materials (not being personal chattels within the bills of sale acts 1878 to 1882) affixed to the property but excluding tenants fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transacciones
    • 29 may 1997Registro de un cargo (395)
    • 04 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 17 mar 1997
    Entregado el 18 mar 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Floating charge over all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Personas con derecho
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transacciones
    • 18 mar 1997Registro de un cargo (395)
    • 29 may 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene JIMTRACK LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    17 nov 2015Inicio de la liquidación
    21 feb 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Asher Miller
    David Rubin & Partners
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    Profesional
    David Rubin & Partners
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0