AUTOLINK HOLDINGS (M6) LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | AUTOLINK HOLDINGS (M6) LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03319443 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de AUTOLINK HOLDINGS (M6) LTD?
- Construcción de carreteras y autopistas (42110) / Construcción
¿Dónde se encuentra AUTOLINK HOLDINGS (M6) LTD?
| Dirección de la sede social | Concept House Home Park Mill Link WD4 8UD Kings Langley Hertfordshire United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AUTOLINK HOLDINGS (M6) LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HIKEHELP LIMITED | 17 feb 1997 | 17 feb 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de AUTOLINK HOLDINGS (M6) LTD?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para AUTOLINK HOLDINGS (M6) LTD?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 18 feb 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 04 mar 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 18 feb 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para AUTOLINK HOLDINGS (M6) LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cambio de datos del director Mr John Kinloch Laidlaw el 07 ago 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Eaton Court Maylands Avenue Hemel Hempstead Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7TR a Concept House Home Park Mill Link Kings Langley Hertfordshire WD4 8UD el 07 ago 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Cambio de datos del director Mr Robert John William Wotherspoon el 17 jul 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del secretario Mr John Alistair Dempsey el 17 jul 2025 | 1 páginas | CH03 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 27 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr John Alistair Dempsey como secretario el 17 abr 2025 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Kevin John Pearson como secretario el 17 abr 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 feb 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 27 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 feb 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Memorándum y Estatutos | 16 páginas | MA | ||
Nombramiento de Mr John Kinloch Laidlaw como director el 31 ago 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Antony Richard Gates como director el 31 ago 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 28 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 feb 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 31 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 feb 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Notification de Innisfree M&G Ppp Llp en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 sept 2021 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessation de Innisfree Nominees Limited (Acting in Its Capacity as Nominee of Innisfree M&G Ppp Lp) en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 sept 2021 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 30 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 feb 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Benjamin Christopher Jacob Dean el 09 dic 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 28 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 18 feb 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 feb 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de AUTOLINK HOLDINGS (M6) LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMPSEY, John Alistair | Secretario | Home Park Mill Link WD4 8UD Kings Langley Concept House Hertfordshire United Kingdom | 334859600001 | |||||||
| DEAN, Benjamin Christopher Jacob | Director | First Floor, Boundary House 91/93 Charterhouse Street EC1M 6HR London Innisfree Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 225247590002 | |||||
| JAMES, Christopher | Director | First Floor, Boundary House 91/93 Charterhouse Street EC1M 6HR London Innisfree Limited United Kingdom | England | British | 146543930001 | |||||
| LAIDLAW, John Kinloch | Director | Home Park Mill Link WD4 8UD Kings Langley Concept House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 116175890001 | |||||
| WOTHERSPOON, Robert John William | Director | Home Park Mill Link WD4 8UD Kings Langley Concept House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 51397340003 | |||||
| MCBRIDE, Robert Ian | Secretario | 97 Harbut Road SW11 2RD London | British | 52020940001 | ||||||
| PEARSON, Kevin John | Secretario | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire United Kingdom | 179458840001 | |||||||
| SHELLEY, Miles Colin | Secretario | 20 Tuffnells Way AL5 3HQ Harpenden Hertfordshire | British | 44005940002 | ||||||
| WALKER, Robert Peter | Secretario | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire | British | 11492400001 | ||||||
| WOTHERSPOON, Robert John William | Secretario | Flat 20 Lawrence House Cureton Street SW1P 4ED London | British | 51397340003 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BANNISTER, Paul Alan | Director | 11 Sorrel Close RG40 5YA Wokingham Berkshire | United Kingdom | United Kingdom | 55857010001 | |||||
| BARR, William James | Director | Harkieston KA19 7LP Maybole Ayrshire | Scotland | British | 121802590001 | |||||
| BICKERSTAFF, Anthony Oliver | Director | 12 Heythrop Drive UB10 8DT Ickenham Middlesex | British | 77330600002 | ||||||
| BOWN, Nicholas George | Director | Sky End House Sky End Lane Hordle SO41 0HG Lymington Hampshire | United Kingdom | British | 69709580002 | |||||
| BRADBURY, David Richard | Director | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 109853290001 | |||||
| CLARKE, Edward Hilton | Director | 70 Waterford Road SW6 2DR London | United Kingdom | British | 89466210001 | |||||
| COLLARD, Michael John | Director | Birds Oak Leatherhead Road KT22 0JJ Oxshott Surrey | British | 49634040001 | ||||||
| CROWTHER, Nicholas John Edward | Director | Charterhouse Street EC1M 6HR London Innisfree Limited Boundary House 91-93 | United Kingdom | British | 103617880001 | |||||
| FERNANDES, Milton Anthony | Director | Wisteria House 67 Kingston Lane TW11 9HN Teddington Middlesex | United Kingdom | British | 108927700001 | |||||
| GATES, Antony Richard | Director | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 165339210001 | |||||
| GRAHAM, John | Director | 91-93 Charterhouse Street EC2V 8AS London Innisfree Ltd Boundary House United Kingdom | United Kingdom | British | 116875070001 | |||||
| HENDRY, Brian William | Director | Radford House Finch Lane Knotty Green HP9 2TL Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 61876980001 | |||||
| KASHEM, Timothy John | Director | Flat 73 Capital Wharf 50 Wapping High Street E1W 1LY London | United Kingdom | British | 113162720018 | |||||
| LIMBERT, Derek | Director | 16 Hutchings Road Knotty Green HP9 2BB Beaconsfield Buckinghamshire | British | 10059400001 | ||||||
| LINNEY, Joseph Mark | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 United Kingdom | Scotland | British | 63161960001 | |||||
| LOPEZ-SIMON, Maria Milagros | Director | 33 Cannon Street EC4M 5SB London Watling House United Kingdom | United Kingdom | Spanish,British | 258287880001 | |||||
| LUCAS, William Anthony | Director | Tanglewood Park Close Wilmcote CV37 9XE Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 27693460001 | ||||||
| MAIR, Logan Michael | Director | 109 Elm Park Mansions Park Walk Chelsea SW10 0AR London | British | 52020870002 | ||||||
| MCBRIDE, Robert Ian | Director | 97 Harbut Road SW11 2RD London | British | 52020940001 | ||||||
| MERCER-DEADMAN, Michael John | Director | 18 Tennyson Road AL5 4BB Harpenden Hertfordshire | Uk | British | 10697910001 | |||||
| METTER, David Antony | Director | W2 | United Kingdom | British | 17535810001 | |||||
| MOGG, Charles Michael | Director | Ladywood Stray Church Road, Wilmcote CV37 9XD Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 87961010001 | ||||||
| NEILL, James Graeme | Director | Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Eaton Court Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 168446500001 | |||||
| NELSON, Andrew Latham | Director | 9 Rosebury Road SW6 2NH London | British | 36191090001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de AUTOLINK HOLDINGS (M6) LTD?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innisfree M&G Ppp Llp | 14 sept 2021 | Boundary House 91-93 Charterhouse Street EC1M 6HR London 1st Floor United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Innisfree Nominees Limited (Acting In Its Capacity As Nominee Of Innisfree M&G Ppp Lp) | 06 abr 2016 | 91/93 Charterhouse Street EC1M 6HR London Boundary House United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0