ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03324967 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Bridgeway House Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Warwickshire England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MORETHANHOTELS (STAFFORD) LIMITED | 25 nov 2005 | 25 nov 2005 |
| FOREMOST HOTELS (STAFFORD) LIMITED | 30 may 2003 | 30 may 2003 |
| INGRAM (STAFFORD) LIMITED | 09 jul 1998 | 09 jul 1998 |
| ROADCHEF (STAFFORD) LIMITED | 23 abr 1997 | 23 abr 1997 |
| BEALAW (430) LIMITED | 27 feb 1997 | 27 feb 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cessation de Atlas Hotels (Group 4 Property 2) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 dic 2019 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Notification de London and Regional Group Hotel Holdings Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 dic 2019 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 feb 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Adrian Paul Bradley como director el 19 mar 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 feb 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 30 sept 2018 au 31 dic 2018 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2017 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 feb 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Keith Ian Griffiths como director el 05 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Sean Joseph Lowe como director el 05 ene 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 033249670006 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2016 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 feb 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de No.1 London Bridge London SE1 9BG England a Quadrant House, Floor 6 4 Thomas More Square London E1W 1YW | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 31 dic 2016 au 30 sept 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 033249670005 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 18 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Registro de la carga 033249670006, creada el 21 jun 2016 | 89 páginas | MR01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 17 Dominion Street London EC2M 2EF a Bridgeway House Bridgeway Stratford-upon-Avon Warwickshire CV37 6YX el 29 jun 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Shaun Robinson como director el 21 jun 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADLEY, Adrian Paul | Director | Baker Street W1U 8EW London 55 United Kingdom | United Kingdom | British | 90379240002 | |||||
| LOWE, Sean Joseph | Director | Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Bridgeway House Warwickshire England | United Kingdom | British | 195752560001 | |||||
| INGRAM HILL, Sarah | Secretario | Monks Hollow Alton Priors SN8 4JX Marlborough Wiltshire | British | 59327230001 | ||||||
| MCCOLL, Fraser Robert | Secretario | Broom Cottage 1 Lodge Lane TN16 1RH Westerham Kent | British | 70649620002 | ||||||
| PENDRILL, Richard William | Secretario | Boscobel Sweetwater Lane Wormley GU8 5SS Godalming Surrey | British | 5919770001 | ||||||
| WARWICK, Timothy James | Secretario | Plas Y Coed 3 Cwrt Y Cadno St Fagans CF5 4PJ Cardiff Wales | British | 65745040001 | ||||||
| BEACH SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 100 Fetter Lane EC4A 1BN London | 900002710001 | |||||||
| MAWLAW SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Bishopsgate EC2M 3AF London 201 | 39182980003 | |||||||
| BARNES, Robert Digby Phillips | Director | Brampton Chase Summerhouse Road GU7 1PY Godalming Surrey | United Kingdom | British | 59539070002 | |||||
| BELL, Alastair Marshall | Director | 8 Thackeray Close Wimbledon SW19 4JL London | England | British | 87778630001 | |||||
| COUTURIER, Philippe | Director | Dominion Street EC2M 2EF London 17 United Kingdom | England | French | 185748330001 | |||||
| DARLING, Mervyn | Director | St James's House Charlotte Street M1 4DZ Manchester Allied Irish Bank United Kingdom | United Kingdom | Irish | 147824160001 | |||||
| DE BURETEL DE CHASSEY, Marc Frederic Marie | Director | 19 Furlong Road N7 8LS London | French | 110966050002 | ||||||
| DESSOKY, Usama | Director | 5 Rudgwick Terrace 20 Avenue Road NW8 6BR London | England | British | 85181940001 | |||||
| DODD, Angus Alexander | Director | 13 Redgrave Road SW15 1PX London | British | 110965490001 | ||||||
| DUNN, Barrie | Director | B316 Peninsula Apartments 4 Praed Street W2 1JE London | United Kingdom | British | 109512300001 | |||||
| EDDIS, Christopher Frederick | Director | 102 Portland Road Holland Park W11 4LX London | United Kingdom | British | 59311260003 | |||||
| GILLESPIE, Brendan | Director | Express By Holiday Inn Birmingham Nec Bickenhill Parkway B40 1QA Birmingham Central Office United Kingdom | British | 129902710001 | ||||||
| GRAUERS, Clifford Eric | Director | Express By Holiday Inn Birmingham Nec Bickenhill Parkway B40 1QA Birmingham Central Office United Kingdom | England | British | 60557140001 | |||||
| GRAY, Robert Edward | Director | Dominion Street EC2M 2EF London 17 | United Kingdom | British | 188584900001 | |||||
| GRIFFITHS, Keith Ian | Director | Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Bridgeway House Warwickshire England | United Kingdom | British | 77782610002 | |||||
| HILL, Timothy Ingram | Director | Monks Hollow Alton Priors SN8 4JX Marlborough Wiltshire | British | 57283990001 | ||||||
| HORTHY, Sharif Istvan | Director | 43 St Annes Crescent BN7 1SD Lewes East Sussex | England | British | 59598440001 | |||||
| INGRAM HILL, Sarah | Director | Monks Hollow Alton Priors SN8 4JX Marlborough Wiltshire | British | 59327230001 | ||||||
| KINGSMILL, Robert Martin | Director | Express By Holiday Inn Birmingham Nec Bickenhill Parkway B40 1QA Birmingham Central Office | United Kingdom | British | 139337530001 | |||||
| MCKEVITT, Richard | Director | Nightingales Lane HP8 4SF Chalfont St. Giles Tyhurst Buckinghamshire | United Kingdom | British | 142295770001 | |||||
| MERCHANT, David John | Director | 9 Fairmile Court KT11 2DS Cobham Surrey | England | British | 102844250001 | |||||
| MITCHELL, Stephen David | Director | Great Portland Street W1W 5LS London 179 | England | British | 95336510001 | |||||
| MORAR, Neal | Director | Dominion Street EC2M 2EF London 17 United Kingdom | England | British | 173110500001 | |||||
| MYERS, David Paul | Director | Great Portland Street W1W 5LS London 179 England | England | British | 142171370001 | |||||
| NOBLE, David | Director | Great Portland Street W1W 5LS London 179-185 | England | British | 127359410001 | |||||
| ROBINSON, Shaun | Director | Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Bridgeway House Warwickshire England | United Kingdom | British | 101627760001 | |||||
| STOCKTON, Richard | Director | Dominion Street EC2M 2EF London 17 | United Kingdom | British | 173676030001 | |||||
| WHITBY, Peter James | Director | Great Portland Street W1W 5LS London 179-185 | England | English | 76096790002 | |||||
| CROFT NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | 100 Fetter Lane EC4A 1BN London | 900002700001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London And Regional Group Hotel Holdings Ltd | 12 dic 2019 | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Atlas Hotels (Group 4 Property 2) Limited | 06 abr 2016 | Dominion Street EC2M 2EF London 17 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 21 jun 2016 Entregado el 30 jun 2016 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción The freehold and leasehold interests in holiday inn express stafford, stafford south, acton court, acton gate, stafford, ST18 9AP with title numbers SF384424 and SF381471 and SF525024 and, where the context so requires, includes the buildings on the property. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 17 dic 2014 Entregado el 19 dic 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 12 oct 2007 Entregado el 19 oct 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The properties listed in schedule 2 of T. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 23 nov 2005 Entregado el 05 dic 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Land lying on the west side of redbridge lane mursling southampton t/no HP581790,land lying to the north of hyde road gorton manchester t/no GM821643,land at harbledown canterbury t/no K787140 (for details of further properties charged plea. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 08 may 2003 Entregado el 13 may 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from ingram hotels limited to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All that l/h property k/a express by holiday inn stafford south acton court acton gate stafford t/n SF381471 together with the f/h land lying to the west of stafford road acton gate t/n SF384424. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 08 may 2003 Entregado el 13 may 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0