ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED

ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03324967
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Bridgeway House
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MORETHANHOTELS (STAFFORD) LIMITED25 nov 200525 nov 2005
    FOREMOST HOTELS (STAFFORD) LIMITED30 may 200330 may 2003
    INGRAM (STAFFORD) LIMITED09 jul 199809 jul 1998
    ROADCHEF (STAFFORD) LIMITED23 abr 199723 abr 1997
    BEALAW (430) LIMITED27 feb 199727 feb 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cessation de Atlas Hotels (Group 4 Property 2) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 dic 2019

    1 páginasPSC07

    Notification de London and Regional Group Hotel Holdings Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 dic 2019

    2 páginasPSC02

    Declaración de confirmación presentada el 16 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr Adrian Paul Bradley como director el 19 mar 2019

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 16 feb 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Exercice comptable précédent prolongé du 30 sept 2018 au 31 dic 2018

    1 páginasAA01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2017

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 16 feb 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Keith Ian Griffiths como director el 05 ene 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Sean Joseph Lowe como director el 05 ene 2018

    2 páginasAP01

    Cancelación total de la carga 033249670006

    1 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2016

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 16 feb 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de No.1 London Bridge London SE1 9BG England a Quadrant House, Floor 6 4 Thomas More Square London E1W 1YW

    1 páginasAD02

    Exercice comptable en cours raccourci du 31 dic 2016 au 30 sept 2016

    1 páginasAA01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    5 páginasAA

    Cancelación total de la carga 033249670005

    1 páginasMR04

    Resoluciones

    Resolutions
    18 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Registro de la carga 033249670006, creada el 21 jun 2016

    89 páginasMR01

    Domicilio social registrado cambiado de 17 Dominion Street London EC2M 2EF a Bridgeway House Bridgeway Stratford-upon-Avon Warwickshire CV37 6YX el 29 jun 2016

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Shaun Robinson como director el 21 jun 2016

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRADLEY, Adrian Paul
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    United Kingdom
    Director
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    United Kingdom
    United KingdomBritish90379240002
    LOWE, Sean Joseph
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Bridgeway House
    Warwickshire
    England
    Director
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Bridgeway House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish195752560001
    INGRAM HILL, Sarah
    Monks Hollow Alton Priors
    SN8 4JX Marlborough
    Wiltshire
    Secretario
    Monks Hollow Alton Priors
    SN8 4JX Marlborough
    Wiltshire
    British59327230001
    MCCOLL, Fraser Robert
    Broom Cottage
    1 Lodge Lane
    TN16 1RH Westerham
    Kent
    Secretario
    Broom Cottage
    1 Lodge Lane
    TN16 1RH Westerham
    Kent
    British70649620002
    PENDRILL, Richard William
    Boscobel Sweetwater Lane
    Wormley
    GU8 5SS Godalming
    Surrey
    Secretario
    Boscobel Sweetwater Lane
    Wormley
    GU8 5SS Godalming
    Surrey
    British5919770001
    WARWICK, Timothy James
    Plas Y Coed 3 Cwrt Y Cadno
    St Fagans
    CF5 4PJ Cardiff
    Wales
    Secretario
    Plas Y Coed 3 Cwrt Y Cadno
    St Fagans
    CF5 4PJ Cardiff
    Wales
    British65745040001
    BEACH SECRETARIES LIMITED
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    Secretario designado corporativo
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    900002710001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Secretario corporativo
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    BARNES, Robert Digby Phillips
    Brampton Chase
    Summerhouse Road
    GU7 1PY Godalming
    Surrey
    Director
    Brampton Chase
    Summerhouse Road
    GU7 1PY Godalming
    Surrey
    United KingdomBritish59539070002
    BELL, Alastair Marshall
    8 Thackeray Close
    Wimbledon
    SW19 4JL London
    Director
    8 Thackeray Close
    Wimbledon
    SW19 4JL London
    EnglandBritish87778630001
    COUTURIER, Philippe
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Director
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    EnglandFrench185748330001
    DARLING, Mervyn
    St James's House
    Charlotte Street
    M1 4DZ Manchester
    Allied Irish Bank
    United Kingdom
    Director
    St James's House
    Charlotte Street
    M1 4DZ Manchester
    Allied Irish Bank
    United Kingdom
    United KingdomIrish147824160001
    DE BURETEL DE CHASSEY, Marc Frederic Marie
    19 Furlong Road
    N7 8LS London
    Director
    19 Furlong Road
    N7 8LS London
    French110966050002
    DESSOKY, Usama
    5 Rudgwick Terrace
    20 Avenue Road
    NW8 6BR London
    Director
    5 Rudgwick Terrace
    20 Avenue Road
    NW8 6BR London
    EnglandBritish85181940001
    DODD, Angus Alexander
    13 Redgrave Road
    SW15 1PX London
    Director
    13 Redgrave Road
    SW15 1PX London
    British110965490001
    DUNN, Barrie
    B316 Peninsula Apartments
    4 Praed Street
    W2 1JE London
    Director
    B316 Peninsula Apartments
    4 Praed Street
    W2 1JE London
    United KingdomBritish109512300001
    EDDIS, Christopher Frederick
    102 Portland Road
    Holland Park
    W11 4LX London
    Director
    102 Portland Road
    Holland Park
    W11 4LX London
    United KingdomBritish59311260003
    GILLESPIE, Brendan
    Express By Holiday Inn Birmingham Nec
    Bickenhill Parkway
    B40 1QA Birmingham
    Central Office
    United Kingdom
    Director
    Express By Holiday Inn Birmingham Nec
    Bickenhill Parkway
    B40 1QA Birmingham
    Central Office
    United Kingdom
    British129902710001
    GRAUERS, Clifford Eric
    Express By Holiday Inn Birmingham Nec
    Bickenhill Parkway
    B40 1QA Birmingham
    Central Office
    United Kingdom
    Director
    Express By Holiday Inn Birmingham Nec
    Bickenhill Parkway
    B40 1QA Birmingham
    Central Office
    United Kingdom
    EnglandBritish60557140001
    GRAY, Robert Edward
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    Director
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United KingdomBritish188584900001
    GRIFFITHS, Keith Ian
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Bridgeway House
    Warwickshire
    England
    Director
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Bridgeway House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish77782610002
    HILL, Timothy Ingram
    Monks Hollow
    Alton Priors
    SN8 4JX Marlborough
    Wiltshire
    Director
    Monks Hollow
    Alton Priors
    SN8 4JX Marlborough
    Wiltshire
    British57283990001
    HORTHY, Sharif Istvan
    43 St Annes Crescent
    BN7 1SD Lewes
    East Sussex
    Director
    43 St Annes Crescent
    BN7 1SD Lewes
    East Sussex
    EnglandBritish59598440001
    INGRAM HILL, Sarah
    Monks Hollow Alton Priors
    SN8 4JX Marlborough
    Wiltshire
    Director
    Monks Hollow Alton Priors
    SN8 4JX Marlborough
    Wiltshire
    British59327230001
    KINGSMILL, Robert Martin
    Express By Holiday Inn Birmingham Nec
    Bickenhill Parkway
    B40 1QA Birmingham
    Central Office
    Director
    Express By Holiday Inn Birmingham Nec
    Bickenhill Parkway
    B40 1QA Birmingham
    Central Office
    United KingdomBritish139337530001
    MCKEVITT, Richard
    Nightingales Lane
    HP8 4SF Chalfont St. Giles
    Tyhurst
    Buckinghamshire
    Director
    Nightingales Lane
    HP8 4SF Chalfont St. Giles
    Tyhurst
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish142295770001
    MERCHANT, David John
    9 Fairmile Court
    KT11 2DS Cobham
    Surrey
    Director
    9 Fairmile Court
    KT11 2DS Cobham
    Surrey
    EnglandBritish102844250001
    MITCHELL, Stephen David
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    Director
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    EnglandBritish95336510001
    MORAR, Neal
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Director
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish173110500001
    MYERS, David Paul
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Director
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritish142171370001
    NOBLE, David
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179-185
    Director
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179-185
    EnglandBritish127359410001
    ROBINSON, Shaun
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Bridgeway House
    Warwickshire
    England
    Director
    Bridgeway
    CV37 6YX Stratford-Upon-Avon
    Bridgeway House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish101627760001
    STOCKTON, Richard
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    Director
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United KingdomBritish173676030001
    WHITBY, Peter James
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179-185
    Director
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179-185
    EnglandEnglish76096790002
    CROFT NOMINEES LIMITED
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    Director designado corporativo
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    900002700001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House, Floor 6
    United Kingdom
    12 dic 2019
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Quadrant House, Floor 6
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro11393145
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    06 abr 2016
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03328699
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 21 jun 2016
    Entregado el 30 jun 2016
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    The freehold and leasehold interests in holiday inn express stafford, stafford south, acton court, acton gate, stafford, ST18 9AP with title numbers SF384424 and SF381471 and SF525024 and, where the context so requires, includes the buildings on the property.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transacciones
    • 30 jun 2016Registro de una carga (MR01)
    • 08 nov 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 17 dic 2014
    Entregado el 19 dic 2014
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transacciones
    • 19 dic 2014Registro de una carga (MR01)
    • 07 jul 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 12 oct 2007
    Entregado el 19 oct 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The properties listed in schedule 2 of T. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties (Security Trustee)
    Transacciones
    • 19 oct 2007Registro de un cargo (395)
    • 15 abr 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 23 nov 2005
    Entregado el 05 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Land lying on the west side of redbridge lane mursling southampton t/no HP581790,land lying to the north of hyde road gorton manchester t/no GM821643,land at harbledown canterbury t/no K787140 (for details of further properties charged plea. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 29 mar 2007Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 23 oct 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 08 may 2003
    Entregado el 13 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from ingram hotels limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that l/h property k/a express by holiday inn stafford south acton court acton gate stafford t/n SF381471 together with the f/h land lying to the west of stafford road acton gate t/n SF384424. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 13 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 03 oct 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 may 2003
    Entregado el 13 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 13 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 03 oct 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0