BLU INVESTMENTS LIMITED

BLU INVESTMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBLU INVESTMENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03325064
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BLU INVESTMENTS LIMITED?

    • (7011) /

    ¿Dónde se encuentra BLU INVESTMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BLU INVESTMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PCO 169 LIMITED21 feb 199721 feb 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BLU INVESTMENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2007

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BLU INVESTMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Restauración por orden judicial

    3 páginasAC92

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    legacy

    1 páginas652a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    6 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2007

    19 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de BLU INVESTMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Secretario
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    British32809000002
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Director
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritish1898090001
    PAILEX CORPORATE SERVICES LIMITED
    First Floor Bouverie House
    154 Fleet Street
    EC4A 2DQ London
    Secretario designado corporativo
    First Floor Bouverie House
    154 Fleet Street
    EC4A 2DQ London
    900013000001
    ADAM, Shenol
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    Director
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    British2068480001
    BARNES, Eric Malcolm
    148 Chapel Lane
    Ravenshead
    NG15 9DJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    148 Chapel Lane
    Ravenshead
    NG15 9DJ Nottingham
    Nottinghamshire
    British20256100002
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    Director
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Director
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritish32809050004
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Director
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritish152497530001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Director
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    United KingdomBritish32809000002
    BURY, David Gordon
    The Viking Wing
    Thurland Castle Tunstall
    LA6 2QR Lancaster
    Lancashire
    Director
    The Viking Wing
    Thurland Castle Tunstall
    LA6 2QR Lancaster
    Lancashire
    United KingdomBritish114282510002
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Director
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritish78691990003
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    Director
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritish3079890002
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Director
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    British51688320001
    HINCHLEY, David
    20 Leconfield Garth
    Follifoot
    HG3 1NF Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    20 Leconfield Garth
    Follifoot
    HG3 1NF Harrogate
    North Yorkshire
    British21091680001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Director
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Director
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    British3079600001
    MORRIS, David
    4 Greenmount Drive
    Greenmount
    BL8 4HA Bury
    Lancashire
    Director
    4 Greenmount Drive
    Greenmount
    BL8 4HA Bury
    Lancashire
    British3442030001
    PELTZ, Daniel
    9 Cavendish Avenue
    St Johns Wood
    NW8 9JD London
    Director
    9 Cavendish Avenue
    St Johns Wood
    NW8 9JD London
    EnglandBritish34366280004
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Director
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritish41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Director
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritish35758050004
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Director
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritish35758050004
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Director
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritish79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Director
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish63986410003
    ROSEFIELD, Stephen Michael
    154 Fleet Street
    1st Floor, Bouverie House
    EC4A 2DQ London
    Director
    154 Fleet Street
    1st Floor, Bouverie House
    EC4A 2DQ London
    British51560380002
    TYLER, David Alan
    6 Ernle Road
    Wimbledon
    SW20 0HJ London
    Director
    6 Ernle Road
    Wimbledon
    SW20 0HJ London
    British51860290001
    WEBB, Nigel Mark
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    Director
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish58059360001
    WESTON SMITH, John Harry
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    Director
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    EnglandBritish13547380001

    ¿Tiene BLU INVESTMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Third supplemental trust deed supplemental to a trust deed dated 31 march 1998 (the principal trust deed),as defined,and securing the £100,000,000 6 > per cent.first mortgage debenture bonds 2011 and £200,000,000 6 > per cent. First mortgage debenture bonds due 2020 of the company (the bonds) and the first supplemental trust deed dated 13 april 1999 (as defined)
    Creado el 30 mar 2001
    Entregado el 10 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The payment of the principal of,premium (if any) and all other moneys due or to become due from bl universal PLC to the chargee under or pursuant to the trust deed
    Breve descripción
    All rights,title and interest in the leasehold and freehold premises known as (I) 23/25 english st,carlisle; (ii) 35 high st,chelmsford; (iii) 41 oxford st,kidderminster plus other properties listed. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Exchange Trust Company Limited,as Trustee for the Holders of Thebonds
    Transacciones
    • 10 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 19 jun 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 18 nov 1998
    Entregado el 04 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The payment of the principal of,premium (if any) and interest on the bonds,and any further bonds and all other moneys covenanted to be paid by bl universal PLC to the chargee under or pursuant to the trust deed
    Breve descripción
    The premises at 20 donegall place,belfast comprised in and held under lease dated 1 august 1929.
    Personas con derecho
    • Royal Exchange Trust Company Limited (The "Trustee")
    Transacciones
    • 04 dic 1998Registro de un cargo (395)
    • 03 abr 2006Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 19 jun 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 19 may 1998
    Entregado el 21 may 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The payment of the principal of premium (if any) and interest on the original bonds (as defined) and all further bonds (as defined) and all monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the mortgage
    Breve descripción
    F/H premises comprising part of the arches retail park connswater belfast; l/h premises forming part of the arches retail park connswater belfast; l/h premises situate at albertbridge road belfast.
    Personas con derecho
    • Royal Exchange Trust Company Limited ("the Trustee")
    Transacciones
    • 21 may 1998Registro de un cargo (395)
    • 19 jun 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage in relation to a trust deed dated 31ST march 1998 constituting and securing £100,000,000 6 3/4 per cent. First mortgage debenture bonds due 2011 and £200,000,000 6 3/4 per cent. First mortgage debenture bonds due 2020 (with authority to issue further first mortgage debenture bonds or notes) (the bonds)
    Creado el 31 mar 1998
    Entregado el 18 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The payment of the principal of, premium (if any) and interest on the original bonds and all further bonds and all other moneys covenanted to be paid by the company to the chargee (the trustee) under or pursuant to the mortgage
    Breve descripción
    F/H and l/h premises k/a connswater shopping centre belfast.
    Personas con derecho
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transacciones
    • 18 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 19 jun 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Trust deed dated 31ST march 1998 constituting and securing £100,000,000 6 3/4 per cent. First mortgage debenture bonds due 2011 and £200,000,000 6 3/4 per cent. First mortgage debenture bonds due 2020 (with authority to issue further first mortgage debenture bonds or notes)
    Creado el 31 mar 1998
    Entregado el 16 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The payment of the principal of, the premium (if any) and interest on the bonds and all other moneys covenanted to be paid by bl universal PLC to the trustee under or pursuant to the trust deed
    Breve descripción
    Various properties as specified on form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Exchange Trust Company Limited(As Trustee for the Holders of the Bonds)
    Transacciones
    • 16 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 16 ago 2005Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 16 ago 2005Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 19 jun 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0