AUTOMOTIVE MOTION TECHNOLOGY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | AUTOMOTIVE MOTION TECHNOLOGY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03325876 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de AUTOMOTIVE MOTION TECHNOLOGY LIMITED?
- fabricación de otras piezas y accesorios para vehículos de motor (29320) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra AUTOMOTIVE MOTION TECHNOLOGY LIMITED?
| Dirección de la sede social | Bridgeway House Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de AUTOMOTIVE MOTION TECHNOLOGY LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para AUTOMOTIVE MOTION TECHNOLOGY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 feb 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 feb 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 7 páginas | AA | ||
Cessation de Dana Incorporated en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 1 páginas | PSC07 | ||
Notification de Echlin Europe Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 feb 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 7 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de John Thomas Coppage como secretario el 07 jul 2020 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Juergen Wald como director el 07 jul 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Oliver Habluetzel como director el 07 jul 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Jason Mcfall como director el 07 jul 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Jason Mcfall como secretario el 07 jul 2020 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de John Thomas Coppage como director el 07 jul 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 feb 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 01 feb 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr John Thomas Coppage como director el 19 oct 2016 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de AUTOMOTIVE MOTION TECHNOLOGY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCFALL, Jason | Secretario | CV37 6YX Stratford - Upon- Avon Bridgeway House United Kingdom | 272686560001 | |||||||
| HABLUETZEL, Oliver | Director | 13 6330 Cham Riedstrasse Switzerland | Switzerland | Swiss | 272686690001 | |||||
| MCFALL, Jason | Director | CV37 6YX Stratford - Upon- Avon Bridgeway House United Kingdom | United Kingdom | British | 272686530001 | |||||
| ALLY, Bibi Rahima | Secretario | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | British | 38963210003 | ||||||
| COPPAGE, John Thomas | Secretario | Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Bridgeway House | 217032400001 | |||||||
| KING, William Lawrence | Secretario | The Old Laundry Horney Common TN22 3ED Uckfield East Sussex | British | 50541890002 | ||||||
| MAIDMENT, Michael Edwin Walter | Secretario | 1 Windmill Hill Biddenham MK40 4AG Bedford Bedfordshire | British | 29336340001 | ||||||
| MURPHY, Peter John | Secretario | 7 Seaton Close Burbage LE10 2BW Hinckley Leicestershire | British | 5874670001 | ||||||
| RICHARDS, Caroline Ann | Secretario | Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Bridgeway House | British | 178214250001 | ||||||
| SAUNDERS, Paul | Secretario | Bearcot Lodge Hatton Green CV35 7LA Warwick Warwickshire | British | 111951440001 | ||||||
| AGHILI, Aziz Seyed | Director | Kloten(Zh) CH 8302 Switzerland Steinackerstrasse 56 Switzerland | Switzerland | American | 153933430001 | |||||
| BAKEWELL, David John | Director | Pothooks Cottage Mill Lane Acton Gate ST17 0RA Stafford | British | 11709930002 | ||||||
| BLEE, Timothy John | Director | 1731 Pin Oak Court Troy M FOREIGN 48098 Usa | British | 55434000001 | ||||||
| CIRULIS, Peter John | Director | Wadenswil Friedheimstrasse 16 8820 Switzerland | Siwtzerland | American | 156668560001 | |||||
| CLARKE, Jeffrey | Director | 210 W.Indiana Avenue Perrysburg Ohio 43551 Usa | American | 115618850001 | ||||||
| COLLETT, Brian | Director | 254 Old Church Road Chingford E4 8BT London | British | 32267100002 | ||||||
| COPPAGE, John Thomas | Director | Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Bridgeway House | England | American | 196214910001 | |||||
| DUXBURY, Howard | Director | Lower Gatehouse 8 Main Street NN7 1DQ Denton Northamptonshire | British | 76503680001 | ||||||
| FILECCIA, Piero | Director | 87 Derby Road DE72 3SY Risley Derbyshire | England | British | 116096800001 | |||||
| GOETTEL, Ralf | Director | Thalfinger Strasse 69 Neu-Ulm 89233 Germany | German | 115619190001 | ||||||
| JANSEN, Cletus Patrick | Director | 29 Craighill Road Knighton LE2 3FD Leicester Leicestershire | British | 14058290001 | ||||||
| JOHNSON, Ernest | Director | Blacksmith's Lodge Main Street Grandborough CV23 8DQ Rugby Warwickshire | British | 115683270001 | ||||||
| KING, William Lawrence | Director | The Old Laundry Horney Common TN22 3ED Uckfield East Sussex | British | 50541890002 | ||||||
| LAWRENCE, Andrew John | Director | St Ives 14 Shooters Hill Pangbourne RG8 7DU Reading Berkshire | British | 67813600001 | ||||||
| LOCKE, Anthony Robert | Director | 19 Hartropp Road B74 2RE Sutton Coldfield West Midlands | British | 120784980001 | ||||||
| MAIDMENT, Michael Edwin Walter | Director | Windmill Hill Biddenham MK40 4AG Bedford 1 | England | British | 29336340001 | |||||
| MAIDMENT, Michael Edwin Walter | Director | 1 Windmill Hill Biddenham MK40 4AG Bedford Bedfordshire | England | British | 29336340001 | |||||
| MURPHY, Peter John | Director | 7 Seaton Close Burbage LE10 2BW Hinckley Leicestershire | United Kingdom | British | 5874670001 | |||||
| POLLOCK, Robert Evans | Director | 29 Walnut Creek Drive Holland Ohio Oh 43528 Ohio | American | 89133770001 | ||||||
| RICHARDS, Caroline Ann | Director | Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Bridgeway House | United Kingdom | British | 178209940001 | |||||
| RIVARD, Jerome G | Director | 29401 Seaway Ct S Harrison Township Mi FOREIGN Usa 48045 | American | 52877540001 | ||||||
| SCOTT-GALL, Ian Harold | Director | Oakfields House East Garston RG17 7HD Hungerford Berkshire | United Kingdom | British | 380830002 | |||||
| WALD, Juergen | Director | Reinzstr 89233 Neu-Ulm 3-7 Germany | Germany | German | 173739660001 | |||||
| WALD, Martin Johannes Klaus | Director | Dorfstrasse 11 56288 Hollnich Germany | Germany | German | 156147730001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de AUTOMOTIVE MOTION TECHNOLOGY LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dana Incorporated | 06 abr 2016 | Technology Drive 43537 Maumee 3939 Ohio United States | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Echlin Europe Limited | 06 abr 2016 | Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Bridgeway House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0