KESTREL FM LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKESTREL FM LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03326134
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KESTREL FM LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra KESTREL FM LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Media House Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KESTREL FM LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KESTREL FM LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Exercice comptable précédent prolongé du 30 sept 2020 au 31 dic 2020

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2019

    7 páginasAA

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 01 oct 2020

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Share premium account cancelled 15/09/2020
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Memorándum y Estatutos

    11 páginasMA

    Declaración de confirmación presentada el 29 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Diedre Ann Ford el 31 ene 2019

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Modification des détails de Celador Radio Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 feb 2019

    2 páginasPSC05

    Cessation de Celador Entertainment Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 ene 2019

    1 páginasPSC07

    Notification de Celador Radio Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 ene 2019

    2 páginasPSC02

    Cese del nombramiento de Paul Adrian Smith como director el 31 ene 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Bauer Group Secretariat Limited como secretario el 31 ene 2019

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Paul Michael Charman como director el 31 ene 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Sarah Jane Vickery como director el 31 ene 2019

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Paul Anthony Keenan como director el 31 ene 2019

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Diedre Ann Ford como director el 31 ene 2019

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Celador Radio Roman Landing Kingsway Southampton Hampshire SO14 1BN England a Media House Peterborough Business Park Lynch Wood Peterborough PE2 6EA el 15 feb 2019

    1 páginasAD01

    ¿Quiénes son los directivos de KESTREL FM LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro00944753
    159023720001
    FORD, Deidre Ann
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Director
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    EnglandBritish255749500002
    KEENAN, Paul Anthony
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Director
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    EnglandBritish39692770004
    VICKERY, Sarah Jane
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Director
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    United KingdomBritish119137220002
    CHESTER, Brian Robert
    Millstone
    39 Windmill Field
    GU20 6QD Windlesham
    Surrey
    Secretario
    Millstone
    39 Windmill Field
    GU20 6QD Windlesham
    Surrey
    British68831100001
    CHRISTMAS, Colin Roy George
    College Place
    Alfred Road
    GU9 8JE Farnham
    4
    Surrey
    England
    Secretario
    College Place
    Alfred Road
    GU9 8JE Farnham
    4
    Surrey
    England
    British1678140002
    EUSTACE, Timothy
    7 Gardiner Close
    OX14 3YA Abingdon
    Oxfordshire
    Secretario
    7 Gardiner Close
    OX14 3YA Abingdon
    Oxfordshire
    British5555740001
    JOHNSON, Mark Alasdair Smith
    Long Acre
    WC2E 9LG London
    39
    United Kingdom
    Secretario
    Long Acre
    WC2E 9LG London
    39
    United Kingdom
    171903190001
    ROCHE, John Philip
    Wheathold Farm
    Ramsdell
    RG26 5SA Tadley
    Hampshire
    Secretario
    Wheathold Farm
    Ramsdell
    RG26 5SA Tadley
    Hampshire
    British30692560001
    YATES, Susan Ruth
    7 Woodbourne
    GU9 9EF Farnham
    Surrey
    Secretario
    7 Woodbourne
    GU9 9EF Farnham
    Surrey
    British55952690003
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secretario designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    ALLEN, Donald Gordon
    5 Heathrow Copse
    Baughurst
    RG26 5JG Basingstoke
    Hampshire
    Director
    5 Heathrow Copse
    Baughurst
    RG26 5JG Basingstoke
    Hampshire
    British38741630001
    ALLEN, Paul
    9 Alderney Avenue
    Hatch Warren
    RG22 4UA Basingstoke
    Hampshire
    Director
    9 Alderney Avenue
    Hatch Warren
    RG22 4UA Basingstoke
    Hampshire
    British81730010002
    AVIS, Richard Joseph Andrew
    8 Pamber Heath Road
    Pamber Heath
    RG26 3TQ Tadley
    Hampshire
    Director
    8 Pamber Heath Road
    Pamber Heath
    RG26 3TQ Tadley
    Hampshire
    EnglandBritish53550320001
    BAKER, John
    1 Pound Cottages
    Stroud Green
    RG14 7JH Newbury
    Berkshire
    Director
    1 Pound Cottages
    Stroud Green
    RG14 7JH Newbury
    Berkshire
    British122288220001
    CHAPMAN, Kimberlee Ann
    29 Queens Road
    Caversham
    RG4 8DN Reading
    Berkshire
    Director
    29 Queens Road
    Caversham
    RG4 8DN Reading
    Berkshire
    British68903800001
    CHARMAN, Paul Michael
    c/o P Charman
    Celador Radio Ltd
    Festival Place
    RG21 7LJ Basingstoke
    Suite 2 Paddington House
    England
    Director
    c/o P Charman
    Celador Radio Ltd
    Festival Place
    RG21 7LJ Basingstoke
    Suite 2 Paddington House
    England
    EnglandBritish226735460001
    CHESTER, Brian Robert
    Millstone
    39 Windmill Field
    GU20 6QD Windlesham
    Surrey
    Director
    Millstone
    39 Windmill Field
    GU20 6QD Windlesham
    Surrey
    EnglandBritish68831100001
    CHRISTMAS, Colin Roy George
    College Place
    Alfred Road
    GU9 8JE Farnham
    4
    Surrey
    England
    Director
    College Place
    Alfred Road
    GU9 8JE Farnham
    4
    Surrey
    England
    EnglandBritish1678140002
    CRAIG, Andrew Timms
    West Barn
    Manor Lane Oare
    RG18 9SB Hermitage
    Berkshire
    Director
    West Barn
    Manor Lane Oare
    RG18 9SB Hermitage
    Berkshire
    EnglandBritish34714840003
    CRAIG, Wendy Diane, Mrs.
    Coniston Drive
    GU9 0DA Farnham
    6
    Surrey
    Director
    Coniston Drive
    GU9 0DA Farnham
    6
    Surrey
    United KingdomBritish57867210001
    DOEL, Brian Gilroy
    Little Court
    PL20 6EF Yelverton
    Devon
    Director
    Little Court
    PL20 6EF Yelverton
    Devon
    EnglandBritish107694860001
    FAGAN, Florence Mary
    Deane Hill House
    Deane
    RG25 3AX Basingstoke
    Hampshire
    Director
    Deane Hill House
    Deane
    RG25 3AX Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritish18789240001
    FUSSEY, Stephen Frederick
    Frimley 4 Cedar Close
    RG26 3SL Tadley
    Hampshire
    Director
    Frimley 4 Cedar Close
    RG26 3SL Tadley
    Hampshire
    British53550330001
    HAROLD, Michael Victor
    The Maltings
    Mapledurwell
    RG25 2LJ Basingstoke
    Hampshire
    Director
    The Maltings
    Mapledurwell
    RG25 2LJ Basingstoke
    Hampshire
    British51992990001
    HAWKSLEY, Andrew
    c/o Celador Radio
    Kingsway
    SO14 1BN Southampton
    Romans Landing
    England
    Director
    c/o Celador Radio
    Kingsway
    SO14 1BN Southampton
    Romans Landing
    England
    EnglandBritish244980330001
    HOLMES, Ronald
    Ivy House
    Mapledurwell
    RG25 2LG Basingstoke
    Hampshire
    Director
    Ivy House
    Mapledurwell
    RG25 2LG Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritish26355080001
    HUGHES, Lawrence Edward
    Hilltops 3 Tadley Hill
    Tadley
    RG26 6PN Basingstoke
    Hampshire
    Director
    Hilltops 3 Tadley Hill
    Tadley
    RG26 6PN Basingstoke
    Hampshire
    British48194990001
    JOHNSON, Mark Alasdair Smith
    Long Acre
    WC2E 9LG London
    39
    United Kingdom
    Director
    Long Acre
    WC2E 9LG London
    39
    United Kingdom
    United KingdomBritish79195840006
    MANNING, Richard Denley John
    39 Ash Lane
    BA5 2LR Wells
    Somerset
    Director
    39 Ash Lane
    BA5 2LR Wells
    Somerset
    United KingdomBritish77961690001
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Director
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    EnglandBritish3182530002
    REEVE, Nigel John
    Links Farmhouse Ayleswade Lane
    Biddenden
    TN27 8LE Ashford
    Kent
    Director
    Links Farmhouse Ayleswade Lane
    Biddenden
    TN27 8LE Ashford
    Kent
    British59213560003
    REYNOLDS, Susan Anne
    115 Pack Lane
    Kempshott
    RG22 5HH Basingstoke
    Hants
    Director
    115 Pack Lane
    Kempshott
    RG22 5HH Basingstoke
    Hants
    EnglandBritish109984070001
    ROBERTSON, John
    8 The Chase
    Donnington
    RG14 3AQ Newbury
    Berkshire
    Director
    8 The Chase
    Donnington
    RG14 3AQ Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish4907930002
    ROCHE, John Philip
    Wheathold Farm
    Ramsdell
    RG26 5SA Tadley
    Hampshire
    Director
    Wheathold Farm
    Ramsdell
    RG26 5SA Tadley
    Hampshire
    British30692560001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de KESTREL FM LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    31 ene 2019
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05439096
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Kingsway
    St Marys Place
    SO14 1BN Southampton
    Roman Landing
    England
    06 abr 2016
    Kingsway
    St Marys Place
    SO14 1BN Southampton
    Roman Landing
    England
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05679435
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene KESTREL FM LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rent deposit deed
    Creado el 14 feb 2008
    Entregado el 22 feb 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £5000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All monies from time to time stanidng to the account pursuant to the rent deposit deed.
    Personas con derecho
    • Grosvenor Basingstoke Properties Limited and Grosvenor Basingstoke Management Limited
    Transacciones
    • 22 feb 2008Registro de un cargo (395)
    • 18 ene 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit deed
    Creado el 15 abr 1998
    Entregado el 24 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The observance and performance of the obligations of the tenant in the deed and the obligations of the lessee to grosvenor (basingstoke) limited under the lease
    Breve descripción
    The company's equitable interest in:(1) the sum of £5,000 paid by the company to the landlord and which the landlord is obliged under the deed to pay into the account (as defined).(2) any other sums paid into that account by the tenant pursuant to the deed and any interest credited to that account.
    Personas con derecho
    • Grosvenor (Basingstoke) Limited
    Transacciones
    • 24 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 10 feb 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 13 feb 1998
    Entregado el 18 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 18 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 31 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0