MARCHPOLE HOLDINGS PLC

MARCHPOLE HOLDINGS PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMARCHPOLE HOLDINGS PLC
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 03328638
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MARCHPOLE HOLDINGS PLC?

    • (5142) /

    ¿Dónde se encuentra MARCHPOLE HOLDINGS PLC?

    Dirección de la sede social
    c/o GRANT THORNTON LLP
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MARCHPOLE HOLDINGS PLC?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta05 abr 2008

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para MARCHPOLE HOLDINGS PLC?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MARCHPOLE HOLDINGS PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Finalización de la liquidación

    1 páginasL64.07

    Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 24 ago 2011

    2 páginas3.6

    legacy

    1 páginasLQ02

    Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 09 nov 2010

    2 páginas3.6

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal hasta 09 nov 2009

    2 páginas3.6

    Orden del tribunal para liquidar

    1 páginasCOCOMP

    Estado de situación patrimonial en la administración concursal tras el informe a los acreedores

    55 páginas3.3

    Informe del receptor administrativo

    13 páginas3.10

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    2 páginas403b

    legacy

    2 páginas403b

    legacy

    2 páginas403b

    legacy

    2 páginas403b

    legacy

    1 páginas405(1)

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 05 abr 2008

    62 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Company info 23/10/2008
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de autoridad para comprar un número de acciones

    RES09

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas88(2)

    legacy

    2 páginas123

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de aumento del capital social autorizado

    RES04
    capital

    Resolución de eliminación de derechos de suscripción preferente

    RES11
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    legacy

    10 páginas363s
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    annual-return21 ago 2008

    legacy

    363(353)

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de MARCHPOLE HOLDINGS PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SHULMAN, Harvey Barry
    88 Kingsley Way
    N2 0EN London
    Secretario
    88 Kingsley Way
    N2 0EN London
    British1239130001
    HARRIS, Raymond Ian
    3 Golfside Close
    N20 0RD London
    Director
    3 Golfside Close
    N20 0RD London
    United KingdomBritish91547170001
    LADOW, Allan
    Igelkottstigen 5
    Hovas
    43650
    Sweden
    Director
    Igelkottstigen 5
    Hovas
    43650
    Sweden
    Swedish132918310001
    MOLLOY, John Patrick
    117 Lonsdale Road
    Barnes
    SW13 9DA London
    Director
    117 Lonsdale Road
    Barnes
    SW13 9DA London
    EnglandBritish125361860001
    MORRIS, Michael Maurice
    5 Pipers Green Lane
    HA7 4LS Brockley Hill
    Stanmore
    Director
    5 Pipers Green Lane
    HA7 4LS Brockley Hill
    Stanmore
    United KingdomBritish117529460001
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    17 Greenfield Drive
    Fortes Green
    N2 9AF London
    Director
    17 Greenfield Drive
    Fortes Green
    N2 9AF London
    EnglandBritish46176700002
    SHULMAN, Harvey Barry
    88 Kingsley Way
    N2 0EN London
    Director
    88 Kingsley Way
    N2 0EN London
    EnglandBritish1239130001
    STIRLING, Ronald Edward
    The White Cottage
    21 Randolph Road
    W9 1AN London
    Director
    The White Cottage
    21 Randolph Road
    W9 1AN London
    British20434210001
    BRADFIELD, David Warren
    25 Oak Drive
    SG16 6BX Henlow
    Bedfordshire
    Secretario
    25 Oak Drive
    SG16 6BX Henlow
    Bedfordshire
    British66000710004
    HAMPSHIRE, James Justin
    28 Heslop Road
    SW12 8EG London
    Secretario
    28 Heslop Road
    SW12 8EG London
    British83282010001
    KIERNAN, James Francis
    111 Telscombe Way
    LU2 8QP Sheldon
    Birmingham
    Secretario
    111 Telscombe Way
    LU2 8QP Sheldon
    Birmingham
    British87389050001
    TAHMASEBI, Khosrow
    The Paddocks
    3 Lavender Close
    CR3 5DW Chaldon Common
    Surrey
    Secretario
    The Paddocks
    3 Lavender Close
    CR3 5DW Chaldon Common
    Surrey
    British38518070001
    TAYLOR, Charles Robert
    77 Plover Way
    Surrey Quays
    SE16 7TS London
    Secretario
    77 Plover Way
    Surrey Quays
    SE16 7TS London
    British72657510001
    WIEDER, Robert
    185 Adelaide Road
    NW3 3NN London
    Secretario
    185 Adelaide Road
    NW3 3NN London
    British85513530001
    ALLNER, Christopher Charles
    Childs Farm
    Woodrow
    HP7 0QQ Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    Childs Farm
    Woodrow
    HP7 0QQ Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish78206300001
    BIGNALL, John
    Mistletoe Farm
    Cuckoo Hill
    HA5 2BB Pinner
    Middlesex
    Director
    Mistletoe Farm
    Cuckoo Hill
    HA5 2BB Pinner
    Middlesex
    British907580001
    BOOTHMAN, Derek Arnold
    Ashworth Dene
    Wilmslow Road Mottram St Andrew
    SK10 4QH Macclesfield
    Cheshire
    Director
    Ashworth Dene
    Wilmslow Road Mottram St Andrew
    SK10 4QH Macclesfield
    Cheshire
    British5733500001
    BRADFIELD, David Warren
    25 Oak Drive
    SG16 6BX Henlow
    Bedfordshire
    Director
    25 Oak Drive
    SG16 6BX Henlow
    Bedfordshire
    British66000710004
    BUTLER, Roger John
    1a 14 Bramham Gardens
    SW5 0JJ London
    Director
    1a 14 Bramham Gardens
    SW5 0JJ London
    British3453620004
    CAPLIN, Anthony Lindsay
    Elm Lodge
    River Gardens
    SW6 6NZ London
    22
    Director
    Elm Lodge
    River Gardens
    SW6 6NZ London
    22
    United KingdomBritish139900020001
    COX, Andrew Douglas
    56 Centre Quay
    Burlington Road Port Marine
    BS20 7AX Portishead
    Avon
    Director
    56 Centre Quay
    Burlington Road Port Marine
    BS20 7AX Portishead
    Avon
    British101923580001
    GILLIATT, John Mowbray
    9 Banbury Road
    CV37 7HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Director
    9 Banbury Road
    CV37 7HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    ScotlandBritish169894800001
    GRAY, Ian Archie
    6 Baronsmead Road
    SW13 9RR London
    Director
    6 Baronsmead Road
    SW13 9RR London
    EnglandBritish115801110001
    HAMPSHIRE, James Justin
    28 Heslop Road
    SW12 8EG London
    Director
    28 Heslop Road
    SW12 8EG London
    United KingdomBritish83282010001
    HARRISON, John
    Goodwin Manor
    Swaffham Prior
    CB5 0LG Cambridge
    Director
    Goodwin Manor
    Swaffham Prior
    CB5 0LG Cambridge
    EnglandBritish104830840001
    JOHNSON, Adrian Robert Barnett
    5 Wilberforce Way
    Lauriston Road Wimbledon Common
    SW19 4TH London
    Director
    5 Wilberforce Way
    Lauriston Road Wimbledon Common
    SW19 4TH London
    British57119570001
    KERR-MUIR, James Rodier
    Flat 8 71 Elm Park Gardens
    SW10 9QE London
    Director
    Flat 8 71 Elm Park Gardens
    SW10 9QE London
    British37895700002
    MACAULAY, John Arnold
    51 Dove Park
    WD3 5NY Chorley Wood
    Hertfordshire
    Director
    51 Dove Park
    WD3 5NY Chorley Wood
    Hertfordshire
    United KingdomBritish154398330001
    MATTEY, David Gary
    10 Royal Avenue
    SW3 4QF London
    Director
    10 Royal Avenue
    SW3 4QF London
    EnglandBritish7199250004
    MELBOURN, John William
    4 Berkeley Gardens
    Claygate
    KT10 0TP Esher
    Surrey
    Director
    4 Berkeley Gardens
    Claygate
    KT10 0TP Esher
    Surrey
    EnglandBritish6081080001
    MESSIK, John Charles
    Flat 1
    16 Lyndhurst Gardens
    NW3 5NR London
    Director
    Flat 1
    16 Lyndhurst Gardens
    NW3 5NR London
    British41030750004
    MORRIS, Michael Maurice
    5 Pipers Green Lane
    HA7 4LS Brockley Hill
    Stanmore
    Director
    5 Pipers Green Lane
    HA7 4LS Brockley Hill
    Stanmore
    United KingdomBritish117529460001
    MOSS, David Harry
    7 St Marys Grove
    SW13 0JA London
    Director
    7 St Marys Grove
    SW13 0JA London
    United KingdomBritish93660650001
    REYNOLDS, Adam
    14 Charles Harrod Court
    Harrods Village
    SW13 8HH Barnes
    London
    Director
    14 Charles Harrod Court
    Harrods Village
    SW13 8HH Barnes
    London
    United KingdomBritish85661680003
    SANTELL, Hilary Anne
    The Stables Mountains
    Noble Tree Road
    TN11 8ND Hildenborough
    Kent
    Director
    The Stables Mountains
    Noble Tree Road
    TN11 8ND Hildenborough
    Kent
    British66561080002

    ¿Tiene MARCHPOLE HOLDINGS PLC alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 06 ago 2008
    Entregado el 19 ago 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Atlas
    Transacciones
    • 19 ago 2008Registro de un cargo (395)
    • 05 ene 2009Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    Pledge of quota
    Creado el 24 mar 2006
    Entregado el 11 abr 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Pledge over all quota owned by the company in J.C.de castelbajac italy srl and any rights attached to that quota.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 11 abr 2006Registro de un cargo (395)
    Agreement for the pledge of account of financial instruments relating to shares of jean-charles de castelbajac S.A.
    Creado el 21 mar 2006
    Entregado el 24 mar 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Pledge over all shares and financial instruments owned by the company in jean-charles de castelbajac S.A. and any rights attached to those shares and financial instruments.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 24 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 05 ene 2009Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    Pledge agreement
    Creado el 07 mar 2006
    Entregado el 17 mar 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Pledge over all membership interests owned by the company in moda america llc and any rights attached to those membership interests.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 17 mar 2006Registro de un cargo (395)
    Charge over shares in marchpole hong kong limited
    Creado el 07 mar 2006
    Entregado el 17 mar 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed charge over all shares owned by the company in marchpole hong kong limited and any rights attached to those shares.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 17 mar 2006Registro de un cargo (395)
    Charge over shares in J.c de castelbajac hong kong limited
    Creado el 07 mar 2006
    Entregado el 17 mar 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed charge over all shares owned by the company in J.c de castelbajac hong kong limited and any rights attached to those shares.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 17 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 05 ene 2009Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    Debenture
    Creado el 29 jul 2002
    Entregado el 31 jul 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 31 jul 2002Registro de un cargo (395)
    • 11 nov 2008Nombramiento de un receptor o gerente (405 (1))
    • 05 ene 2009Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 122 jul 2011Aviso de cese de funciones como receptor o gerente (LQ02)
      • Número de expediente 1
    Debenture
    Creado el 16 may 2002
    Entregado el 22 may 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The sum of £250,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the entire business and assets of marchpole holdings PLC.
    Personas con derecho
    • Downash Consulting Limited
    Transacciones
    • 22 may 2002Registro de un cargo (395)
    • 06 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 11 sept 2000
    Entregado el 19 sept 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 19 sept 2000Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over book debts
    Creado el 06 jun 2000
    Entregado el 26 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific charge over the benefit of all book debts and other debts due or owing to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 26 jun 2000Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 12 may 1998
    Entregado el 15 may 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The l/h property k/a 19/20 berners street london W1 t/n NGL724255. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 15 may 1998Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental deed to deed of assignment of life policy
    Creado el 26 sept 1997
    Entregado el 16 oct 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All amounts of principal interest or otherwise and obligations which at any time after 5TH april 1997 may be due owing or incurred under the loan note instrument and the notes by the company to the noteholders (as defined) and/or the chargee (as trustee) up to but not exceeding £10,000 000 from 5TH april 1997 until and including 31ST march 1998 and up to but not exceeding £5,000,000 from 1ST april 1998 until and including 31ST march 1999
    Breve descripción
    Policy number 24276-088-das and 24277-088-das on the life of michael morris in the sum of £5,000,000 and £5,000,000 with allied dunbar assurance PLC with all bonuses accrued.
    Personas con derecho
    • Natwest Ventures (Nominees) Limited
    Transacciones
    • 16 oct 1997Registro de un cargo (395)
    • 12 dic 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of assignment of life policy
    Creado el 05 abr 1997
    Entregado el 10 abr 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument and the notes up to but not exceeding £10,000,000 from 5TH april 1997 until and including 31ST march 1998 and up to but not exceeding £5,000,000 from 1ST april 1998 until and including 31ST march 1999
    Breve descripción
    With full title guarantee the policy and monies inlcuding bonuses on the life of michael morris policy number 24276-081-das & 24277-081-das for £5,000,000 and £5000,000. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Natwest Ventures (Nominees) Limited
    Transacciones
    • 10 abr 1997Registro de un cargo (395)
    • 12 dic 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene MARCHPOLE HOLDINGS PLC algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1Administrador judicial nombrado
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Martin Gilbert Ellis
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    Administrador judicial
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    Andrew Lawrence Hosking
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Administrador judicial
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    FechaTipo
    16 jun 2015Conclusión de la liquidación
    14 may 2009Fecha de la petición
    01 jul 2009Inicio de la liquidación
    22 sept 2015Fecha de disolución
    Liquidación forzosa
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Profesional
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0