YOUNG KENT

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaYOUNG KENT
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
    Número de empresa 03328952
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de YOUNG KENT?

    • Actividades de otras organizaciones de miembros n.c.p. (94990) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra YOUNG KENT?

    Dirección de la sede social
    36 Hedley Street
    ME14 5AD Maidstone
    Kent
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de YOUNG KENT?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    KENT YOUTH.02 ago 200102 ago 2001
    KENT YOUTH ASSOCIATION31 mar 199831 mar 1998
    KENT ASSOCIATION OF YOUTH CLUBS 06 mar 199706 mar 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de YOUNG KENT?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para YOUNG KENT?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 23 ago 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 1

    1 páginasMR04

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2018

    24 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 ago 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Sarah Landry como director el 05 oct 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2017

    25 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 ago 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Peter Victor Martin como director el 20 mar 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Janet Mary Stephens como director el 20 mar 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Sarah Anne Landry como director el 20 mar 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Andrea Ashman como director el 20 mar 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Alan Bernstein como director el 30 mar 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Timothy Norman Lister como director el 30 ago 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Rupert Patrick Allinson como director el 30 ago 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Andrew James Steel como director el 14 oct 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Rebecca Martin como director el 27 sept 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2016

    28 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 ago 2016 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Terry Hewett como director el 01 sept 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 23 ago 2015, aucune liste de membres fournie

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2015

    28 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de YOUNG KENT?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ASHMAN, Andrea
    Discovery Road
    Bearsted
    ME15 8HF Maidstone
    28
    England
    Director
    Discovery Road
    Bearsted
    ME15 8HF Maidstone
    28
    England
    United KingdomBritish193240430001
    HARDY, Carole Ann
    Hedley Street
    ME14 5AD Maidstone
    36
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Hedley Street
    ME14 5AD Maidstone
    36
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish169762760001
    MARSH, Robert John
    Hedley Street
    ME14 5AD Maidstone
    36
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Hedley Street
    ME14 5AD Maidstone
    36
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish169762270001
    MARTIN, Peter Victor
    520 Pilgrims Way
    Wouldham
    ME1 3RB Rochester
    Woodbanks
    England
    Director
    520 Pilgrims Way
    Wouldham
    ME1 3RB Rochester
    Woodbanks
    England
    United KingdomBritish27060120002
    STEPHENS, Janet Mary
    Golding Close
    ME1 2QY Rochester
    14
    Kent
    England
    Director
    Golding Close
    ME1 2QY Rochester
    14
    Kent
    England
    United KingdomBritish98067090001
    CLEWES, Graham Charles
    10 Ash Road
    DA3 8BQ Hartley
    Kent
    Secretario
    10 Ash Road
    DA3 8BQ Hartley
    Kent
    British91003680003
    PAPADEMETRIE, Susan
    Liatwatch Sutton Road
    Langley
    ME17 3NF Maidstone
    Kent
    Secretario
    Liatwatch Sutton Road
    Langley
    ME17 3NF Maidstone
    Kent
    British51673950001
    RICE, James Leonard
    27 The Old Yews
    New Barn
    DA3 7JS Longfield
    Kent
    Secretario
    27 The Old Yews
    New Barn
    DA3 7JS Longfield
    Kent
    British4165770001
    RICE, James Leonard
    27 The Old Yews
    New Barn
    DA3 7JS Longfield
    Kent
    Secretario
    27 The Old Yews
    New Barn
    DA3 7JS Longfield
    Kent
    British4165770001
    ALGAR, Mark Robert
    57 The Street
    Cobham
    DA12 3BX Gravesend
    Kent
    Director
    57 The Street
    Cobham
    DA12 3BX Gravesend
    Kent
    British56569370001
    ALLINSON, Rupert Patrick
    Hedley Street
    ME14 5AD Maidstone
    36
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Hedley Street
    ME14 5AD Maidstone
    36
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish64986020001
    AUST, John Derek
    7 High Pines
    Homefield Road
    CR6 9HQ Warlingham
    Surrey
    Director
    7 High Pines
    Homefield Road
    CR6 9HQ Warlingham
    Surrey
    United KingdomBritish11286670004
    AUSTIN-BROOKS, John William
    Hedley Street
    ME14 5AD Maidstone
    36
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Hedley Street
    ME14 5AD Maidstone
    36
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish178429320001
    BANCROFT, James
    Hedley Street
    ME14 5AD Maidstone
    36
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Hedley Street
    ME14 5AD Maidstone
    36
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish160537270001
    BERNSTEIN, Alan
    Hedley Street
    ME14 5AD Maidstone
    36
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Hedley Street
    ME14 5AD Maidstone
    36
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish96372810001
    BIRRELL, Lois Denise
    New Hythe Lane
    Larkfield
    ME20 6SG Aylesford
    Messenger House
    Kent
    United Kingdom
    Director
    New Hythe Lane
    Larkfield
    ME20 6SG Aylesford
    Messenger House
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish137152950001
    BISH, Micky
    73 Grove Road
    ME15 9AU Maidstone
    Kent
    Director
    73 Grove Road
    ME15 9AU Maidstone
    Kent
    United KingdomBritish58425610001
    BLOW, Stanley
    Lion And Lamb Cottage Pear Tree Row
    Sutton Road Langley
    ME17 3NF Maidstone
    Kent
    Director
    Lion And Lamb Cottage Pear Tree Row
    Sutton Road Langley
    ME17 3NF Maidstone
    Kent
    British57233390001
    BOORMAN, Edwin Roy Pratt
    Redhill Farm
    339 Redhill Waterinbury
    ME18 5LB Maidstone
    Kent
    Director
    Redhill Farm
    339 Redhill Waterinbury
    ME18 5LB Maidstone
    Kent
    United KingdomBritish35538290001
    CAMBELL-SMITH, Robert, Rev Canon
    The Vicarage
    Goudhurst
    TN17 1AN Cranbrook
    Kent
    Director
    The Vicarage
    Goudhurst
    TN17 1AN Cranbrook
    Kent
    British57746430001
    CLARKE, Paul
    13 Meadow Walk
    ME15 7RY Maidstone
    Kent
    Director
    13 Meadow Walk
    ME15 7RY Maidstone
    Kent
    British43843780001
    CLOUT, Barry
    21 Taverners Road
    ME8 9AW Rainham
    Kent
    Director
    21 Taverners Road
    ME8 9AW Rainham
    Kent
    United KingdomBritish43843820001
    COLLINS, Belinda Marie
    Hedley Street
    ME14 5AD Maidstone
    36
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Hedley Street
    ME14 5AD Maidstone
    36
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish151541570001
    COOMBS, Peter John
    92 Canterbury Road
    Lydden
    CT15 7ET Dover
    Kent
    Director
    92 Canterbury Road
    Lydden
    CT15 7ET Dover
    Kent
    British51673940001
    DHADWAL, Paramjot Kaur Sarai
    Tera Ghar 254 Brompton Farm Road
    Frindsbury
    ME2 3NP Rochester
    Kent
    Director
    Tera Ghar 254 Brompton Farm Road
    Frindsbury
    ME2 3NP Rochester
    Kent
    EnglandBritish89850760001
    DIMENT, Elizabeth Diane
    59 Acorn Grove
    Ditton
    ME20 6EL Aylesford
    Kent
    Director
    59 Acorn Grove
    Ditton
    ME20 6EL Aylesford
    Kent
    British96748860001
    EASON, Richard Mark Lloyd
    Hedley Street
    ME14 5AD Maidstone
    36
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Hedley Street
    ME14 5AD Maidstone
    36
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish29965770001
    EVERETT, John
    36 Willow Rise
    Downswood
    ME15 8XR Maidstone
    Kent
    Director
    36 Willow Rise
    Downswood
    ME15 8XR Maidstone
    Kent
    British56854790002
    FOWLE, Andrew James
    25 Clifton Close
    Strood
    ME2 2HG Rochester
    Kent
    Director
    25 Clifton Close
    Strood
    ME2 2HG Rochester
    Kent
    British56854750001
    FROWDE, Peter Roderick
    Hillcrest Preston Hill
    Wingham
    CT3 1DB Canterbury
    Kent
    Director
    Hillcrest Preston Hill
    Wingham
    CT3 1DB Canterbury
    Kent
    EnglandBritish23009860001
    GEORGE, Marisa
    305 Rochester Road
    Burham
    ME1 3RS Rochester
    Kent
    Director
    305 Rochester Road
    Burham
    ME1 3RS Rochester
    Kent
    British59864210001
    GILBERT, Sarah
    New Hythe Lane
    Larkfield
    ME20 6SG Aylesford
    Messenger House
    Kent
    United Kingdom
    Director
    New Hythe Lane
    Larkfield
    ME20 6SG Aylesford
    Messenger House
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish137242590001
    HAWKER, Sharon Louise
    1 Sittingbourne Road
    ME14 5ER Maidstone
    Kent
    Director
    1 Sittingbourne Road
    ME14 5ER Maidstone
    Kent
    British70976250001
    HEWETT, Terry
    Hedley Street
    ME14 5AD Maidstone
    36
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Hedley Street
    ME14 5AD Maidstone
    36
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish155005740001
    HOLMES, Joanne Mary
    New Hythe Lane
    Larkfield
    ME20 6SG Aylesford
    Messenger House
    Kent
    United Kingdom
    Director
    New Hythe Lane
    Larkfield
    ME20 6SG Aylesford
    Messenger House
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish131578350001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para YOUNG KENT?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    23 ago 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene YOUNG KENT alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage
    Creado el 20 dic 2012
    Entregado el 22 dic 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company
    Breve descripción
    F/H land and building k/a 36 hedley street, maidstone, kent t/no K306460.
    Personas con derecho
    • Kent Youth Trust
    Transacciones
    • 22 dic 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 07 may 2019Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0