WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED

WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03337345
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED?

    • Otras instalaciones de construcción (43290) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Paul Scott como director el 22 ene 2015

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Mr John William Young Strachan Samuel como director el 22 ene 2015

    3 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2014

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 ene 2015

    Estado de capital el 08 ene 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cancelación total de la carga 3

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    4 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 ene 2014

    Estado de capital el 06 ene 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Déclaration annuelle établie au 01 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2012

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2011

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 ene 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2010

    5 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2009

    5 páginasAA

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    Déclaration annuelle établie au 01 ene 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2008

    5 páginasAA

    legacy

    1 páginas353

    ¿Quiénes son los directivos de WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RENEW NOMINEES LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Secretario corporativo
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    41291250014
    SAMUEL, John William Young Strachan
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    West Yorkshire
    England
    Director
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish3909060002
    RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Director corporativo
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    91993060004
    BARKER, Roger Winston
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    Secretario
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    British59419910001
    HILL, David Robert
    Low House
    Lowes Water
    CA13 9UX Cockermouth
    Secretario
    Low House
    Lowes Water
    CA13 9UX Cockermouth
    British18429260002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secretario designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BARKER, Roger Winston
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    British59419910001
    DAWES, John Brian
    Holly Lodge
    Arkleby
    CA7 2BT Wigton
    Cumbria
    Director
    Holly Lodge
    Arkleby
    CA7 2BT Wigton
    Cumbria
    EnglandBritish10253750001
    FEAST, Roger
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    Director
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    British66800550001
    HILL, David Robert
    Low House
    Lowes Water
    CA13 9UX Cockermouth
    Director
    Low House
    Lowes Water
    CA13 9UX Cockermouth
    British18429260002
    LITTLEHALES, Richard
    Aisling Cottage
    Back Church Lane
    LS16 8DW Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Aisling Cottage
    Back Church Lane
    LS16 8DW Leeds
    West Yorkshire
    British57288230002
    MCARTHUR, Alexander Nigel
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Director
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    British1571200002
    PEARSON, Valerie
    Phoenix House
    Hawthorn Park
    LS14 1PQ Leeds
    Director
    Phoenix House
    Hawthorn Park
    LS14 1PQ Leeds
    British82999480006
    SCOTT, Paul
    The Burroughs
    Papcastle
    CA13 0JN Cockermouth
    Cumbria
    Director
    The Burroughs
    Papcastle
    CA13 0JN Cockermouth
    Cumbria
    EnglandBritish63708460003
    UNDERWOOD, Philip John
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Director
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    British59420330009
    WAREING, Anthony James
    4 Craig Road
    CA14 3JX Workington
    Cumbria
    Director
    4 Craig Road
    CA14 3JX Workington
    Cumbria
    United KingdomBritish17422620001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Director designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    ¿Tiene WEST CUMBERLAND INSULATION (1997) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 05 ene 2005
    Entregado el 20 ene 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 20 ene 2005Registro de un cargo (395)
    • 30 dic 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 16 abr 1999
    Entregado el 20 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 20 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 30 dic 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creado el 09 may 1997
    Entregado el 14 may 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 14 may 1997Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0