SEASIDE SU1 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSEASIDE SU1 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03338717
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SEASIDE SU1 LIMITED?

    • Otras actividades deportivas (93199) / Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

    ¿Dónde se encuentra SEASIDE SU1 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SEASIDE SU1 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SHEFFIELD UNITED ACADEMY LIMITED06 feb 200206 feb 2002
    SHEFFIELD UNITED (ABBEYDALE GRANGE) LIMITED02 sept 199702 sept 1997
    BROOMCO (1244) LIMITED24 mar 199724 mar 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SEASIDE SU1 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para SEASIDE SU1 LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SEASIDE SU1 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2013

    6 páginasAA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Julian Winter como director

    1 páginasTM01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed sheffield united academy LIMITED\certificate issued on 06/09/13
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name06 sept 2013

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 30 ago 2013

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Nombramiento de Esplanade Director Limited como director

    2 páginasAP02

    Nombramiento de Mr Julian Winter como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 24 mar 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 abr 2013

    Estado de capital el 24 abr 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2012

    6 páginasAA

    Nombramiento de Mr Craig Burns como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Julian Winter como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 24 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2011

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de David Harrop como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Craig Burns como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de David Harrop como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Julian Winter como director

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Mr Simon Charles Mccabe el 14 jul 2011

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Trevor Birch como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 24 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Simon Charles Mccabe el 19 nov 2010

    3 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2010

    6 páginasAA

    legacy

    4 páginasMG02

    ¿Quiénes son los directivos de SEASIDE SU1 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BURNS, Craig
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    Secretario
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    167993580001
    BURNS, Craig
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    Director
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    EnglandBritish167991320001
    DUDLEY, David Michael
    21 Weston View
    Crookes
    S10 5BZ Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    21 Weston View
    Crookes
    S10 5BZ Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish125782620001
    MCCABE, Simon Charles
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Director
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish154915110001
    ESPLANADE DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Director corporativo
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro01633267
    180712410001
    CAPPER, Simon
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Secretario
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    British118147580002
    FENOUGHTY, Mark Thomas
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    British91397360003
    HARROP, David
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    Secretario
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    153053780001
    MANNING, Michael Atkinson
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    Secretario
    67 Postern Close
    YO23 1JF York
    North Yorkshire
    British20393860001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    ARMSTRONG, Gary John, Dr
    9 Clarkson Row
    Mornington Terrace
    NW1 7RA London
    Director
    9 Clarkson Row
    Mornington Terrace
    NW1 7RA London
    United Kingdom British 81787340001
    BAMFORD, Alan Maxwell
    Stonecroft 53 Vicarage Lane
    Dore
    S17 3GX Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    Stonecroft 53 Vicarage Lane
    Dore
    S17 3GX Sheffield
    South Yorkshire
    British11424620001
    BIRCH, Trevor
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    South Yorkshire
    Director
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    South Yorkshire
    UkBritish160667800001
    CAPPER, Simon
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Director
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    United KingdomBritish118147580002
    DOOLEY, Derek
    83 Norton Park View
    S8 8GU Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    83 Norton Park View
    S8 8GU Sheffield
    South Yorkshire
    British34642040001
    FENOUGHTY, Mark Thomas
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    British91397360003
    GREEN, Charles Alexander
    Oak Tree Farm
    Blankney Barff
    LN4 3BJ Wetheringham
    Lincolnshire
    Director
    Oak Tree Farm
    Blankney Barff
    LN4 3BJ Wetheringham
    Lincolnshire
    British75952680002
    HARROP, David Anthony
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    Director
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    EnglandBritish160187290001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    MCDONALD, Anthony Michael
    Glenwood Cottage 25 Andrew Lane
    High Lane
    SK6 8HX Stockport
    Cheshire
    Director
    Glenwood Cottage 25 Andrew Lane
    High Lane
    SK6 8HX Stockport
    Cheshire
    British51141710003
    ROBINSON, Terence James
    The Long Barn
    Hollymount Lane, Greenmount
    BL8 4HP Bury
    Lancashire
    Director
    The Long Barn
    Hollymount Lane, Greenmount
    BL8 4HP Bury
    Lancashire
    EnglandBritish107314140001
    ROCKETT, Jason
    Bramall Lane
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Director
    Bramall Lane
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    United KingdomBritish111427410006
    SLINN, Stephen
    17 Owlthorpe Drive
    Mosborough
    S20 5JU Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    17 Owlthorpe Drive
    Mosborough
    S20 5JU Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish72785350001
    THURMAN, John Lythall
    Rosebank 8 Moor Lane
    Kirk Langley
    DE6 4LQ Ashbourne
    Derbyshire
    Director
    Rosebank 8 Moor Lane
    Kirk Langley
    DE6 4LQ Ashbourne
    Derbyshire
    British41580370003
    TOWNSEND, Ian
    Homelands
    Upper Dunsforth
    YO26 9RU Great Ouseburn York
    Director
    Homelands
    Upper Dunsforth
    YO26 9RU Great Ouseburn York
    United KingdomBritish26617400002
    WARNOCK, William John
    33 Hallwood Road
    Burncross
    S35 1TR Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    33 Hallwood Road
    Burncross
    S35 1TR Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish82114730001
    WINTER, Julian
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    Director
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    EnglandBritish163637880001
    WINTER, Julian
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    Director
    Bramall Lane
    Sheffield
    S2 4SU South Yorkshire
    EnglandBritish163637880001
    WOOD, Peter Philip
    Flat 45 Whinfell Court
    Eccleshall Road
    S11 9QA Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    Flat 45 Whinfell Court
    Eccleshall Road
    S11 9QA Sheffield
    South Yorkshire
    British59507480001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Director designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Director designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001

    ¿Tiene SEASIDE SU1 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 09 oct 2002
    Entregado el 11 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/Hold land on the east side of shirecliffe rd,sheffield; SYK168119.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 17 sept 2002
    Entregado el 21 sept 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 sept 2002Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0