SITEX GROUP HOLDINGS LIMITED

SITEX GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSITEX GROUP HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03339001
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SITEX GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • (7415) /

    ¿Dónde se encuentra SITEX GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Beaufort House
    Cricket Field Road
    UB8 1QG Uxbridge
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SITEX GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DMWSL 191 LIMITED24 mar 199724 mar 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SITEX GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SITEX GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 24 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 abr 2011

    Estado de capital el 12 abr 2011

    • Capital: GBP 211,126.87
    SH01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2010

    1 páginasAA

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    Déclaration annuelle établie au 24 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    15 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2009

    1 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Stephen John Crabb el 30 nov 2009

    1 páginasCH03

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas225

    Cuentas preparadas hasta el 30 sept 2007

    1 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de SITEX GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CRABB, Stephen John
    Abbotswood
    HP27 0SR Speen
    4
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Abbotswood
    HP27 0SR Speen
    4
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Other83334300001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Secretario corporativo
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    CUNNINGHAM, Oliver Mark
    Bridge Farm Close
    Grove
    OX12 7QF Wantage
    2
    Oxon
    Director
    Bridge Farm Close
    Grove
    OX12 7QF Wantage
    2
    Oxon
    EnglandBritish135852790001
    DIBBLE, Keith George
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    Secretario
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    British82410610001
    EMERY, Patricia Frances
    3 Rye Close
    RG12 2QY Bracknell
    Berkshire
    Secretario
    3 Rye Close
    RG12 2QY Bracknell
    Berkshire
    British53909400002
    EVANS, Jonathan
    7 Maria Terrace
    Stepney
    E1 4NE London
    Secretario
    7 Maria Terrace
    Stepney
    E1 4NE London
    British44018040001
    JENNINGS, Thomas David
    Hinton 48a Murray Road
    HA6 2YL Northwood
    Middlesex
    Secretario
    Hinton 48a Murray Road
    HA6 2YL Northwood
    Middlesex
    British47666540003
    JUKES, John Kenneth
    39 Westwater Way
    OX11 7SR Didcot
    Oxfordshire
    Secretario
    39 Westwater Way
    OX11 7SR Didcot
    Oxfordshire
    British52056580002
    VAN DER PANT, Gavin Lawrence
    9 Westfield Cottages
    Henley Road
    SL7 2HQ Medmenham
    Buckinghamshire
    Secretario
    9 Westfield Cottages
    Henley Road
    SL7 2HQ Medmenham
    Buckinghamshire
    British72310190001
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Secretario designado corporativo
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    ALTY, Merlin John
    18 Ronneby Close
    KT13 9SB Weybridge
    Surrey
    Director
    18 Ronneby Close
    KT13 9SB Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish25352070001
    BRENTNALL, Trevor Alan
    Dolloways House
    Howbourne Lane
    TN22 4DR Buxted
    East Sussex
    Director
    Dolloways House
    Howbourne Lane
    TN22 4DR Buxted
    East Sussex
    British39686000001
    BROOKER, Ian
    Mashie Niblick Foxbury
    Maidstone Road Platt
    TN15 8JE Sevenoaks
    Kent
    Director
    Mashie Niblick Foxbury
    Maidstone Road Platt
    TN15 8JE Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish104323600001
    CLUBB, Ian Mcmaster
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    Director
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    British3485960001
    CRABB, Stephen John
    44 Ernest Gardens
    Chiswick
    W4 3QU London
    Director
    44 Ernest Gardens
    Chiswick
    W4 3QU London
    Other83334300001
    CRABB, Stephen John
    44 Ernest Gardens
    Chiswick
    W4 3QU London
    Director
    44 Ernest Gardens
    Chiswick
    W4 3QU London
    Other83334300001
    EDWARDS, Stephen Peter
    The Grange
    Lamberhurst Quarter
    TN3 8AN Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    The Grange
    Lamberhurst Quarter
    TN3 8AN Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish147275950001
    HOLMES, Michael Harry
    Beechcroft Hophurst Hill
    Crawley Down
    RH10 4LW Crawley
    West Sussex
    Director
    Beechcroft Hophurst Hill
    Crawley Down
    RH10 4LW Crawley
    West Sussex
    EnglandBritish52804410002
    HORTON, Jonathan Raymond
    51 Aldensley Road
    W6 0DH London
    Director
    51 Aldensley Road
    W6 0DH London
    United KingdomBritish94144740001
    JENNINGS, Thomas David
    Commonwood Cottage Common Wood
    WD4 9BA Kings Langley
    Hertfordshire
    Director
    Commonwood Cottage Common Wood
    WD4 9BA Kings Langley
    Hertfordshire
    UkBritish47666540004
    JUKES, John Kenneth
    39 Westwater Way
    OX11 7SR Didcot
    Oxfordshire
    Director
    39 Westwater Way
    OX11 7SR Didcot
    Oxfordshire
    United KingdomBritish52056580002
    MORRIS, Brian Bertram
    14 Ronald Close
    BR3 3HX Beckenham
    Kent
    Director
    14 Ronald Close
    BR3 3HX Beckenham
    Kent
    United KingdomBritish56301270001
    QUINLAN, Ian
    3 The Courtyard
    Victoria Road
    SL7 1DW Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    3 The Courtyard
    Victoria Road
    SL7 1DW Marlow
    Buckinghamshire
    British2521720003
    RANDALL, Martin Keith
    Jacks Platt
    Duddleswell
    TN22 3JR Uckfield
    East Sussex
    Director
    Jacks Platt
    Duddleswell
    TN22 3JR Uckfield
    East Sussex
    United KingdomBritish40012240002
    RIEGER, Anthony William
    45 Burkes Road
    HP9 1PW Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    45 Burkes Road
    HP9 1PW Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British80849320001
    SHARMAN, Jeremy William
    Harborough Hill House
    NN17 3DD Gretton
    Northamptonshire
    Director
    Harborough Hill House
    NN17 3DD Gretton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish57824380002
    VENESS, Jaqueline Susan
    22 Murrin Road
    SL6 5EQ Maidenhead
    Berkshire
    Director
    22 Murrin Road
    SL6 5EQ Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish70374050001
    25 NOMINEES LIMITED
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    Director corporativo
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    42409900001

    ¿Tiene SITEX GROUP HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 20 ago 1999
    Entregado el 28 ago 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    In favour of the chargee by clause 2.1 of the debenture, the company (a) covenanted and undertook that it will on demand in writing made to it by the security trustee pay or discharge to the security trustee all money and liabilities on or after the date of the debenture due, owing or incurred to each beneficiary by the company under or pursuant to the senior finance documents; (b) covenanted, undertook and guaranteed that it will on demand in writing made to it by the security trustee pay or discharge to the security trustee all money and liabilities on or after the date of the debenture due, owing or incurred to each beneficiary by each other company (except as a guarantor for the company) under or pursuant to the senior finance documents
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage all f/h and l/h land in england and wales; by way of first fixed charge all plant and machinery goodwill and uncalled capital book and other debts; by way of first floaitng charge all assets owned by the chargor except to the extent that such assets are for the time being effectively charged by any fixed charge referred to above,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Dresdner Bank Ag (As Security Trustee)
    Transacciones
    • 28 ago 1999Registro de un cargo (395)
    Supplemental debenture
    Creado el 10 mar 1998
    Entregado el 26 mar 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    In favour of the chargee (the "security agent") as agent and trustee for itself and each of the banks all monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under each of the senior finance documents or any other document provided that no obligation or liability is included in the definition of "secured liabilities" to the extent that, if it were so included, the debenture (as supplemented by the "supplemental debenture") (or any part thereof) would constitute unlawfull financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985
    Breve descripción
    The company and sitex assign all their respective rights, title and interest (if any) in and to the additional relevant agreements on the same terms, mutatis mutandis, as are set out in the debenture (as supplemented by the "supplemental debenture") as if the additional agreement were set out in clause 4.1 (a) as relevant agreements.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Morgan Grenfell & Co. Limited (The "Security Agent")
    Transacciones
    • 26 mar 1998Registro de un cargo (395)
    • 13 sept 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 02 jul 1997
    Entregado el 18 jul 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee (the "security agent") as agent and trustee for itself and each of the lenders or any of the lenders (as defined) under each or any of the senior finance documents (as defined)
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Morgan Grenfell & Co. Limited
    Transacciones
    • 18 jul 1997Registro de un cargo (395)
    • 13 sept 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0