RIVERSIDE CROYDON LIMITED

RIVERSIDE CROYDON LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRIVERSIDE CROYDON LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03340555
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RIVERSIDE CROYDON LIMITED?

    • Instalaciones de acondicionamiento físico (93130) / Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

    ¿Dónde se encuentra RIVERSIDE CROYDON LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RIVERSIDE CROYDON LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para RIVERSIDE CROYDON LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RIVERSIDE CROYDON LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    4 páginas4.71

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1FE England

    2 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de , Active House 21 North Fourth Street, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK9 1HL el 09 oct 2013

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 19 sept 2013

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Déclaration annuelle établie au 29 ago 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    Nombramiento de Mr Paul Antony Woolf como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Norman Field como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 29 ago 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 31 ago 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Nombramiento de Matthew Graham Merrick como director

    4 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    27 sept 2011The form is a duplicate of AP01 registered on 12/09/2011

    Nombramiento de James Archibald como secretario

    4 páginasAP03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    27 sept 2011The form is a duplicate of AP03 registered on 12/09/2011

    Nombramiento de James Archibald como secretario

    3 páginasAP03

    Nombramiento de Matthew Graham Merrick como director

    3 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    15 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de RIVERSIDE CROYDON LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ARCHIBALD, James
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Secretario
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    British162966660001
    BUCKNALL, Matthew William
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Director
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritish162066820001
    MERRICK, Matthew Graham
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Director
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritish162110530001
    WOOLF, Paul Antony
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Director
    c/o Mazars Llp
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritish160679880001
    ASHWORTH, Paul Richard
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    Secretario
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    British46410260001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Secretario
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    British58961410002
    DREGENT, Patricia Ann Taylor
    17 Spinney Close
    RM13 8LR Rainham
    Essex
    Secretario
    17 Spinney Close
    RM13 8LR Rainham
    Essex
    British6369240002
    PENRICE, Victoria Margaret
    Trebartha
    51a Frances Road
    SL4 3AQ Windsor
    Berkshire
    Secretario
    Trebartha
    51a Frances Road
    SL4 3AQ Windsor
    Berkshire
    British90459300001
    SCALES, Eugene Patrick
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Secretario
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Other124193970001
    SHILLINGLAW, Gary Preston
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    Secretario
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    British66825690001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    Secretario
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    British113777700001
    WHEELER, Jonathan
    19 Glebe Place
    Chelsea
    SW3 5LD London
    Secretario
    19 Glebe Place
    Chelsea
    SW3 5LD London
    British19812400001
    WONG, Wai Chung
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    Secretario
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    British123616460002
    ANDERSON, Ruth
    46 Upper Grotto Road
    Strawberry Hill
    TW1 4NF Twickenham
    Director
    46 Upper Grotto Road
    Strawberry Hill
    TW1 4NF Twickenham
    British66859670001
    ASHWORTH, Paul Richard
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    Director
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    EnglandBritish46410260001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Director
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritish58961410002
    BEADLE, Mark Ronald Sydney
    14 Fen Meadow
    TN15 9HT Ightham
    Kent
    Director
    14 Fen Meadow
    TN15 9HT Ightham
    Kent
    British80515670001
    CHARLTON, Stephen Paul
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    Director
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritish96743210001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Director
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish146698270001
    COLES, Charles Graham
    Willow Cottage
    Chalfont Lane
    WD3 5PP Chorleywood
    Hertfordshire
    Director
    Willow Cottage
    Chalfont Lane
    WD3 5PP Chorleywood
    Hertfordshire
    EnglandBritish12337010002
    CREED, Stuart John
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    Director
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    United KingdomBritish3716600001
    DHODY, Jog
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Director
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish104269910002
    FIELD, Norman Mark
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    Director
    North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House 21
    Buckinghamshire
    United KingdomSouth African161860310001
    FOSTER, Michael Raymond
    4 Church Close
    Westoning
    MK45 5DH Bedford
    Director
    4 Church Close
    Westoning
    MK45 5DH Bedford
    EnglandBritish53280440001
    GILLIS, Neil Duncan
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    Director
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    EnglandBritish69204500003
    GUYER, Paul John
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    Director
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    British100971720002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish30306840002
    HENCHOZ, Patrick
    Huntington Court
    Huntington Lane
    HR4 7RA Hereford
    Herefordshire
    Director
    Huntington Court
    Huntington Lane
    HR4 7RA Hereford
    Herefordshire
    United KingdomSwiss93431850001
    JOHNSON, Mark Christopher
    Little Stream
    Sunning Hill Road
    SL5 9JZ Ascot
    Berkshire
    Director
    Little Stream
    Sunning Hill Road
    SL5 9JZ Ascot
    Berkshire
    EnglandBritish48443030001
    KELLY, Maurice William
    Spinney Cottage Wing Road
    Mentmore
    LU7 0QG Leighton Buzzard
    Buckinghamshire
    Director
    Spinney Cottage Wing Road
    Mentmore
    LU7 0QG Leighton Buzzard
    Buckinghamshire
    British89366130001
    LEATHERBARROW, David Jon
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Director
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish135618280002
    MCCOLLUM, Kevin Boyd
    Waterton Stables
    Ampney Crucis
    GL7 5RX Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    Waterton Stables
    Ampney Crucis
    GL7 5RX Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritish121972580001
    MCGUIGAN, Marc Edward
    Avadi
    Chapel Lane
    GL20 7ER Tewkesbury
    Gloucester
    Director
    Avadi
    Chapel Lane
    GL20 7ER Tewkesbury
    Gloucester
    EnglandBritish93677590002
    MCRORY, Penelope Ann
    13 Queen Street
    KT16 8BS Chertsey
    Surrey
    Director
    13 Queen Street
    KT16 8BS Chertsey
    Surrey
    British52251860001
    MICHAELS, Terry
    The Vines Hardwick Close
    KT22 0HZ Oxshott
    Surrey
    Director
    The Vines Hardwick Close
    KT22 0HZ Oxshott
    Surrey
    New Zealand72228080001

    ¿Tiene RIVERSIDE CROYDON LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed and floating security document
    Creado el 18 jun 2009
    Entregado el 26 jun 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any other chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Societe Generale as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transacciones
    • 26 jun 2009Registro de un cargo (395)
    • 03 oct 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Group debenture
    Creado el 08 feb 2006
    Entregado el 18 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Secured Parties)(in Such Capacity the "Security Agent")
    Transacciones
    • 18 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 ene 2004
    Entregado el 07 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any other member of the group to the note finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Electra Partners Europe Limited as Noteholders' Agent and Noteholders' Security Trustee Andnoteholders Security Trust (The "Noteholders' Security Trustee")
    Transacciones
    • 07 feb 2004Registro de un cargo (395)
    • 03 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 ene 2004
    Entregado el 03 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any member of the group (meaning the borrower or its subsidiaries from time to time) to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Dukes meadow chiswick hounslow t/no NGL147830; imperial way croydon surrey t/no SGL454522; llandarcy neath swansea t/no CYM43829 and WA953690 for details of further properties charged please refer to form 395 unscheduled property, rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, reights as tenant, book and other debts, bank accounts, charged securities, uncalled capital , goodwill, intellectual property, licences, credit agreements, contracts floating charge undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 03 feb 2004Registro de un cargo (395)
    • 07 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene RIVERSIDE CROYDON LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    24 sept 2013Inicio de la liquidación
    20 nov 2014Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Profesional
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profesional
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0