RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED

RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03341350
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    • Actividades combinadas de apoyo a instalaciones (81100) / Actividades administrativas y de apoyo
    • Otros servicios de limpieza (81299) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CARILLION PALL MALL LIMITED31 may 200631 may 2006
    MOWLEM PALL MALL LIMITED10 feb 200410 feb 2004
    PALL MALL SUPPORT SERVICES LIMITED03 abr 199703 abr 1997
    TRUSHELFCO (NO.2227) LIMITED27 mar 199727 mar 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    22 páginasLIQ14
    A99Q11KG

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 23 mar 2020

    24 páginasLIQ03
    A94WUP23

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600
    A89ACXCR

    Destitución del liquidador por orden judicial

    9 páginasLIQ10
    A89ACXCZ

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 23 mar 2019

    26 páginasLIQ03
    A82RK4KW

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 23 mar 2018

    24 páginasLIQ03
    A76GY2G3

    Domicilio social registrado cambiado de Innovation House Bullerthorpe Lane Colton Leeds West Yorkshire LS15 9JL a Kpmg 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH el 29 may 2018

    2 páginasAD01
    A76GX4G2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 23 mar 2017

    13 páginas4.68
    A659CFLU

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 23 mar 2017

    13 páginas4.68
    A65463PT

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600
    A58UMH41

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    1 páginas2.34B
    A52Y02SD

    Informe de progreso del administrador hasta 16 mar 2016

    16 páginas2.24B
    A52Y02S1

    Informe de progreso del administrador hasta 17 sept 2015

    14 páginas2.24B
    A4I5ZNEH

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B
    A4GAO4GQ

    Informe de progreso del administrador hasta 17 mar 2015

    26 páginas2.24B
    A45HOSJD

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    25 páginas2.16B
    A3LVU05U

    Declaración de la propuesta del administrador

    29 páginas2.17B
    A3JYJ55U

    Declaración de la propuesta del administrador

    29 páginas2.17B
    A3JQWNKO

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B
    A3GTIYBN

    Cambio de datos del director Mr Richard William Taylor Gray el 05 sept 2014

    2 páginasCH01
    X3FZRVJ5

    Déclaration annuelle établie au 27 mar 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 abr 2014

    Estado de capital el 08 abr 2014

    • Capital: GBP 1,000,003
    SH01
    X35EHOF7

    Nombramiento de Mr John King como director

    2 páginasAP01
    X304PCDN

    Cese del nombramiento de David Seaton como director

    1 páginasTM01
    X304PBIZ

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2012

    33 páginasAA
    A2FXGR68

    ¿Quiénes son los directivos de RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DANIEL, Mark Richard
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    Secretario
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    178838610001
    FORAN, Raymond Christopher
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    Director
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    IrelandIrishCompany Director149366250001
    GRAY, Richard William Taylor
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    Director
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    ScotlandBritishDirector111454800002
    KING, John
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    Director
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    IrelandIrishCompany Director184461620001
    BARKER, Nigel
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    Secretario
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    British153013180001
    FOSTER, Robert
    9 Ganton Road
    Bloxwich
    WS3 3XQ Walsall
    Secretario
    9 Ganton Road
    Bloxwich
    WS3 3XQ Walsall
    BritishDirector38619010002
    HARKIN, Niall
    5 Campbell Chase
    BT4 3PE Belfast
    County Antrim
    N Ireland
    Secretario
    5 Campbell Chase
    BT4 3PE Belfast
    County Antrim
    N Ireland
    BritishFinance Director125430560001
    LAWRENCE, David
    45 Griffith Avenue
    Drumcondra
    Dublin 9
    Republic Of Ireland
    Secretario
    45 Griffith Avenue
    Drumcondra
    Dublin 9
    Republic Of Ireland
    British136692630001
    MACNAMARA, James Justin
    Heyford Manor
    18 Church Lane, Lower Heyford
    OX25 5NZ Oxon
    Secretario
    Heyford Manor
    18 Church Lane, Lower Heyford
    OX25 5NZ Oxon
    BritishFinance Director204243460001
    CARILLION SECRETARIAT LIMITED
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    Secretario corporativo
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    33743910002
    TRUSEC LIMITED
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    Secretario designado corporativo
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    900007200001
    BEAN, Paul Francis
    10 Ormiston Farm Steadings
    Kirknewton
    EH27 0DQ Edinburgh
    West Lothian
    Director
    10 Ormiston Farm Steadings
    Kirknewton
    EH27 0DQ Edinburgh
    West Lothian
    United KingdomBritishCompany Director125759470001
    BOYLE, George Mathieson
    Strathern House
    Devonshire Avenue
    HP6 5JE Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    Strathern House
    Devonshire Avenue
    HP6 5JE Amersham
    Buckinghamshire
    BritishDirector102046460001
    BRANNIGAN, Terence Hugh
    West Cliffe Grove
    HG2 0PS Harrogate
    17
    North Yorkshire
    Director
    West Cliffe Grove
    HG2 0PS Harrogate
    17
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director125430930001
    DAY, Stephen John
    Becca House Becca Lane
    Aberford
    LS25 3BD Leeds
    Director
    Becca House Becca Lane
    Aberford
    LS25 3BD Leeds
    EnglandBritishDirector59028300002
    FORAN, Raymond Christopher
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    Director
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    IrelandIrishDirector149366250001
    FOSTER, Robert
    9 Ganton Road
    Bloxwich
    WS3 3XQ Walsall
    Director
    9 Ganton Road
    Bloxwich
    WS3 3XQ Walsall
    EnglandBritishDirector38619010002
    HARKIN, Niall
    5 Campbell Chase
    BT4 3PE Belfast
    County Antrim
    N Ireland
    Director
    5 Campbell Chase
    BT4 3PE Belfast
    County Antrim
    N Ireland
    Northern IrelandBritishFinance Director125430560001
    IVEY, John Charles
    Tregenna 32 The Glen
    Farnborough Park
    BR6 8LR Orpington
    Kent
    Director
    Tregenna 32 The Glen
    Farnborough Park
    BR6 8LR Orpington
    Kent
    BritishDirector8286080001
    MACNAMARA, James Justin
    Heyford Manor
    18 Church Lane, Lower Heyford
    OX25 5NZ Oxon
    Director
    Heyford Manor
    18 Church Lane, Lower Heyford
    OX25 5NZ Oxon
    EnglandBritishDirector204243460001
    MCGRORY, Jack
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    Director
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector96596920001
    ROWE, Drusilla Charlotte Jane
    Flat E
    13 Saint Georges Drive
    SW1V 4DJ London
    Director designado
    Flat E
    13 Saint Georges Drive
    SW1V 4DJ London
    British900010990001
    SEATON, David John
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    Director
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector66233040004
    SHEPLEY, Philip Ernest
    15 Whitmore Road
    Beckenham
    BR3 3NU Kent
    Director
    15 Whitmore Road
    Beckenham
    BR3 3NU Kent
    United KingdomBritishCustomer Services Director122662180001
    VAUGHAN, Andrew David
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    Director
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector110679680001
    VOCKINS, Anthony Frederick
    3 Shires Orchard
    Croxton Kerral
    NG32 1RD Grantham
    Lincolnshire
    Director
    3 Shires Orchard
    Croxton Kerral
    NG32 1RD Grantham
    Lincolnshire
    BritishManaging Director123410850001
    WOODS, David
    12 Rainsborough Rise
    Thorpe St Andrew
    NR7 0TR Norwich
    Norfolk
    Director
    12 Rainsborough Rise
    Thorpe St Andrew
    NR7 0TR Norwich
    Norfolk
    BritishDirector11156100002
    ZUERCHER, Eleanor Jane
    26 Springfield Road
    Linslade
    LU7 7QS Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Director designado
    26 Springfield Road
    Linslade
    LU7 7QS Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British900014530001
    CARILLION MANAGEMENT LIMITED
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    Director corporativo
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    36778210004

    ¿Tiene RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rent deposit deed
    Creado el 23 dic 2010
    Entregado el 08 ene 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    A first fixed equitable charge over the deposit balance being the balance from time to time standing to the credit of the deposit account being a separate interest bearing account see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Pollen Estate Trustee Company Limited
    Transacciones
    • 08 ene 2011Registro de un cargo (MG01)
    Mortgage debenture
    Creado el 28 sept 2007
    Entregado el 19 oct 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the comapny to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC in Its Capacity as Security Trustee for and on Behalf of Thefinance Parties (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 19 oct 2007Registro de un cargo (395)
    Mortgage debenture
    Creado el 02 jun 2000
    Entregado el 16 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the parent company (as defined) or the company to the chargee (the "security trustee") as trustee for itself and the noteholders under or in connection with the notes (as defined) or the mortgage debenture together with the expenses (as defined)
    Breve descripción
    141/157 acre lane brixton london; rooms 36-37 first floor lingley house commissioners road streed kent; 1 st michaels court church street newport gwent .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Wren Investments Limited
    Transacciones
    • 16 jun 2000Registro de un cargo (395)
    • 14 ago 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 02 jun 2000
    Entregado el 14 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the chargee on any account whatsoever under the financing documents or otherwise
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 14 jun 2000Registro de un cargo (395)
    • 22 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 07 nov 1997
    Entregado el 15 nov 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from any company to the chargee and to any beneficiary (as defined) under or in connection with the notes (as defined) or this deed
    Breve descripción
    141/157 acre lane brixton london; rooms 36/37 first floor lingley house, commissioners road strood kent; unit 3 evtol trading estate portland street, newport gwent .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Wren Investments Limited (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 15 nov 1997Registro de un cargo (395)
    • 14 ago 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 07 nov 1997
    Entregado el 12 nov 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee and on any account whatsoever under the financing documents (as defined)
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 nov 1997Registro de un cargo (395)
    • 22 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    18 sept 2014Inicio de la administración
    24 mar 2016Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    John Hansen
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    Profesional
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    Stuart Irwin
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    County Antrim
    Profesional
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    County Antrim
    2
    FechaTipo
    24 mar 2016Inicio de la liquidación
    04 nov 2020Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Ian Leonard
    1 Lanyon Place
    BT1 3LP Belfast
    County Antrim
    Profesional
    1 Lanyon Place
    BT1 3LP Belfast
    County Antrim
    John Hansen
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    Liquidador propuesto
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    Stuart Irwin
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    County Antrim
    Liquidador propuesto
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    County Antrim
    Stuart Irwin
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    County Antrim
    Profesional
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    County Antrim
    John Hansen
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    Profesional
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0