CHGRMUPR CAMPAIGN
Visión general
| Nombre de la empresa | CHGRMUPR CAMPAIGN |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited' |
| Número de empresa | 03345259 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CHGRMUPR CAMPAIGN?
- (7487) /
¿Dónde se encuentra CHGRMUPR CAMPAIGN?
| Dirección de la sede social | Lion House Red Lion Street WC1R 4GB London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CHGRMUPR CAMPAIGN?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| JEANS FOR GENES CAMPAIGN | 04 abr 1997 | 04 abr 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CHGRMUPR CAMPAIGN?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CHGRMUPR CAMPAIGN?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2011 | 30 páginas | AA | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed jeans for genes campaign\certificate issued on 18/04/11 | 5 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Misceláneos Form NE01 | 2 páginas | MISC | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 4 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Aviso de cambio de nombre | 2 páginas | CONNOT | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 abr 2011, aucune liste de membres fournie | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Rysaffe Secretaries el 04 abr 2011 | 2 páginas | CH04 | ||||||||||
Cambio de datos del director Christine Ann Lavery el 04 abr 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Leyden como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 jun 2010 | 36 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Goard como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Robin Gibbs como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Caroline Elizabeth Harding como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Goard como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 30 jun 2011 au 31 mar 2011 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Raymond Dias como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 abr 2010 | 20 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher Henry Syrda como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Marcia Green como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 jun 2009 | 33 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de John Patrick Stephen Leyden como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Angel como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CHGRMUPR CAMPAIGN?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYSAFFE SECRETARIES | Secretario corporativo | Red Lion Street WC1R 4GB London Lion House United Kingdom |
| 90583890001 | ||||||||||
| HARDING, Caroline Elizabeth | Director | Burnham Court Moscow Road W2 4SW London 35 United Kingdom | United Kingdom | British | 135130430001 | |||||||||
| HUGHAN, Christopher John | Director | Martins Orchard West Burton RH20 1HD Pulborough West Sussex | United Kingdom | British | 52671040008 | |||||||||
| JOHNSON, Timothy Brett | Director | Boxwell Road HP4 3EX Berkhamsted 6 Hertfordshire | United Kingdom | British | 133392590001 | |||||||||
| LAVERY, Christine Ann | Director | 7 Chessfield Park Little Chalfont HP6 6RU Amersham Buckinghamshire | England | British | 53320280001 | |||||||||
| SYRDA, Christopher Henry | Director | Ray Mill Road East SL6 8SW Maidenhead 23a Berkshire | United Kingdom | British | 137871850001 | |||||||||
| DIAS, Raymond | Secretario | 1 Castlereagh House Lady Aylesford Avenu HA7 4FP Stanmore Middlesex | British | 102027890001 | ||||||||||
| HAINES, Bethan Sarah | Secretario | 33b Mount Pleasant Lane E5 9DW London | British | 64310660001 | ||||||||||
| HAINES, Bethan Sarah | Secretario | 33b Mount Pleasant Lane E5 9DW London | British | 64310660001 | ||||||||||
| MONK, Christine Kay | Secretario | Flat 19 45 New Compton Street WC2H 8DF London | British | 69183070001 | ||||||||||
| PATEL, Sujita | Secretario | Canjayar Tydcombe Road CR6 9LU Warlingham Surrey | British | 61206700001 | ||||||||||
| ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 19 Glasgow Road PA1 3QX Paisley Renfrewshire | 62720590001 | |||||||||||
| ANGEL, John Hugh | Director | Pipers Cottage Nettleden HP1 3DQ Hemel Hempstead Hertfordshire | England | British | 44960640002 | |||||||||
| BROWN, Peter Jeremy | Director | 15 Hall Park Gate HP4 2NL Berkhamsted Hertfordshire | England | British | 83107950001 | |||||||||
| CARRINGTON, Nigel Martyn, Sir | Director | 21 Frognal Lane NW3 7DB London | England | British | 14447700001 | |||||||||
| CLARK, Nigel Culliford | Director | 10 Weltje Road W6 4TJ London | British | 15454020001 | ||||||||||
| CLIFFE, Rosslyn | Director | 41 Shaftesbury Way TW2 5RW Twickenham | British | 64862190002 | ||||||||||
| DAVIS, Vanessa Carolyn Elaine | Director | 29 Arthur Road SW19 7DN London | United Kingdom | British | 48914350001 | |||||||||
| DENTON, Charles James | Director | Hearts Delight Road Tunstall ME9 8JB Sittingbourne Uplands Kent | United Kingdom | British | 135837260001 | |||||||||
| DEVINE, Robert | Director | 15 Watery Lane Keresley CV6 2GE Coventry West Midlands | England | British | 83436220001 | |||||||||
| DIAS, Raymond | Director | 1 Castlereagh House Lady Aylesford Avenu HA7 4FP Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | 102027890001 | |||||||||
| FANE, Andrew William Mildmay | Director | Flat 5 64 Ladbrooke Road W11 3NR London | England | British | 74018030002 | |||||||||
| GIBBS, Robin Peterson | Director | Gloucester Place W1U 6JE London 85 | United States | 138689870001 | ||||||||||
| GOARD, Christopher John | Director | 8 Worminghall Road HP18 9JD Ickford Turnfield House Buckinghamshire | United Kingdom | British | 31559350001 | |||||||||
| GREEN, Marcia Ann | Director | Pear Tree House Farm 117 Lutton Gate Gedney Hill PE12 0QH Spalding Lincolnshire | England | British | 89056360001 | |||||||||
| HOLROYD, Christopher Allen | Director | The Meade Pagans Hill Chew Stoke BS40 8UF Bristol | British | 92797840001 | ||||||||||
| LAVERY, Christine Ann | Director | 7 Chessfield Park Little Chalfont HP6 6RU Amersham Buckinghamshire | England | British | 53320280001 | |||||||||
| LEYDEN, John | Director | Welbeck Court Addison Bridge Place W14 8XW London 22 United Kingdom | United Kingdom | Irish | 48086980002 | |||||||||
| MCNAIRNEY, Rachel Wylie | Director | Rukera 10 Pardovan Place, Camelon FK1 4BQ Falkirk Central Region | British | 92589740001 | ||||||||||
| MONK, Christine Kay | Director | Flat 19 45 New Compton Street WC2H 8DF London | British | 69183070001 | ||||||||||
| MOODY, Paul | Director | 9 Bowling Green View Drighlington BD11 1JP Bradford | England | British | 40895240002 | |||||||||
| NELSON, Liz, Dr | Director | 57 Home Park Road SW19 7HS London | Uk Us | 113170030001 | ||||||||||
| NORRIS-JONES, David Colin | Director | The Wick 12 Lynwood Road KT17 4LD Epsom Surrey | British | 24592840002 | ||||||||||
| NUMAN, Robert Paul | Director | Seafields Shooterway Lane HP4 3NP Berkhamsted Hertfordshire | British | 53320220001 | ||||||||||
| RYMER, Rosemarie | Director | Manor Farm BH21 5NL Wimborne St. Giles Dorset | British | 83108430001 |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0