STER CENTURY (UK) LIMITED

STER CENTURY (UK) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSTER CENTURY (UK) LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03347110
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de STER CENTURY (UK) LIMITED?

    • Actividades de proyección de películas cinematográficas (59140) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra STER CENTURY (UK) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    3rd Floor One Ariel Way
    Westfield
    W12 7SL London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STER CENTURY (UK) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    STER-KINEKOR (UK) LIMITED02 abr 199702 abr 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de STER CENTURY (UK) LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 nov 2024
    Próximas cuentas vencen el31 ago 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 nov 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para STER CENTURY (UK) LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta02 abr 2025
    Próxima declaración de confirmación vence16 abr 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta02 abr 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para STER CENTURY (UK) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cambio de datos del director Mr Matthew Neil Eyre el 30 sept 2024

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Matthew Neil Eyre el 06 nov 2024

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Toby William Bradon como director el 20 sept 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Matthew Neil Eyre como director el 30 sept 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Narinder Shergill como director el 01 oct 2024

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2023

    44 páginasAA

    Cese del nombramiento de Robert Alexander Calder como director el 01 jun 2024

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del secretario Mr Euan Sutton el 03 jun 2024

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Toby William Bradon el 03 jun 2024

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr James Timothy Richards el 03 jun 2024

    2 páginasCH01

    Modification des détails de Aurora Cinema Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 jun 2024

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de 10 Chiswick Park 566 Chiswick High Road London W4 5XS a 3rd Floor One Ariel Way Westfield London W12 7SL el 03 jun 2024

    1 páginasAD01

    Registro de la carga 033471100041, creada el 02 may 2024

    19 páginasMR01

    Declaración de confirmación presentada el 02 abr 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Claire Gillian Arksey como director el 30 ene 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Claire Gillian Arksey como director el 31 ago 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Jeremy Knibbs como director el 31 ago 2023

    1 páginasTM01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 8th Floor 20 Farringdon Street London EC4A 4AB United Kingdom a C/O Tmf Group 13th Floor One Angel Court London EC2R 7HJ

    1 páginasAD02

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2022

    43 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 abr 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 14

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 18

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 15

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 16

    1 páginasMR04

    Nombramiento de Robert Alexander Calder como director el 14 mar 2023

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de STER CENTURY (UK) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SUTTON, Euan
    One Ariel Way
    Westfield
    W12 7SL London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Secretario
    One Ariel Way
    Westfield
    W12 7SL London
    3rd Floor
    United Kingdom
    202704710001
    EYRE, Matthew Neil
    One Ariel Way
    Westfield
    W12 7SL London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Director
    One Ariel Way
    Westfield
    W12 7SL London
    3rd Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector326544610010
    RICHARDS, James Timothy
    One Ariel Way
    Westfield
    W12 7SL London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Director
    One Ariel Way
    Westfield
    W12 7SL London
    3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive Officer77252910003
    SHERGILL, Narinder
    One Ariel Way
    Westfield
    W12 7SL London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Director
    One Ariel Way
    Westfield
    W12 7SL London
    3rd Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector137005400002
    DAVISON, Matthew St John
    10 Hanover Gardens
    Cove
    GU14 9DT Farnborough
    Hampshire
    Secretario
    10 Hanover Gardens
    Cove
    GU14 9DT Farnborough
    Hampshire
    British78095460001
    ELLISON, John Beaumont
    25a High Street
    GU19 5AF Bagshot
    Surrey
    Secretario
    25a High Street
    GU19 5AF Bagshot
    Surrey
    British93434850001
    GRIMSLEY, Selwyn John
    10 Queen Victoria Court
    Farnborough Road
    GU14 8AR Farnborough
    Hampshire
    Secretario
    10 Queen Victoria Court
    Farnborough Road
    GU14 8AR Farnborough
    Hampshire
    South AfricanFinancial Director52944220003
    MCNAIR, Alan Ewart
    16 Woodhill Avenue
    SL9 8DW Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secretario
    16 Woodhill Avenue
    SL9 8DW Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishChief Financial Officer89547140001
    SHAH, Vinesh Harakhchand
    68 Alicia Avenue
    Kenton
    HA3 8HS Harrow
    Middlesex
    Secretario
    68 Alicia Avenue
    Kenton
    HA3 8HS Harrow
    Middlesex
    BritishAccountant121070620001
    WHALLEY, Anne
    Chiswick Park
    566 Chiswick High Road
    W4 5XS London
    10
    United Kingdom
    Secretario
    Chiswick Park
    566 Chiswick High Road
    W4 5XS London
    10
    United Kingdom
    British91537940001
    JAMESTOWN INVESTMENTS LIMITED
    4 Felstead Gardens
    Ferry Street
    E14 3BS London
    Secretario corporativo
    4 Felstead Gardens
    Ferry Street
    E14 3BS London
    43844040001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ARKSEY, Claire Gillian
    Chiswick Park
    566 Chiswick High Road
    W4 5XS London
    10
    United Kingdom
    Director
    Chiswick Park
    566 Chiswick High Road
    W4 5XS London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director313115170001
    BRADON, Toby William
    One Ariel Way
    Westfield
    W12 7SL London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Director
    One Ariel Way
    Westfield
    W12 7SL London
    3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector280267410001
    CALDER, Robert Alexander
    One Ariel Way
    Westfield
    W12 7SL London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Director
    One Ariel Way
    Westfield
    W12 7SL London
    3rd Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director306761060001
    CORNWELL, Alison Margaret
    Chiswick Park
    566 Chiswick High Road
    W4 5XS London
    10
    United Kingdom
    Director
    Chiswick Park
    566 Chiswick High Road
    W4 5XS London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Financial Officer230771800001
    DAVISON, Matthew St John
    10 Hanover Gardens
    Cove
    GU14 9DT Farnborough
    Hampshire
    Director
    10 Hanover Gardens
    Cove
    GU14 9DT Farnborough
    Hampshire
    BritishFinance Dirctor78095460001
    FONTERNEL, Theodorus Ernst
    Gilbert Way
    Finchampstead
    RG40 4HJ Wokingham
    14
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Gilbert Way
    Finchampstead
    RG40 4HJ Wokingham
    14
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director80900000003
    FONTERNEL, Theodorus Ernst
    Gilbert Way
    Finchampstead
    RG40 4HJ Wokingham
    14
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Gilbert Way
    Finchampstead
    RG40 4HJ Wokingham
    14
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDevelopment Director80900000003
    GRIMSLEY, Selwyn John
    1 Northwick
    Eversley
    RG27 0SD Hook
    Hampshire
    Director
    1 Northwick
    Eversley
    RG27 0SD Hook
    Hampshire
    South AfricanManaging Director52944220004
    HALL, Christopher Keith
    Wessex Lodge Green Lane
    Woodstock
    OX20 1JY Oxford
    Oxon
    Director
    Wessex Lodge Green Lane
    Woodstock
    OX20 1JY Oxford
    Oxon
    EnglandBritishCompany Director7419710001
    KNIBBS, Stephen Jeremy
    Chiswick Park
    566 Chiswick High Road
    W4 5XS London
    10
    United Kingdom
    Director
    Chiswick Park
    566 Chiswick High Road
    W4 5XS London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Managing Director And Deputy Ceo92163440003
    LOUIS, Stephen David
    70 Cheriton Square
    SW17 8AE London
    Director
    70 Cheriton Square
    SW17 8AE London
    United KingdomBritishCompany Director59735410002
    MCNAIR, Alan Ewart
    Chiswick Park
    566 Chiswick High Road
    W4 5XS London
    10
    United Kingdom
    Director
    Chiswick Park
    566 Chiswick High Road
    W4 5XS London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer89547140003
    O'SULLIVAN, Ann Marie
    Lammas Park Road
    W5 5JD London
    25
    Director
    Lammas Park Road
    W5 5JD London
    25
    United KingdomBritishDirector75691380002
    ROSS, Michael Peter
    Gilbert Way
    Finchampstead
    RG40 4HJ Wokingham
    14
    Berkshire
    Director
    Gilbert Way
    Finchampstead
    RG40 4HJ Wokingham
    14
    Berkshire
    South AfricanCompany Director52944260004
    ROSS, Michael Peter
    Gilbert Way
    Finchampstead
    RG40 4HJ Wokingham
    14
    Berkshire
    Director
    Gilbert Way
    Finchampstead
    RG40 4HJ Wokingham
    14
    Berkshire
    South AfricanManaging Director52944260004
    SCHERER, Jonathan Francis
    27 Bolingbroke Road
    W14 0AJ London
    Director
    27 Bolingbroke Road
    W14 0AJ London
    United KingdomBritishCompany Director61992420003
    YOUNG, Alistair David
    4 The Dell
    Highland Road
    GU9 0ND Farnham
    Surrey
    Director
    4 The Dell
    Highland Road
    GU9 0ND Farnham
    Surrey
    BritishCompany Director82367660001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de STER CENTURY (UK) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    One Ariel Way
    Westfield
    W12 7SL London
    3rd Floor
    United Kingdom
    06 abr 2016
    One Ariel Way
    Westfield
    W12 7SL London
    3rd Floor
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro4779767
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene STER CENTURY (UK) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 02 may 2024
    Entregado el 07 may 2024
    Pendiente
    Breve descripción
    Leasehold property held in the name of ster century (UK) limited, located and known as the cinema, castle mall shopping centre, norwich NR1 3DD bearing land registry title number NK290585. Please refer to schedule 3 of the security instrument for additional details.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Wilmington Trust (London) Limited as Security Agent
    Transacciones
    • 07 may 2024Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 26 ene 2023
    Entregado el 31 ene 2023
    Pendiente
    Breve descripción
    Leasehold property held in the name of ster century (UK) limited, located and known as the cinema, castle mall shopping centre, norwich NR1 3DD bearing land registry title number NK290585. Please refer to schedule 3 of the security instrument for additional details.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Wilmington Trust (London) Limited (as the Security Agent)
    Transacciones
    • 31 ene 2023Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 14 sept 2022
    Entregado el 21 sept 2022
    Pendiente
    Breve descripción
    Leasehold property held in the name of ster century (UK) limited, located and known as the cinema, castle mall shopping centre, norwich NR1 3DD bearing land registry title number NK290585. Please refer to schedule 3 of the security instrument for additional details.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Wilmington Trust (London) Limited (as Security Agent)
    Transacciones
    • 21 sept 2022Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 11 dic 2020
    Entregado el 15 dic 2020
    Pendiente
    Breve descripción
    Leasehold property held in the name of ster century (UK) limited, located and known as the cinema, castle mall shopping centre, norwich NR1 3DD bearing land registry title number NK290585. Please refer to schedule 3 of the security instrument for additional details.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Wilmington Trust (London) Limited (as Security Agent)
    Transacciones
    • 15 dic 2020Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 30 sept 2019
    Entregado el 03 oct 2019
    Pendiente
    Breve descripción
    Leasehold property registered in the name of ster century (UK) limited known as the cinema, castle mall shopping centre, norwich NR1 3DD bearing title no. NK290585; for addtional information please referr to schedule 4 of the security instrument.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Wilmington Trust (London) Limited (as Security Agent)
    Transacciones
    • 03 oct 2019Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 14 oct 2016
    Entregado el 21 oct 2016
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    The tenant's interest in the lease of the multiplex cinema unit, 98/73, ocean drive, edinburgh, EH6 6JJ registered under title number MID96024.
    Contiene una promesa negativa:
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC (As Security Agent)
    Transacciones
    • 21 oct 2016Registro de una carga (MR01)
    • 18 jul 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 28 sept 2016
    Entregado el 17 oct 2016
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Festival place basingstoke hampshire t/no HP639899 and fixed security over ip including "ster century" logo trademark in UK registration no. 2548147. please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 17 oct 2016Registro de una carga (MR01)
    • 18 jul 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 28 sept 2016
    Entregado el 04 oct 2016
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Lease of the cinema at liffey valley shopping centre fonthill road clondalkin dublin 22.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 04 oct 2016Registro de una carga (MR01)
    • 27 mar 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 18 oct 2013
    Entregado el 25 oct 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Multiplex cinema unit 98/73 ocean drive edinburgh scotland t/no MID96024. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 25 oct 2013Registro de una carga (MR01)
    • 18 jul 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 28 ago 2013
    Entregado el 29 ago 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 29 ago 2013Registro de una carga (MR01)
    • 18 jul 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 08 ago 2013
    Entregado el 14 ago 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Festival place basingstoke hampshire t/no HP639899, no 22 and unit B27 the light the headrow leeds t/no's WYK767960 and YY12062 and 1-15 the brewery romford essex t/no EGL426679 see image for full details. Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 14 ago 2013Registro de una carga (MR01)
    • 15 ago 2016Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga (MR05)
    • 18 jul 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    An irish law debenture
    Creado el 14 dic 2012
    Entregado el 20 dic 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 20 dic 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 06 sept 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage
    Creado el 27 nov 2012
    Entregado el 06 dic 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Unit B27, the light, leeds - l/h.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 06 dic 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 06 sept 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security executed on 21 december 2010
    Creado el 17 ene 2011
    Entregado el 21 ene 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All and whole the tenant's interest in the lease of the multiplex cinema unit 98/73, ocean drive, edinburgh, t/no: MID96024 see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 21 ene 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 06 sept 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Irish law debenture
    Creado el 21 dic 2010
    Entregado el 23 dic 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 23 dic 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 06 sept 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 21 dic 2010
    Entregado el 23 dic 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 23 dic 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 06 sept 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental legal charge to a debenture dated 20 june 2006 and
    Creado el 19 jul 2007
    Entregado el 21 jul 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The multiplex cinema the light leeds, t/n WYK767960,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries)
    Transacciones
    • 21 jul 2007Registro de un cargo (395)
    • 24 dic 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Supplemental legal charge to a debenture dated 20 june 2006 and
    Creado el 19 jul 2007
    Entregado el 21 jul 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Multiplex cinema the brewery romford t/n EGL426697,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries)
    Transacciones
    • 21 jul 2007Registro de un cargo (395)
    • 24 dic 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Supplemental legal charge
    Creado el 25 ene 2007
    Entregado el 26 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The consent properties being, multiplex cinema, festival place, basingstoke, hampshire t/no HP639899 together with all present and future buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 26 ene 2007Registro de un cargo (395)
    • 24 dic 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Standard security presented for registration in scotland on 13 october 2006 and
    Creado el 20 jun 2006
    Entregado el 27 oct 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or the obligors to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The tenants interest in the lease of 12 screen cinema at ocean terminal ocean drive leith t/n MID96024,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as a Security Trustee for the Securitybeneficiaries
    Transacciones
    • 27 oct 2006Registro de un cargo (395)
    • 24 dic 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 20 jun 2006
    Entregado el 10 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All that and those parts of the lands of palmerstown upper comprised in folio 113829F of the registry county dublin comprising the cinema at liffey valley shopping centre, dublin. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries
    Transacciones
    • 10 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 24 dic 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 20 jun 2006
    Entregado el 10 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H properties being cinema, castle mall shipping centre, norwich t/n NK290585, cinema, millennium plaza, scott road, cardiff t/n CYM126174 and multiplex cinema, ozone leisure park, grenoble road, oxford t/n ON247346. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries
    Transacciones
    • 10 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 24 dic 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Supplemental legal mortgage
    Creado el 04 ene 2006
    Entregado el 04 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H property k/a the multiplex cinema ozone leisure park grenoble road oxford t/no ON247346 together with all plant and machinery at any time thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Canadian Imperial Bank of Commerce as Security Agent for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 04 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 10 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge
    Creado el 06 jun 2005
    Entregado el 15 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Floating charge over all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Time Warner Entertainment LTD and Village Cinemas International Pty LTD,as Security Agents Forthe Beneficiaries
    Transacciones
    • 15 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2023Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 01 jun 2005
    Entregado el 14 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the charging company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Part of the lands of palmerston upper comprised in folio 113829F comprising the cinema at liffey valley shopping centre dublin. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Canadian Imperial Bank of Commerce (The Security Agent)
    Transacciones
    • 14 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 10 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0