IMCO RECONOMY 5 LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | IMCO RECONOMY 5 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03347372 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
- Recolección de residuos no peligrosos (38110) / Captación, depuración y distribución de agua; gestión de residuos; actividades de descontaminación y recuperación
¿Dónde se encuentra IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
| Dirección de la sede social | Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Shropshire England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SKIPS@HOME LIMITED | 18 abr 2007 | 18 abr 2007 |
| WELLS FARGO SKIPS LIMITED | 08 abr 1997 | 08 abr 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Aviso de cambio de nombre | 2 páginas | CONNOT | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 abr 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 abr 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 2 Coldbath Square London EC1R 5HL a Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 Telford Shropshire TF3 3BD el 26 jul 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr John Sullivan como secretario el 21 jul 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Llewelyn Milnes-James como director el 21 jul 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Charles Nicholas Pollard como director el 21 jul 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alistair Myrie Holl como director el 21 jul 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Caroline Elizabeth Allen como secretario el 21 jul 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr John Terence Sullivan como director el 21 jul 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Paul Cox como director el 21 jul 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 033473720005 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
second-filing-of-form-with-form-type | 5 páginas | RP04 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Ms Caroline Elizabeth Allen como secretario el 11 abr 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sophie Catherine Jane Reed como secretario el 01 abr 2016 | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 08 abr 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Anton Gerstrom como director el 01 dic 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Charles Nicholas Pollard como director el 01 dic 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULLIVAN, John | Secretario | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | 210820120001 | |||||||
| COX, Paul Anthony | Director | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | England | British | 153797870001 | |||||
| SULLIVAN, John Terence | Director | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | England | British | 180046340001 | |||||
| ALLEN, Caroline Elizabeth | Secretario | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 208085190001 | |||||||
| DIXON, Sally Veronica | Secretario | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | British | 105363350001 | ||||||
| JESKE, Riga | Secretario | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 189290690001 | |||||||
| KAHVECI, Suheda | Secretario | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 176235280001 | |||||||
| PHILLIPS, Elizabeth Clare | Secretario | 14 Blackhill Lane WA16 9DR Knutsford Cheshire | British | 56302980001 | ||||||
| REED, Sophie Catherine Jane | Secretario | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 198174110001 | |||||||
| SCOTT, Stephen John | Secretario designado | 52 Mucklow Hill Halesowen B62 8BL Birmingham | British | 900002270001 | ||||||
| WELLS, Jennifer Ann | Secretario | 20a Collett Way Priorslee TF2 9SL Telford Salop | British | 63479470001 | ||||||
| EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | 32524900007 | |||||||
| DIXON, Sally Veronica | Director | 22 Ardleigh Road N1 4HP London | England | British | 105363350001 | |||||
| GERSTROM, Peter Anton | Director | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | England | British | 138719750001 | |||||
| HARRISON, Julian John | Director | 24 Havelock Road SY3 7NE Shrewsbury Salop | England | British | 123927990001 | |||||
| HOLL, Alistair Myrie | Director | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | Wales | British | 138014840001 | |||||
| JOHNSON, Peter Stuart | Director | The Old Post Office Church Road West Peckham ME18 5JL Maidstone Kent | England | British | 11159620001 | |||||
| MILNES-JAMES, Richard Llewelyn | Director | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | 140753960001 | |||||
| PHILLIPS, John | Director | 14 Blackhill Lane WA16 9DR Knutsford Cheshire | British | 343070001 | ||||||
| POLLARD, Charles Nicholas | Director | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | England | British | 192011710001 | |||||
| RIDDLE, David Ellison | Director | 3 Lovelace Road KT6 6NS Surbiton Surrey | England | British | 556710002 | |||||
| SCOTT, Jacqueline | Director designado | 52 Mucklow Hill Halesowen B62 8BL Birmingham | British | 900002260001 | ||||||
| STEGGLES, Jonathan David | Director | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | 45141530001 | |||||
| WARD, Malcolm John | Director | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | 57775660003 | |||||
| WELLS, Peter | Director | 20a Collett Way Priorslee TF2 9SL Telford Salop | British | 45937400001 | ||||||
| WILLACY, Richard Johannes Ormerod | Director | Wraymead 158 Croydon Road RH2 0NG Reigate Surrey | United Kingdom | British | 92108930002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de IMCO RECONOMY 5 LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste Hire Service Limited | 06 abr 2016 | Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene IMCO RECONOMY 5 LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 20 ago 2015 Entregado el 27 ago 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A supplemental common debenture | Creado el 29 nov 2011 Entregado el 08 dic 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of accession | Creado el 18 may 2007 Entregado el 25 may 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 26 abr 2005 Entregado el 11 may 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee in its capacity as security agent for the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| First fixed and floating charge | Creado el 26 may 1999 Entregado el 04 jun 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descripción A first fixed charge on all book and other debts as are not sold or bought by alex lawrie receivable financing limited under an agreement dated 2ND june 1999 and a floating charge all proceeds of book and other debts with the payment of any sum due or owing to alex lawrie receivables financing limited under or in connection with any bill of exchange or other negotiable instrument to which both the company and alex lawrie receivables financing limited are a party. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0