IMCO RECONOMY 5 LIMITED

IMCO RECONOMY 5 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaIMCO RECONOMY 5 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03347372
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de IMCO RECONOMY 5 LIMITED?

    • Recolección de residuos no peligrosos (38110) / Captación, depuración y distribución de agua; gestión de residuos; actividades de descontaminación y recuperación

    ¿Dónde se encuentra IMCO RECONOMY 5 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Kelsall House Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Shropshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de IMCO RECONOMY 5 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SKIPS@HOME LIMITED18 abr 200718 abr 2007
    WELLS FARGO SKIPS LIMITED08 abr 199708 abr 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de IMCO RECONOMY 5 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para IMCO RECONOMY 5 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 28 jun 2018

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Declaración de confirmación presentada el 08 abr 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    16 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 abr 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Domicilio social registrado cambiado de 2 Coldbath Square London EC1R 5HL a Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 Telford Shropshire TF3 3BD el 26 jul 2016

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr John Sullivan como secretario el 21 jul 2016

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Richard Llewelyn Milnes-James como director el 21 jul 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Charles Nicholas Pollard como director el 21 jul 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Alistair Myrie Holl como director el 21 jul 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Caroline Elizabeth Allen como secretario el 21 jul 2016

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr John Terence Sullivan como director el 21 jul 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Paul Cox como director el 21 jul 2016

    2 páginasAP01

    Cancelación total de la carga 033473720005

    4 páginasMR04

    second-filing-of-form-with-form-type

    5 páginasRP04
    Anotaciones
    FechaAnotación
    13 jun 2016Clarification This document is a second filing of the TM02 registered on 12/05/2016 for Sophie Catherine Jane Reed

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    16 páginasAA

    Nombramiento de Ms Caroline Elizabeth Allen como secretario el 11 abr 2016

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Sophie Catherine Jane Reed como secretario el 01 abr 2016

    2 páginasTM02
    Anotaciones
    FechaAnotación
    13 jun 2016Clarification A second filed TM02 was registered on 13/06/2016

    Déclaration annuelle établie au 08 abr 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital21 abr 2016

    Estado de capital el 21 abr 2016

    • Capital: GBP 10
    SH01

    Cese del nombramiento de Peter Anton Gerstrom como director el 01 dic 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Charles Nicholas Pollard como director el 01 dic 2015

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de IMCO RECONOMY 5 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SULLIVAN, John
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Secretario
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    210820120001
    COX, Paul Anthony
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Director
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    EnglandBritish153797870001
    SULLIVAN, John Terence
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Director
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    EnglandBritish180046340001
    ALLEN, Caroline Elizabeth
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secretario
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    208085190001
    DIXON, Sally Veronica
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secretario
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    British105363350001
    JESKE, Riga
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secretario
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    189290690001
    KAHVECI, Suheda
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secretario
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    176235280001
    PHILLIPS, Elizabeth Clare
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    Secretario
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    British56302980001
    REED, Sophie Catherine Jane
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secretario
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    198174110001
    SCOTT, Stephen John
    52 Mucklow Hill
    Halesowen
    B62 8BL Birmingham
    Secretario designado
    52 Mucklow Hill
    Halesowen
    B62 8BL Birmingham
    British900002270001
    WELLS, Jennifer Ann
    20a Collett Way
    Priorslee
    TF2 9SL Telford
    Salop
    Secretario
    20a Collett Way
    Priorslee
    TF2 9SL Telford
    Salop
    British63479470001
    EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Secretario corporativo
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    32524900007
    DIXON, Sally Veronica
    22 Ardleigh Road
    N1 4HP London
    Director
    22 Ardleigh Road
    N1 4HP London
    EnglandBritish105363350001
    GERSTROM, Peter Anton
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Director
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    EnglandBritish138719750001
    HARRISON, Julian John
    24 Havelock Road
    SY3 7NE Shrewsbury
    Salop
    Director
    24 Havelock Road
    SY3 7NE Shrewsbury
    Salop
    EnglandBritish123927990001
    HOLL, Alistair Myrie
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Director
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    WalesBritish138014840001
    JOHNSON, Peter Stuart
    The Old Post Office
    Church Road West Peckham
    ME18 5JL Maidstone
    Kent
    Director
    The Old Post Office
    Church Road West Peckham
    ME18 5JL Maidstone
    Kent
    EnglandBritish11159620001
    MILNES-JAMES, Richard Llewelyn
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Director
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritish140753960001
    PHILLIPS, John
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    Director
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    British343070001
    POLLARD, Charles Nicholas
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Director
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    EnglandBritish192011710001
    RIDDLE, David Ellison
    3 Lovelace Road
    KT6 6NS Surbiton
    Surrey
    Director
    3 Lovelace Road
    KT6 6NS Surbiton
    Surrey
    EnglandBritish556710002
    SCOTT, Jacqueline
    52 Mucklow Hill
    Halesowen
    B62 8BL Birmingham
    Director designado
    52 Mucklow Hill
    Halesowen
    B62 8BL Birmingham
    British900002260001
    STEGGLES, Jonathan David
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Director
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritish45141530001
    WARD, Malcolm John
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Director
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritish57775660003
    WELLS, Peter
    20a Collett Way
    Priorslee
    TF2 9SL Telford
    Salop
    Director
    20a Collett Way
    Priorslee
    TF2 9SL Telford
    Salop
    British45937400001
    WILLACY, Richard Johannes Ormerod
    Wraymead
    158 Croydon Road
    RH2 0NG Reigate
    Surrey
    Director
    Wraymead
    158 Croydon Road
    RH2 0NG Reigate
    Surrey
    United KingdomBritish92108930002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de IMCO RECONOMY 5 LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Waste Hire Service Limited
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    England
    06 abr 2016
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroUk
    Número de registro03441128
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene IMCO RECONOMY 5 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 20 ago 2015
    Entregado el 27 ago 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 ago 2015Registro de una carga (MR01)
    • 25 jul 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A supplemental common debenture
    Creado el 29 nov 2011
    Entregado el 08 dic 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 dic 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 24 ago 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of accession
    Creado el 18 may 2007
    Entregado el 25 may 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (Security Trustee)
    Transacciones
    • 25 may 2007Registro de un cargo (395)
    • 24 ago 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 26 abr 2005
    Entregado el 11 may 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee in its capacity as security agent for the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Cibc World Markets PLC
    Transacciones
    • 11 may 2005Registro de un cargo (395)
    • 23 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    First fixed and floating charge
    Creado el 26 may 1999
    Entregado el 04 jun 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    A first fixed charge on all book and other debts as are not sold or bought by alex lawrie receivable financing limited under an agreement dated 2ND june 1999 and a floating charge all proceeds of book and other debts with the payment of any sum due or owing to alex lawrie receivables financing limited under or in connection with any bill of exchange or other negotiable instrument to which both the company and alex lawrie receivables financing limited are a party.
    Personas con derecho
    • Alex Lawrie Receivables Financing Limited
    Transacciones
    • 04 jun 1999Registro de un cargo (395)
    • 05 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0