STANDARD CHARTERED TRUSTEES (UK) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | STANDARD CHARTERED TRUSTEES (UK) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03350300 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de STANDARD CHARTERED TRUSTEES (UK) LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra STANDARD CHARTERED TRUSTEES (UK) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 Basinghall Avenue EC2V 5DD London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de STANDARD CHARTERED TRUSTEES (UK) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para STANDARD CHARTERED TRUSTEES (UK) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 05 mar 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 19 mar 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 05 mar 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para STANDARD CHARTERED TRUSTEES (UK) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 05 mar 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Maria Alejandra Jacobson como director el 16 oct 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Michael Rose como director el 16 oct 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2024 | 5 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Palwinder Singh Hare como director el 14 may 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Palwinder Singh Hare como director el 25 abr 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Notification de Standard Chartered Bank en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 jun 2017 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessation de Standard Chartered Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 jun 2017 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cambio de datos del director Mr Justin Andrew Seymour Fowke el 05 feb 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Janice Yan Ping Yeo el 12 abr 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director The Law Debenture Pension Trust Corporation P.L.C. el 30 nov 2020 | 1 páginas | CH02 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 5 páginas | AA | ||
Nombramiento de Janice Yan Ping Yeo como director el 01 ago 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Peter John Phillip Gibbinson como director el 01 ago 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Justin Andrew Seymour Fowke el 01 sept 2019 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Peter John Phillip Gibbinson el 01 jul 2018 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Nigel John Richards el 17 dic 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 5 páginas | AA | ||
Nombramiento de Sonia Rossetti como director el 01 jul 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de STANDARD CHARTERED TRUSTEES (UK) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC (SECRETARIES) LIMITED | Secretario corporativo | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom |
| 126490730001 | ||||||||||
| FOWKE, Justin Andrew Seymour | Director | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 201778170003 | |||||||||
| HARE, Palwinder Singh | Director | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 149787070001 | |||||||||
| JACOBSON, Maria Alejandra | Director | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | United Kingdom | Australian | 341753820001 | |||||||||
| LAWRENCE, Linda Ann | Director | La Pearl, 4 Ashfield Lane BR7 6LQ Chislehurst Kent | United Kingdom | British | 7449690003 | |||||||||
| RICHARDS, Nigel John | Director | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 211600540002 | |||||||||
| ROSSETTI, Sonia | Director | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 187343520001 | |||||||||
| WHEELER, Christopher Paul | Director | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | Scotland | British | 146779280002 | |||||||||
| YEO, Janice Yan Ping | Director | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | United Kingdom | Singaporean | 298641000002 | |||||||||
| THE LAW DEBENTURE PENSION TRUST CORPORATION P.L.C. | Director corporativo | 100 Bishopsgate EC2N 4AG London 8th Floor United Kingdom |
| 146073480001 | ||||||||||
| CALLAHAN, Linda Ann | Secretario | 5 Sedcombe Close DA14 4QG Sidcup Kent | British | 7449690001 | ||||||||||
| DWYER, Daniel John | Secretario designado | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||||||
| FOX, Mark Adam | Secretario | 9 Trent Close WD7 9HX Shenley Hertfordshire | British | 79601950001 | ||||||||||
| GILL, Christopher Richard | Secretario | 104 Miles Road KT19 9AB Epsom Surrey | British | 58988340001 | ||||||||||
| SKIPPEN, Terry Charles | Secretario | 61 Richmond Road Leytonstone E11 4BX London | British | 54597200001 | ||||||||||
| THE LAW DEBENTURE PENSION TRUST CORPORATION P.L.C. | Secretario corporativo | 100 Wood Street EC2V 7EX London Fifth Floor United Kingdom |
| 146073480001 | ||||||||||
| BAILLIE, Robin Alexander Macdonald | Director | 19 Post Office Square London Road TN1 1BQ Tunbridge Wells Kent | British | 26138380004 | ||||||||||
| DAVIDSON, John Sneddon | Director | Longfield House 8 Dudsbury Road West Parley BH22 8RF Ferndown Dorset | British | 55271150003 | ||||||||||
| DOYLE, Betty June | Director designado | 8 The Bartons Elstree Hill North WD6 3EN Elstree Herts | British | 900003960001 | ||||||||||
| DWYER, Daniel John | Director designado | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||||||
| FLETCHER, David Martin | Director | Ickleton Place 32 Brookhampton Street Ickleton CB10 1SP Saffron Walden Essex | British | 141816590001 | ||||||||||
| FRANKLIN, William John | Director | 80 South Road CF36 3DA Porthcawl Mid Glamorgan | British | 8309500001 | ||||||||||
| GIBBINSON, Peter John Phillip | Director | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 245104280002 | |||||||||
| GRAY, Mark Douglas | Director | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | England | British | 155951830001 | |||||||||
| GREEN, Michael James | Director | The Hermitage High Street Twyford SO21 1RG Winchester Hampshire | British | 48480960001 | ||||||||||
| HARE, Palwinder Singh | Director | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 149787070001 | |||||||||
| HUNTER, Richard Andrew | Director | Holmfield Wonersh Common, Wonersh GU5 0PL Guildford Surrey | United Kingdom | British | 50520200002 | |||||||||
| JEBSON, Paul Stephen | Director | 22 Greystone Park TN14 6EB Sundridge Kent | United Kingdom | British | 93182210002 | |||||||||
| JULIUS, Laurence Jeffrey | Director | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | England | British | 22499730001 | |||||||||
| KELJIK, Christopher Avedis | Director | 62a Flood Street SW3 5TE London | England | British | 52296240002 | |||||||||
| LAWS, Gavin Crawford | Director | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 90826000001 | |||||||||
| LEICESTER, Mark Simon | Director | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 180135400002 | |||||||||
| MAXWELL, John Alexander | Director | Dalintober Ledaig PA37 1SA Oban Argyll | British | 63334440002 | ||||||||||
| MOORE, Sarah Alison | Director | 62 Ty Draw Road Penylan CF23 5HD Cardiff South Glamorgan | British | 118820740001 | ||||||||||
| ORSICH, Alan | Director | 5 Cary Walk WD7 8AP Radlett Hertfordshire | United Kingdom | British | 93237010001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de STANDARD CHARTERED TRUSTEES (UK) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Chartered Bank | 26 jun 2017 | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Standard Chartered Holdings Limited | 06 abr 2016 | Basinghall Avenue EC2V 5DD London 1 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0