ALLIGATOR STORAGE LTD.

ALLIGATOR STORAGE LTD.

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaALLIGATOR STORAGE LTD.
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03356309
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ALLIGATOR STORAGE LTD.?

    • Operación de instalaciones de almacenamiento y depósito para actividades de transporte terrestre (52103) / Transporte y almacenamiento

    ¿Dónde se encuentra ALLIGATOR STORAGE LTD.?

    Dirección de la sede social
    Brittanic House
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Hertfordshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ALLIGATOR STORAGE LTD.?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    KEEPSAFE LIMITED10 sept 199710 sept 1997
    LAWGRA (NO.422) LIMITED18 abr 199718 abr 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ALLIGATOR STORAGE LTD.?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 oct 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ALLIGATOR STORAGE LTD.?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 nov 2019

    9 páginasLIQ03

    Declaración de solvencia

    6 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 30 nov 2018

    LRESSP

    Cese del nombramiento de Sam Ahmed como secretario el 30 sept 2018

    1 páginasTM02

    Comptes modifiés pour une petite entreprise établis au 30 sept 2015

    17 páginasAAMD

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 25 sept 2018

    • Capital: GBP 1.48
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 oct 2017

    26 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 18 abr 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Exercice comptable précédent prolongé du 30 sept 2017 au 31 oct 2017

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Rajveer Ranawat como director el 01 nov 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Akbar Abdul Rafiq como director el 01 nov 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Diego Arroyo como director el 01 nov 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Frederico Oliva como director el 01 nov 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mehran Charania como director el 01 nov 2017

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 033563090018

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 033563090020

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 033563090017

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 033563090019

    1 páginasMR04

    Nombramiento de Mr Andrew Brian Jones como director el 01 nov 2017

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de ALLIGATOR STORAGE LTD.?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    JONES, Andrew Brian
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Brittanic House
    Hertfordshire
    England
    Director
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Brittanic House
    Hertfordshire
    England
    EnglandEnglish178066050001
    VECCHIOLI, Federico
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Brittanic House
    Hertfordshire
    England
    Director
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Brittanic House
    Hertfordshire
    England
    EnglandFrench158800170002
    AHMED, Sam
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Brittanic House
    Hertfordshire
    England
    Secretario
    Stirling Way
    WD6 2BT Borehamwood
    Brittanic House
    Hertfordshire
    England
    239675980001
    SMYTH, Michael Anthony
    8 Regent Square
    WC1H 8HZ London
    Secretario
    8 Regent Square
    WC1H 8HZ London
    British4337440001
    GILLESPIE MACANDREW SECRETARIES LIMITED
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroSC287766
    110304810001
    LAWGRAM SECRETARIES LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    Secretario designado corporativo
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    900004760001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Secretario corporativo
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    ARROYO, Diego
    Savile Row
    W1S 2ET London
    23
    United Kingdom
    Director
    Savile Row
    W1S 2ET London
    23
    United Kingdom
    EnglandMexican192493040001
    BAILLIE, Mark William
    Little Stream
    Woodlands Road West
    GU25 4PN Virginia Water
    Surrey
    Director
    Little Stream
    Woodlands Road West
    GU25 4PN Virginia Water
    Surrey
    Australian112156520002
    CARPENTER, Malcolm Edward
    100 Pennycress Way
    MK16 8TT Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Director
    100 Pennycress Way
    MK16 8TT Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    British115886430001
    CHARANIA, Mehran
    Dorset Street
    W1V 6QU London
    11 Bryanston House
    United Kingdom
    Director
    Dorset Street
    W1V 6QU London
    11 Bryanston House
    United Kingdom
    United KingdomBelgian104274770001
    CLARKE, Christine
    Sloane Avenue
    SW3 3XB London
    Mgpa 60
    United Kingdom
    Director
    Sloane Avenue
    SW3 3XB London
    Mgpa 60
    United Kingdom
    British138932540001
    CLEGG, Michael Bailey
    Upwey 36 Old Turnpike
    PO16 7HA Fareham
    Hampshire
    Director
    Upwey 36 Old Turnpike
    PO16 7HA Fareham
    Hampshire
    British57300000001
    EDGE, Roderick Boris Clifford
    The Water Tower Knoll Road
    GU7 2EJ Godalming
    Surrey
    Director
    The Water Tower Knoll Road
    GU7 2EJ Godalming
    Surrey
    SurreyBritish15622690001
    HODGSON, Simon Squair
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United Kingdom
    Director
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish89025200003
    JACK, Alister William
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    Director
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    ScotlandBritish159211330001
    JEFFREY, Alexander Daniel
    Ainger Road
    NW 3AH London
    46a
    Director
    Ainger Road
    NW 3AH London
    46a
    United KingdomBritish129962520001
    LANDALE, Peter David Roper
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    Director
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United KingdomBritish49635220001
    LUCCIONI, Laurent Xavier
    Sloane Avenue
    SW3 3XB London
    Mgpa 60
    United Kingdom
    Director
    Sloane Avenue
    SW3 3XB London
    Mgpa 60
    United Kingdom
    United KingdomFrench131705720001
    OLIVA, Frederico
    Savile Row
    W1S 2ET London
    23
    United Kingdom
    Director
    Savile Row
    W1S 2ET London
    23
    United Kingdom
    United KingdomItalian192498980001
    PERUSAT, Marc Michel
    Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Level 35
    United Kingdom
    Director
    Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Level 35
    United Kingdom
    United KingdomFrench115589250001
    PULIDO, Rena
    125 W Delaware Place
    FOREIGN Chicago
    Illinois Il 60610
    United States
    Director
    125 W Delaware Place
    FOREIGN Chicago
    Illinois Il 60610
    United States
    Australian122049340001
    RAFIQ, Akbar Abdul Aziz
    Savile Row
    W1S 2ET London
    23
    Director
    Savile Row
    W1S 2ET London
    23
    EnglandBritish,Pakistani192308760001
    RANAWAT, Rajveer
    Chatsworth Road
    Cricklewood
    NW2 4BT London
    40
    United Kingdom
    Director
    Chatsworth Road
    Cricklewood
    NW2 4BT London
    40
    United Kingdom
    EnglandBritish179208350001
    SANTER, Christopher John
    Jedburgh Street
    Clapham
    SW11 5QB London
    6
    Director
    Jedburgh Street
    Clapham
    SW11 5QB London
    6
    EnglandBritish128404730001
    SMITH, Nathan Robert
    England's Lane
    NW3 4YD London
    41b
    United Kingdom
    Director
    England's Lane
    NW3 4YD London
    41b
    United Kingdom
    Australian136694070001
    SMITH, Nathan Robert
    Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Level 35
    United Kingdom
    Director
    Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Level 35
    United Kingdom
    Australian123776780001
    SMYTH, Michael Anthony
    8 Regent Square
    WC1H 8HZ London
    Director
    8 Regent Square
    WC1H 8HZ London
    EnglandBritish4337440001
    STREET, Stephen Gregory
    10 English Street
    Mile End
    E3 4TA London
    United Kingdom
    Director
    10 English Street
    Mile End
    E3 4TA London
    United Kingdom
    British47656020001
    TAYLOR, Michael James
    Stanley Hill Ave
    Amersham
    HP7 9BB London
    39
    United Kingdom
    Director
    Stanley Hill Ave
    Amersham
    HP7 9BB London
    39
    United Kingdom
    Australian128209530001
    WILKINSON, Charles Edmund
    Utopia
    Rue De La Passee
    GY2 4TN St Sampsons
    Channel Islands
    Director
    Utopia
    Rue De La Passee
    GY2 4TN St Sampsons
    Channel Islands
    GuernseyBritish127529840001
    WONG, Lilian
    Martin Place
    2000 Syndney
    1
    New South Wales
    Australia
    Director
    Martin Place
    2000 Syndney
    1
    New South Wales
    Australia
    Australian139160950001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ALLIGATOR STORAGE LTD.?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Storage Uk Spv1 Ltd
    Duke Street
    W1U 1LN London
    3rd Floor 37 Duke Street
    England
    06 abr 2016
    Duke Street
    W1U 1LN London
    3rd Floor 37 Duke Street
    England
    No
    Forma jurídicaLimited
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom Company Law
    Lugar de registroEngland
    Número de registro06271294
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) tienen el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) tienen el derecho de ejercer, o realmente ejercen, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene ALLIGATOR STORAGE LTD. alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 02 dic 2014
    Entregado el 05 dic 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited as Security Agent
    Transacciones
    • 05 dic 2014Registro de una carga (MR01)
    • 02 nov 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 16 oct 2014
    Entregado el 29 oct 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    T/Nos WM742950 BL82345 SY291399 BD255255 NT329242 HP116380 and HP700117.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited
    Transacciones
    • 29 oct 2014Registro de una carga (MR01)
    • 02 nov 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 16 oct 2014
    Entregado el 29 oct 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited
    Transacciones
    • 29 oct 2014Registro de una carga (MR01)
    • 02 nov 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 16 oct 2014
    Entregado el 28 oct 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited
    Transacciones
    • 28 oct 2014Registro de una carga (MR01)
    • 02 nov 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 29 jun 2012
    Entregado el 07 jul 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 07 jul 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 03 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 29 jun 2012
    Entregado el 03 jul 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a honeygrove house bond street southampton t/n HP116380.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jul 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 03 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 29 jun 2012
    Entregado el 03 jul 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a sunbury house farnham trading estate farnham t/no SY291399.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jul 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 03 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 29 jun 2012
    Entregado el 03 jul 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/A property k/a unit 9 freshfield industrial estate kemp town brighton t/no ESX285601 ESX340864.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jul 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 03 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 29 jun 2012
    Entregado el 03 jul 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a woodhall underground garages robert street london.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jul 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 03 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 29 jun 2012
    Entregado el 03 jul 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a 214 - 224 broomhill road bristol t/no BL82345.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jul 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 03 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 29 jun 2012
    Entregado el 03 jul 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a 20 moorside road winchester t/no HP700117.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jul 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 03 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 29 jun 2012
    Entregado el 03 jul 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a unit 12 cosgrove way luton t/no BD255255.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jul 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 03 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 29 jun 2012
    Entregado el 03 jul 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land and buildings at bath street tec nottingham t/no NT329242.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jul 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 03 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 29 jun 2012
    Entregado el 03 jul 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a land and buildings on the north side of garretts green lane sheldon birmingham t/no WM742950.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jul 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 03 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 28 ene 2010
    Entregado el 09 feb 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due form each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery for details of properties charged please refer to form MG01 see image for full details.
    Personas con derecho
    • Capita Trust Company Limited (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 09 feb 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 04 jul 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creado el 10 ene 2008
    Entregado el 14 ene 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Sunbury house farnham trading estate farnham t/n SY291399,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Capita Trust Company Limited
    Transacciones
    • 14 ene 2008Registro de un cargo (395)
    • 04 jul 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 19 oct 2007
    Entregado el 08 nov 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    For details of properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Capita Trust Company Limited (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 08 nov 2007Registro de un cargo (395)
    • 04 jul 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage
    Creado el 29 nov 2005
    Entregado el 02 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £75,000 and all other monies due or to become due
    Breve descripción
    The standard and double ender 20' containers with the following unit/series numbers ornu 301345 ornu 301256 ornu 300623 for further details of chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 31 oct 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 30 ago 2000
    Entregado el 05 sept 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 sept 2000Registro de un cargo (395)
    • 31 oct 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 17 abr 1998
    Entregado el 22 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Bath street tec nottingham nottinghamshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 22 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 31 oct 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene ALLIGATOR STORAGE LTD. algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    30 nov 2018Inicio de la liquidación
    07 mar 2021Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Steven Sherry
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Profesional
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Profesional
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0