HI FINANCE PROPERTIES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | HI FINANCE PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03363702 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
- Hoteles y alojamientos similares (55100) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida
¿Dónde se encuentra HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HOLIDAY INN FINANCE PROPERTIES LIMITED | 16 jul 2002 | 16 jul 2002 |
| COMPASS HOTEL PROPERTIES LIMITED | 31 ene 2001 | 31 ene 2001 |
| GRANADA HOTEL PROPERTIES LIMITED | 26 sept 1997 | 26 sept 1997 |
| 2036TH SINGLE MEMBER SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED | 01 may 1997 | 01 may 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 17 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 nov 2018 | 16 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Justin Bruce Robinson como director el 14 sept 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 10 Queen Street Place London EC4R 1AG | 2 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 10 Queen Street Place London EC4R 1AG | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR el 21 dic 2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 6 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del secretario Haysmacintyre Company Secretaries Limited el 18 dic 2017 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Justin Bruce Robinson el 18 dic 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Simon Michael Teasdale el 18 dic 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom a 10 Queen Street Place London EC4R 1AG el 18 dic 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Patrick Thomas Mabry el 18 dic 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 033637020006 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 20 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 03 oct 2017
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 oct 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 033637020006 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Justin Bruce Robinson el 03 feb 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 oct 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| MABRY, Patrick Thomas | Director | Little New Street EC4A 3TR London Hill House 1 | Luxembourg | German | 204005420001 | |||||||||
| TEASDALE, Simon Michael | Director | Little New Street EC4A 3TR London Hill House 1 | United Kingdom | British | 204008350001 | |||||||||
| COMBEER, Jean Brenda | Secretario | Robin Hill 3 St Johns Avenue KT22 7HT Leatherhead Surrey | British | 50345500001 | ||||||||||
| ENGMANN, Catherine | Secretario | 18 Rays Avenue SL4 5HG Windsor Berkshire | British | 92722710002 | ||||||||||
| LOYNES, Paul | Secretario | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | 203651900001 | |||||||||||
| MASON, Timothy Charles | Secretario | 231 Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | British | 12314170002 | ||||||||||
| TAUTZ, Helen Jane | Secretario | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | British | 37564540001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Alison | Secretario | 27 Valley Road CM11 2BS Billericay Essex | British | 78744290002 | ||||||||||
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Bishops Square Eighth Floor E1 6EG London Ten United Kingdom |
| 125623230001 | ||||||||||
| SISEC LIMITED | Secretario designado corporativo | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001770001 | |||||||||||
| BAKER, Skardon Francis | Director | St. George Street W1S 1FS London 25 | United Kingdom | American | 196342720001 | |||||||||
| CARTWRIGHT, Stacey Lee | Director | 46 Chiddingstone Road SW6 3TG London | British | 37682070002 | ||||||||||
| CROSTON, Francis John | Director | 5 The Laurels Queenborough Lane CM77 7QD Braintree Essex | United Kingdom | British | 65219360003 | |||||||||
| DAVENPORT, Donald Andrew | Director | Ramsbury House 23 Badgers Hill Wentworth GU25 4SA Virginia Water Surrey | United Kingdom | British | 13178710003 | |||||||||
| DEMPSEY, Patrick Joseph Anthony | Director | Cuckoo Meadow Little Shardeloes HP7 0EF Old Amersham Buckinghamshire | England | British | 100598030001 | |||||||||
| EKAS, Petra Cecilia Maria | Director | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 169731050002 | |||||||||
| FISH, Andrew John | Director | Cherry Tree Cottage Manor Close KT24 6SA East Horsley Surrey | England | British | 77133450001 | |||||||||
| KOLEV, Ivaylo | Director | St. George Street W1S 1FS London 25 | Uk | Bulgarian | 193389430001 | |||||||||
| LOYNES, Paul | Director | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 241370450001 | |||||||||
| MACKENZIE, Lisa Marie | Director | 70 Vassall Road Kennington SW9 6HY London | British | 78059700001 | ||||||||||
| MARTIN, Andrew David | Director | 5 Dalkeith Road AL5 5PP Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | 52743800001 | |||||||||
| MCCARTHY, John Patrick | Director | Regents Park Road NW1 8XL London 120 | United States | 112396050001 | ||||||||||
| MCEWAN, Allan Scott | Director | 29 Kings Road SL4 2AD Windsor Berkshire | United Kingdom | British | 75569660002 | |||||||||
| MITCHELL, Paul Raymond | Director | Waltons Farm Hollygreen Lane HP27 9PL Bledlow Bucks England | England | British | 148147140001 | |||||||||
| MORTIMER, David Grant | Director | 86 Frenchay Road OX2 6TF Oxford Oxfordshire | British | 47770480002 | ||||||||||
| NEWMAN, Mark | Director | Flat 7 44 Sloane Street SW1X 9LU London | United Kingdom | Canadian | 62529820001 | |||||||||
| PARROTT, Graham Joseph | Director | Flat 1 27 Redington Road Hampstead NW3 7QY London | British | 6741720003 | ||||||||||
| PRINCE, Ryan David | Director | 7a Howick Place SW1P 1DZ London 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 85682450077 | |||||||||
| ROBINSON, Justin Bruce | Director | Little New Street EC4A 3TR London Hill House 1 | United Kingdom | British | 225299130001 | |||||||||
| SPRINGETT, Catherine Mary | Director | The Coach House 32 Kerrison Road Ealing W5 5NW London | United Kingdom | British | 147336720001 | |||||||||
| STAUNTON, Henry Eric | Director | Fairfield Nursery Road KT20 7TZ Walton On The Hill Surrey | England | British | 37935500001 | |||||||||
| STOCKS, Nigel Peter | Director | Birdwoods School Lane Shackleford GU8 6AZ Godalming Surrey | United Kingdom | British | 147336730001 | |||||||||
| STRETTON, Mark Nigel | Director | Top Cottage Upper Oddington GL56 0XN Moreton-In-Marsh | British | 95909440001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HI FINANCE PROPERTIES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nas Cobalt No.2 Limited | 06 abr 2016 | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene HI FINANCE PROPERTIES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 01 dic 2015 Entregado el 02 dic 2015 | Pendiente | ||
Breve descripción F/H crest hotel filton road hambrook t/no.AV194979 and l/h the bloomsbury crest hotel coram stret t/no.NGL672413. Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 22 may 2013 Entregado el 03 jun 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción F/H basingstoke crest hotel grove road basingstoke t/no HP409818, f/h black prince hotel southwold road bexley t/no SGL103988, f/h crest hotel filton road hambrook t/no AV194979, for details of further properties charged please refer to the form MR01. Notification of addition to or amendment of charge. Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage | Creado el 20 jun 2005 Entregado el 28 jun 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge | |
Breve descripción L/H crowne plaza birmingham nec at national exhibition centre birmingham west midlands t/n WM722535 f/h crowne plaza london - heathrow at land and buildings on the west side of stockley road and the north side of cherry lane west drayton t/n NGL160680 f/h holiday inn brentwood at brook street brentwood t/n EX323558 * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 20 jun 2005 Entregado el 22 jun 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 241097 | Creado el 24 oct 1997 Entregado el 07 nov 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The erskine crest hotel erskine renfrew t/n REN57421. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 24 oct 1997 Entregado el 29 oct 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from granada group PLC to the chargee pursuant to the terms of the loan agreement of even date together with any other monies payable by the company to the chargee under the legal charge | |
Breve descripción Basingstoke posthouse (formerly basingstoke crest hotel) basingstoke hampshire T.no: HP409818; bexley posthouse (formerly k/a black prince public house) rochester way l/b of bexley t/no: SGL103988; bristol posthouse (formerly crest hotel) filton house hambrrok south gloucestershire t/no: AV194979. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene HI FINANCE PROPERTIES LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0