KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED

KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED
    Estado de la empresaConvertida/Cerrada
    Forma jurídicaConvertida o cerrada
    Número de empresa 03372093
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    • Venta al por menor en establecimientos no especializados predominando la venta de alimentos, bebidas o tabaco (47110) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PRICESTORE LIMITED16 may 199716 may 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta11 ene 2015

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Misceláneos

    Forms b & z convert to rs
    2 páginasMISC

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Convert to rs 02/06/2016
    RES13

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 02 jun 2016

    • Capital: GBP 2,800,002
    3 páginasSH01

    Nombramiento de Mr David Roberts como director el 01 abr 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Steven Clive Bailey como director el 01 abr 2016

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 27 abr 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 abr 2016

    Estado de capital el 28 abr 2016

    • Capital: GBP 2,800,000
    SH01

    Cancelación total de la carga 8

    1 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 11 ene 2015

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 abr 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 may 2015

    Estado de capital el 01 may 2015

    • Capital: GBP 2,800,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 02 ene 2014

    4 páginasAA

    Exercice comptable en cours prolongé du 02 ene 2015 au 11 ene 2015

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 ago 2014

    Estado de capital el 29 ago 2014

    • Capital: GBP 2,800,000
    SH01

    Déclaration annuelle établie au 27 abr 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 may 2014

    Estado de capital el 06 may 2014

    • Capital: GBP 2,800,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 05 ene 2013

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 abr 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Domicilio social registrado cambiado de * New Century House Corporation Street Manchester M60 4ES* el 03 dic 2012

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 27 abr 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    4 páginasAA

    Nombramiento de Cws (No.1) Limited como director

    2 páginasAP02

    Nombramiento de Mr Steven Clive Bailey como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Humes como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Timothy Hurrell como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 27 abr 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 01 ene 2011

    4 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Timothy Hurrell el 01 ago 2010

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SELLERS, Caroline Jane
    1 Gale Close
    Littleborough
    OL15 9EJ Rochdale
    Lancashire
    Secretario
    1 Gale Close
    Littleborough
    OL15 9EJ Rochdale
    Lancashire
    British45801060004
    ROBERTS, David Francis
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Director
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish200852560001
    CWS (NO.1) LIMITED
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Director corporativo
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro1925625
    130695310001
    COBURN, Ian David
    6 Sorrel Drive
    GU18 5PB Lightwater
    Surrey
    Secretario
    6 Sorrel Drive
    GU18 5PB Lightwater
    Surrey
    British3000420001
    COUSINS, Alan Gordon Arthur
    94 Bridge Road
    SO31 7EP Sarisbury Green
    Hampshire
    Secretario
    94 Bridge Road
    SO31 7EP Sarisbury Green
    Hampshire
    British57534360001
    WHITTAKER, Katherine Alison
    22 Westfield Drive
    Woodley
    SK6 1LD Stockport
    Cheshire
    Secretario
    22 Westfield Drive
    Woodley
    SK6 1LD Stockport
    Cheshire
    British29899300002
    EXCELLET INVESTMENTS LIMITED
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    Secretario corporativo
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    1872620003
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretario designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BAILEY, Steven Clive
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Director
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish95753690002
    BRAITHWAITE, Neil
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    Director
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    EnglandBritish87486660004
    CHEYNE, David George Thomson
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    Director
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    BritainBritish74956170001
    CLAPHAM, David John
    4 Heritage Hill
    BR2 6AU Keston
    Kent
    Director
    4 Heritage Hill
    BR2 6AU Keston
    Kent
    United KingdomBritish29705630001
    COBURN, Ian David
    6 Sorrel Drive
    GU18 5PB Lightwater
    Surrey
    Director
    6 Sorrel Drive
    GU18 5PB Lightwater
    Surrey
    British3000420001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    Aylesbury House
    Horsebridge Road Broughton
    SO20 8BD Stockbridge
    Hampshire
    Director
    Aylesbury House
    Horsebridge Road Broughton
    SO20 8BD Stockbridge
    Hampshire
    British91828160001
    HOLLAND, Joseph
    87 Chapleton Road
    Bromley Cross
    BL7 9LZ Bolton
    Lancashire
    Director
    87 Chapleton Road
    Bromley Cross
    BL7 9LZ Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish14141950001
    HOOKE, Anthony Arnold
    Cedars Wildwood Gardens
    Dingels Lane Cricket Hill
    GU46 6EB Yateley
    Hampshire
    Director
    Cedars Wildwood Gardens
    Dingels Lane Cricket Hill
    GU46 6EB Yateley
    Hampshire
    British69353000002
    HUMES, Stephen
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Director
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritish84087790001
    HURRELL, Timothy
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Director
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritish99724260001
    LAWSON, Stuart
    Treetops Smithwood Avenue
    GU6 8PS Cranleigh
    Surrey
    Director
    Treetops Smithwood Avenue
    GU6 8PS Cranleigh
    Surrey
    British60361810001
    MCCRACKEN, Philip Guy
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    Director
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish106997230001
    ROBSON, William Henry Mark
    90 Springfield Road
    SL4 3PH Windsor
    Berkshire
    Director
    90 Springfield Road
    SL4 3PH Windsor
    Berkshire
    British57803420001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Director designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001
    QUICKNESS LIMITED
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    Director corporativo
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    47109420002

    ¿Tiene KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Creado el 31 may 2001
    Entregado el 06 jun 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to the chargee and each of the secured parties
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent and Security Trustee for Itself and the Secured Parties (as Defined) (the "Security Trustee")
    Transacciones
    • 06 jun 2001Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 18 may 1999
    Entregado el 21 may 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that l/h property k/a 105A junction road andover hampshire and the proceeds of sale all planat machinery fixtures and fittings goodwill and the benefit of the option dated 18/05/99.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 21 may 1999Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 abr 1999
    Entregado el 12 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Premises known as the maisonette/shop at 2/3 atholl court,kingsway gardens andover; see form 395. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 12 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 feb 1999
    Entregado el 25 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a 150A junction road andover hampshire the benefit of the option dated 23 february 1999 between the company and alldays stores limited. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 25 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 26 ene 1999
    Entregado el 28 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    Ground floor shop and first floor office premises at 5 queens road farnborough hants. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 28 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 ene 1999
    Entregado el 07 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Ground floor shop premises and first and second floor maisonettes at 1/5 elizabeth parade tudor drive yateley hants. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 07 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 10 nov 1998
    Entregado el 24 nov 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 570 wokingham road earley reading-BK84581 assigned the benefit of the option dated 10TH november 1998 between the company and alldays stores limited relating to the property (the option). By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 24 nov 1998Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 nov 1998
    Entregado el 09 nov 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property at 8 alexandra road north camp farnborough hampshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 09 nov 1998Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of variation to a legal charge dated 21 august 1998
    Creado el 20 oct 1998
    Entregado el 28 oct 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property means the ground floor shop premises at 286 gosbrook road caversham reading berkshire.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 28 oct 1998Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 sept 1998
    Entregado el 30 sept 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Leasehold property k/a 109/113 queens road aldershot hampshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 30 sept 1998Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 sept 1998
    Entregado el 18 sept 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land at ash street ash surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 18 sept 1998Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 21 ago 1998
    Entregado el 09 sept 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Piece or parcel of land at the ground floor shop premises at 286 gosbrook road caversham reading berkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 09 sept 1998Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 jun 1998
    Entregado el 15 jul 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Ground floor shop premises at 1 and 2 giles court brookside walk tadley hampshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 15 jul 1998Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 05 mar 1998
    Entregado el 18 mar 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal charge
    Breve descripción
    The company charges the property being land at ground floor shop premises at 53 high street aldershot hampshire GU11 1BH t/n-HP371495 (to the full extent of the company's interest in the property or its proceeds of sale) by way of legal mortagage of all legal interests and otherwise by way of specific equitable charge, assigned the benefit of all covenants and rights affecting or concerning the property subject to re-assignment on redemption, by way of fixed charge all the plant machinery and fixtures and fittings equipment and utensils, all the present or future goodwill of any business.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 18 mar 1998Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 dic 1997
    Entregado el 24 dic 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The l/h property k/a ground floor and basement 55/57 erleigh road reading berkshire the goodwill of the business and the benefit of the option dated 23 december 1997 between the company and alldays stores limited. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 24 dic 1997Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 17 nov 1997
    Entregado el 19 nov 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Ground floor and basement at 133/135 oxford road reading berkshire RG1 7UU t/n BK285171 all legal ineterests and otherwise by specific equitable charge assinged the benefit of all covenants and rights fixed charge all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements utensils all present or future goodwill of any business assigns the benefit of the option of even date.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 19 nov 1997Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 21 oct 1997
    Entregado el 24 oct 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 5TH february 1990
    Breve descripción
    The rent deposit being an amount equal to 6 months rent from time to time firstly reserved by the lease being at the date of creation of the charge a deposit of £6,500.
    Personas con derecho
    • Double Reading Limited
    Transacciones
    • 24 oct 1997Registro de un cargo (395)
    • 22 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 15 oct 1997
    Entregado el 24 oct 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    That piece or parcel of land at 1 anstey close, basingstoke, hampshire and the goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 24 oct 1997Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 09 sept 1997
    Entregado el 12 sept 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Piece or parcel of land at 27/31 high street chobham surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 12 sept 1997Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 09 sept 1997
    Entregado el 12 sept 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Piece or parcel of land at 37 guildford road lightwater surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 12 sept 1997Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 22 ago 1997
    Entregado el 27 ago 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    That piece or parcel of land at 8 alexandra road north camp farnborough hants t/no.HP527455 and goodwill of any business.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 27 ago 1997Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 15 ago 1997
    Entregado el 22 ago 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property k/a 132 cove road farnborough hants t/no HP504574 by way of fixed charge all the present or future goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 22 ago 1997Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 ago 1997
    Entregado el 22 ago 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 22 ago 1997Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 jul 1997
    Entregado el 28 jul 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Alldays Stores Limited
    Transacciones
    • 28 jul 1997Registro de un cargo (395)
    • 20 nov 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 jul 1997
    Entregado el 28 jul 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Alldays Franchising Limited
    Transacciones
    • 28 jul 1997Registro de un cargo (395)
    • 20 nov 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0