AGEWELL & LUNCH CLUBS IN SHEFFIELD LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | AGEWELL & LUNCH CLUBS IN SHEFFIELD LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
Número de empresa | 03374012 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de AGEWELL & LUNCH CLUBS IN SHEFFIELD LIMITED?
- Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra AGEWELL & LUNCH CLUBS IN SHEFFIELD LIMITED?
Dirección de la sede social | The Hart Shaw Building Europa Link Sheffield Business Park S9 1XU Sheffield South Yorkshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AGEWELL & LUNCH CLUBS IN SHEFFIELD LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
AGEWELL IN SHEFFIELD LIMITED | 20 may 1997 | 20 may 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de AGEWELL & LUNCH CLUBS IN SHEFFIELD LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para AGEWELL & LUNCH CLUBS IN SHEFFIELD LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||
Cese del nombramiento de Kevin Tandy como director el 09 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Diane Riad-Smith como director el 09 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Fathir Khan como director el 09 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Ahmed Gul como director el 09 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Dorrett Buckley Greaves como director el 09 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Peter Garner como director el 09 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Margaret Callaghan como director el 09 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2016 | 12 páginas | AA | ||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 mar 2016 au 30 sept 2016 | 1 páginas | AA01 | ||
Déclaration annuelle établie au 20 may 2016, aucune liste de membres fournie | 6 páginas | AR01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2015 | 15 páginas | AA | ||
Déclaration annuelle établie au 20 may 2015, aucune liste de membres fournie | 10 páginas | AR01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2014 | 16 páginas | AA | ||
Déclaration annuelle établie au 20 may 2014, aucune liste de membres fournie | 10 páginas | AR01 | ||
Cambio de datos del director Ahmed Gul el 20 may 2014 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Margaret Callaghan el 20 may 2014 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Peter Garner el 20 may 2014 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Fathir Khan el 20 may 2014 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Bradley Blake como director | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2013 | 16 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de * Westbourne Place 23 Westbourne Road Sheffield South Yorkshire S10 2QQ* el 15 nov 2013 | 2 páginas | AD01 | ||
¿Quiénes son los directivos de AGEWELL & LUNCH CLUBS IN SHEFFIELD LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HINDMARCH, Alan Mitchell, Rev | Secretario | Narrow Lane North Anston S25 4BG Sheffield 74 South Yorkshire England | British | 54576530001 | ||||||
HINDMARCH, Alan Mitchell, Rev | Director | Narrow Lane North Anston S25 4BG Sheffield 74 South Yorkshire England | England | British | Project Coordinator | 54576530002 | ||||
ADAMS, Doris | Secretario | 2 Warminster Crescent S8 9NW Sheffield South Yorkshire | British | Retired | 54576700001 | |||||
ROBINSON, Judith Ann | Secretario | 83 Liberty Drive S6 5QB Sheffield South Yorkshire | British | Retired | 82964890001 | |||||
HIGHSTONE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | Highstone House 165 High Street EN5 5SU Barnet Hertfordshire | 900014180001 | |||||||
ADAMS, Doris | Director | 2 Warminster Crescent S8 9NW Sheffield South Yorkshire | British | Retired | 54576700001 | |||||
ALI, Anjob | Director | 6 Uttley Drive Darnall S9 5BZ Sheffield South Yorkshire | British | Retired | 83111790001 | |||||
BLAKE, Bradley | Director | 33 Walton Road S11 8RE Sheffield South Yorkshire | Jamaican | None - Retired | 86488890001 | |||||
BROWN, Janet Anne, Captain | Director | 39 Park Grange Croft S2 3QJ Sheffield South Yorkshire | British | Minister Of Religion | 67480640001 | |||||
BUCKLEY GREAVES, Dorrett | Director | 8 Christchurch Road S3 9HN Sheffield South Yorkshire | England | Jamacian | None Retired | 86488700001 | ||||
CALLAGHAN, Margaret | Director | Stacye Rise Woodhouse S13 7RX Sheffield 11 South Yorkshire England | England | British | Retired | 77977470002 | ||||
CHADWICK, Delia Maureen | Director | 2 Kilton Hill S3 9EB Sheffield South Yorkshire | British | Company Director | 54791930001 | |||||
COHEN, Barry | Director | Flat 25 Brigadier Hargreaves Court 468 Stradbroke Road S13 7GB Sheffield | British | Retired | 62932250001 | |||||
DAWSON, Stanley | Director | 36 Goddard Hall Road S5 7AP Sheffield South Yorkshire | British | Retired | 77977440001 | |||||
GARNER, Peter | Director | 56 Hollins Lane Stannington S6 5GR Sheffield South Yorkshire | England | British | Retired | 90374650001 | ||||
GRANT, Vera | Director | 21 Ivy Park Road S10 3LA Sheffield South Yorkshire | British | Director | 54576870001 | |||||
GUL, Ahmed | Director | 240 Staniforth Road Attercliffe S9 3FS Sheffield South Yorkshire | England | British | Retired | 105510720002 | ||||
HAYWOOD REED, Pam | Director | 412 Abbeydale Road S7 1FQ Sheffield South Yorkshire | British | Retired | 82964760001 | |||||
KHAN, Fathir | Director | 313 Abbeydale Road S7 1FJ Sheffield South Yorkshire | England | Banglidashi | Retired | 82963830001 | ||||
LOMAS, Sheila | Director | Tapton Hill Road Crosspool S10 5GF Sheffield 177 South Yorkshire | British | Retired | 139583150001 | |||||
MCCORMICK, Louisa | Director | 74 Gilbert Row Parkhill North S2 5RY Sheffield South Yorkshire | British | Retired | 36649410001 | |||||
MIAH, Moklis | Director | 17 Titterton Street S9 3TE Sheffield South Yorkshire | British | Retired | 99402190001 | |||||
MILIEN, Lileth Urtensia | Director | 269 Woodseats Road S8 0PP Sheffield South Yorkshire | British | Director | 54576490001 | |||||
NEALE, Marian Phyllis | Director | 105 Deer Park View S6 5NN Sheffield South Yorkshire | British | Director | 54576560001 | |||||
RIAD-SMITH, Diane | Director | Binstead Road S5 8PD Sheffield 35 South Yorkshire England | England | British | Housewife | 169992310001 | ||||
ROBINSON, Judith Ann | Director | 83 Liberty Drive S6 5QB Sheffield South Yorkshire | British | Retired | 82964890001 | |||||
SMITH, Dora | Director | 29 Blackstock Close S14 1AE Sheffield South Yorkshire | British | Retired | 72612560001 | |||||
SWANN, Peter Frank | Director | 4 Hucklow Road S5 6TE Sheffield South Yorkshire | British | Retired | 51770980001 | |||||
TANDY, Kevin | Director | Harwood Drive S20 7LD Sheffield 9 South Yorkshire England | England | British | Retired | 169992410001 | ||||
TAYLOR, Dorothy | Director | 54 Hutcliffe Wood Road S8 0FA Sheffield South Yorkshire | British | Retired | 82964590001 | |||||
WEATHERALL, Doreen | Director | 60 Newbould Crescent Beighton S20 1FF Sheffield South Yorkshire | British | Retired | 82964340001 | |||||
WHEELDON, John | Director | 31 Old Hay Close S17 3GP Sheffield South Yorkshire | British | Director | 54576940001 | |||||
WHITE, Jean | Director | 34 Monckton Road S5 6AL Sheffield South Yorkshire | British | Care Assistant | 83111690001 | |||||
YAQOOB, Mohammed | Director | 66 Swarcliffe Road S9 3FB Sheffield South Yorkshire | Pakistan | Retired | 82964470001 | |||||
HIGHSTONE DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | Highstone House 165 High Street EN5 5SU Barnet Hertfordshire | 900014170001 |
¿Tiene AGEWELL & LUNCH CLUBS IN SHEFFIELD LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Creado el 29 oct 2009 Entregado el 31 oct 2009 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Property at 135 upperthorpe road, sheffield with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 20 may 2009 Entregado el 23 may 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H 135 upperthorpe road sheffield t/no SYK400197 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0