CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03374064 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?
- Desarrollo de software para negocios y hogares (62012) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 92 London Street RG1 4SJ Reading Berkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| THALES TELEMATICS PLC | 02 ene 2002 | 02 ene 2002 |
| THALES TELEMATICS PLC | 02 ene 2002 | 02 ene 2002 |
| GLOBAL TELEMATICS PLC | 15 may 1997 | 15 may 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2012 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores | 12 páginas | 4.72 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 09 sept 2013 | 11 páginas | 4.68 | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 2 páginas | F10.2 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Priory Park Great North Road Aberford West Yorkshire LS25 3DF United Kingdom* el 20 sept 2012 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19 | 6 páginas | 4.20 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012 | 20 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG04 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG04 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 may 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Cybit Holdings Plc Cybit House Kingfisher Way Hinchingbrooke Business Park Huntingdon Cambridgeshire PE29 6FN* el 29 mar 2012 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nicholas Williams como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Henry como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Waterhouse como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2011 au 31 mar 2012 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Paul Francis Bosson como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Paul Keith Waterhouse como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Nicholas Williams como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 31 mar 2012 au 31 dic 2011 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSSON, Paul Francis | Director | London Street RG1 4SJ Reading 92 Berkshire | England | British | 82707040001 | |||||
| BELCHER, John Victor | Secretario | 5 Woodpecker Close Twyford RG10 0BB Reading Berkshire | British | 10018180001 | ||||||
| LAWRENCE, Kevin Brian | Secretario | Kingsbury House Arlington GL7 5ND Bibury Gloucestershire | British | 169886380001 | ||||||
| PRICE, Trevor Sheldon | Secretario | 39 Wolsey Road KT10 8NT Esher Surrey | British | 47797870003 | ||||||
| SEABROOK, Michael William Peter | Secretario | 40 Horsell Park Close Horsell GU21 4LZ Woking Surrey | British | 70900110002 | ||||||
| WATERHOUSE, Paul Keith | Secretario | Cybit Holdings Plc Cybit House Kingfisher Way Hinchingbrooke PE29 6FN Business Park Huntingdon Cambridgeshire | 165522040001 | |||||||
| PAILEX CORPORATE SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | First Floor Bouverie House 154 Fleet Street EC4A 2DQ London | 900013000001 | |||||||
| AKBARI, Homaira | Director | 5 Rue Du Pont De Lodi 75006 FOREIGN Paris France | American | 86832440001 | ||||||
| ASHTON, Max William Simon | Director | 11 Holne Chase N2 0QP London | United Kingdom | British | 73381460001 | |||||
| BARTLETT, Robert | Director | 38 Ardingly Great Hollands RG12 8XR Bracknell Berkshire | British | 71790550001 | ||||||
| BELGEONNE, Edward | Director | Winters Barn Cottage Frensham Lane GU35 8RU Headley Hampshire | British | 4264610006 | ||||||
| BRUEGGER, Edmund Peter | Director | Cholwell Farm Clutton BS39 5TG Bristol | England | British | 13417490001 | |||||
| BRUEGGER, Edmund Peter | Director | Cholwell Farm Clutton BS39 5TG Bristol | England | British | 13417490001 | |||||
| CHEVREL, Roger Jean Marius | Director | 16 Route Du Domaine Le Vesinet 78110 France | French | 16515610001 | ||||||
| COLLINS, David Anthony | Director | First Floor, Bouverie House 154 Fleet Street EC4A 2DQ London | British | 74345090001 | ||||||
| GALLAGHER, Daniel Joseph | Director | 9 Cavendish Meads Sunninghill SL5 9TB Ascot Berkshire | British And Irish | 49885010001 | ||||||
| GRIFFITHS, David Wynne | Director | 6 Woodrough Copse Birtley Road Bramley GU5 0HH Guildford Surrey | British | 63953750001 | ||||||
| GUERIN, Stanislas Philippe | Director | 116 Boulevard Raspail 75006 Paris France | French | 69237660001 | ||||||
| HARDY, Warren Andrew | Director | Great Gables Burkes Crescent HP9 1PD Beaconsfield Buckinghamshire | British | 68425480003 | ||||||
| HENRY, William Patrick | Director | Cybit Holdings Plc Cybit House Kingfisher Way Hinchingbrooke PE29 6FN Business Park Huntingdon Cambridgeshire | England | American | 119049370001 | |||||
| HORNE, David Robert Geoffrey | Director | The Timbers Coronation Road Littlewick Green SL6 3RA Maidenhead Berkshire | Britain | British | 31020910002 | |||||
| HORSMAN, Richard John | Director | House Wagon Lane TN2 6PT Paddock Wood High Lee Farm Kent England | United Kingdom | British | 160192730001 | |||||
| LAGORMARSINO, Antoine Jean-Baptiste | Director | Heckfield Place Heckfield RG27 0LD Hook Hampshire | French | 78647480001 | ||||||
| LAWRENCE, Kevin Brian | Director | Kingsbury House Arlington GL7 5ND Bibury Gloucestershire | England | British | 169886380001 | |||||
| MASSOL, Jose Andre | Director | 18 Rue Des Clos Ribauds 95550 Bessancourt FOREIGN France | British | 40427390001 | ||||||
| MCCREADY, James John | Director | Fairways 28b Barnton Avenue West EH4 6DE Edinburgh | United Kingdom | British | 426750003 | |||||
| MCKINNEY, David | Director | 11 Gordon Road SL4 3RG Windsor Berkshire | British | 75154230001 | ||||||
| MORAUD, Jean-Louis | Director | 8 Les Passereaux La Celle St Cloud 78170 France | French | 93664700001 | ||||||
| PALMER, Stuart Justin | Director | 213 Arethusa Way Bisley GU24 9BT Woking Surrey | England | United Kingdom | 80123680001 | |||||
| PRICE, Trevor Sheldon | Director | Garden Flat 50a Elmgrove Road KT13 8PD Weybridge Surrey | British | 47797870005 | ||||||
| RICHARDSON, Martin Roger | Director | The Old Rectory Mill Lane HP27 9LG Monks Risborough Buckinghamshire | United Kingdom | British | 46804640002 | |||||
| ROBERTS, Simon | Director | 3 Conygree Close Lower Earley RG6 4XE Reading Berkshire | United Kingdom | British | 43241480001 | |||||
| SUGDEN, Neil | Director | Speranza 1 Downs Road Compton RG20 6RE Newbury Berkshire | British | 30962840002 | ||||||
| WILLIAMS, Nicholas | Director | Cybit Holdings Plc Cybit House Kingfisher Way Hinchingbrooke PE29 6FN Business Park Huntingdon Cambridgeshire | England | British | 160931630001 | |||||
| WOOD, Brian Richard | Director | Hillgate 5 Pilgrims Way RH2 9LE Reigate Surrey | United Kingdom | British | 2475940001 |
¿Tiene CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creado el 23 ago 2011 Entregado el 06 sept 2011 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción £5,774 see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 07 mar 2008 Entregado el 14 mar 2008 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 15 feb 1999 Entregado el 24 feb 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of charge | Creado el 18 ene 1999 Entregado el 20 ene 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under or in relation to service provider agreements in relation to subscribers or the subscriber base of the company or in relation to other agreements | |
Breve descripción All chose in action, book and other debts now or in future owing to the company by subscribers of the company in relation to the subscriber base. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of charge | Creado el 03 nov 1997 Entregado el 08 nov 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the service provider agreement dated 3 november 1997 or otherwise in any manner whatsoever | |
Breve descripción By way of first fixed charge all book debts and other debts; by way of first floating charge all book debts other debts and any other rights benefits or interest comprised in the subscriber base.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de acreedores |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0