CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED

CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03374064
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?

    • Desarrollo de software para negocios y hogares (62012) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THALES TELEMATICS PLC02 ene 200202 ene 2002
    THALES TELEMATICS PLC02 ene 200202 ene 2002
    GLOBAL TELEMATICS PLC15 may 199715 may 1997

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    12 páginas4.72

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 09 sept 2013

    11 páginas4.68

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    2 páginasF10.2

    Domicilio social registrado cambiado de * Priory Park Great North Road Aberford West Yorkshire LS25 3DF United Kingdom* el 20 sept 2012

    2 páginasAD01

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19

    6 páginas4.20

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación

    LRESEX

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    20 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG04

    legacy

    3 páginasMG04

    legacy

    3 páginasMG02

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Déclaration annuelle établie au 15 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 may 2012

    Estado de capital el 15 may 2012

    • Capital: GBP 48,624,000
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de * Cybit Holdings Plc Cybit House Kingfisher Way Hinchingbrooke Business Park Huntingdon Cambridgeshire PE29 6FN* el 29 mar 2012

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Nicholas Williams como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de William Henry como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Paul Waterhouse como secretario

    1 páginasTM02

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2011 au 31 mar 2012

    1 páginasAA01

    Nombramiento de Mr Paul Francis Bosson como director

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    20 páginasAA

    Nombramiento de Mr Paul Keith Waterhouse como secretario

    1 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Nicholas Williams como director

    2 páginasAP01

    Exercice comptable en cours raccourci du 31 mar 2012 au 31 dic 2011

    1 páginasAA01

    ¿Quiénes son los directivos de CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BOSSON, Paul Francis
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    Director
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    EnglandBritish82707040001
    BELCHER, John Victor
    5 Woodpecker Close
    Twyford
    RG10 0BB Reading
    Berkshire
    Secretario
    5 Woodpecker Close
    Twyford
    RG10 0BB Reading
    Berkshire
    British10018180001
    LAWRENCE, Kevin Brian
    Kingsbury House
    Arlington
    GL7 5ND Bibury
    Gloucestershire
    Secretario
    Kingsbury House
    Arlington
    GL7 5ND Bibury
    Gloucestershire
    British169886380001
    PRICE, Trevor Sheldon
    39 Wolsey Road
    KT10 8NT Esher
    Surrey
    Secretario
    39 Wolsey Road
    KT10 8NT Esher
    Surrey
    British47797870003
    SEABROOK, Michael William Peter
    40 Horsell Park Close
    Horsell
    GU21 4LZ Woking
    Surrey
    Secretario
    40 Horsell Park Close
    Horsell
    GU21 4LZ Woking
    Surrey
    British70900110002
    WATERHOUSE, Paul Keith
    Cybit Holdings Plc Cybit House
    Kingfisher Way Hinchingbrooke
    PE29 6FN Business Park Huntingdon
    Cambridgeshire
    Secretario
    Cybit Holdings Plc Cybit House
    Kingfisher Way Hinchingbrooke
    PE29 6FN Business Park Huntingdon
    Cambridgeshire
    165522040001
    PAILEX CORPORATE SERVICES LIMITED
    First Floor Bouverie House
    154 Fleet Street
    EC4A 2DQ London
    Secretario designado corporativo
    First Floor Bouverie House
    154 Fleet Street
    EC4A 2DQ London
    900013000001
    AKBARI, Homaira
    5 Rue Du Pont De Lodi 75006
    FOREIGN Paris
    France
    Director
    5 Rue Du Pont De Lodi 75006
    FOREIGN Paris
    France
    American86832440001
    ASHTON, Max William Simon
    11 Holne Chase
    N2 0QP London
    Director
    11 Holne Chase
    N2 0QP London
    United KingdomBritish73381460001
    BARTLETT, Robert
    38 Ardingly
    Great Hollands
    RG12 8XR Bracknell
    Berkshire
    Director
    38 Ardingly
    Great Hollands
    RG12 8XR Bracknell
    Berkshire
    British71790550001
    BELGEONNE, Edward
    Winters Barn Cottage
    Frensham Lane
    GU35 8RU Headley
    Hampshire
    Director
    Winters Barn Cottage
    Frensham Lane
    GU35 8RU Headley
    Hampshire
    British4264610006
    BRUEGGER, Edmund Peter
    Cholwell Farm
    Clutton
    BS39 5TG Bristol
    Director
    Cholwell Farm
    Clutton
    BS39 5TG Bristol
    EnglandBritish13417490001
    BRUEGGER, Edmund Peter
    Cholwell Farm
    Clutton
    BS39 5TG Bristol
    Director
    Cholwell Farm
    Clutton
    BS39 5TG Bristol
    EnglandBritish13417490001
    CHEVREL, Roger Jean Marius
    16 Route Du Domaine
    Le Vesinet
    78110
    France
    Director
    16 Route Du Domaine
    Le Vesinet
    78110
    France
    French16515610001
    COLLINS, David Anthony
    First Floor, Bouverie House
    154 Fleet Street
    EC4A 2DQ London
    Director
    First Floor, Bouverie House
    154 Fleet Street
    EC4A 2DQ London
    British74345090001
    GALLAGHER, Daniel Joseph
    9 Cavendish Meads
    Sunninghill
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    Director
    9 Cavendish Meads
    Sunninghill
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    British And Irish49885010001
    GRIFFITHS, David Wynne
    6 Woodrough Copse
    Birtley Road Bramley
    GU5 0HH Guildford
    Surrey
    Director
    6 Woodrough Copse
    Birtley Road Bramley
    GU5 0HH Guildford
    Surrey
    British63953750001
    GUERIN, Stanislas Philippe
    116 Boulevard Raspail
    75006 Paris
    France
    Director
    116 Boulevard Raspail
    75006 Paris
    France
    French69237660001
    HARDY, Warren Andrew
    Great Gables Burkes Crescent
    HP9 1PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Great Gables Burkes Crescent
    HP9 1PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British68425480003
    HENRY, William Patrick
    Cybit Holdings Plc Cybit House
    Kingfisher Way Hinchingbrooke
    PE29 6FN Business Park Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    Cybit Holdings Plc Cybit House
    Kingfisher Way Hinchingbrooke
    PE29 6FN Business Park Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandAmerican119049370001
    HORNE, David Robert Geoffrey
    The Timbers
    Coronation Road Littlewick Green
    SL6 3RA Maidenhead
    Berkshire
    Director
    The Timbers
    Coronation Road Littlewick Green
    SL6 3RA Maidenhead
    Berkshire
    BritainBritish31020910002
    HORSMAN, Richard John
    House
    Wagon Lane
    TN2 6PT Paddock Wood
    High Lee Farm
    Kent
    England
    Director
    House
    Wagon Lane
    TN2 6PT Paddock Wood
    High Lee Farm
    Kent
    England
    United KingdomBritish160192730001
    LAGORMARSINO, Antoine Jean-Baptiste
    Heckfield Place
    Heckfield
    RG27 0LD Hook
    Hampshire
    Director
    Heckfield Place
    Heckfield
    RG27 0LD Hook
    Hampshire
    French78647480001
    LAWRENCE, Kevin Brian
    Kingsbury House
    Arlington
    GL7 5ND Bibury
    Gloucestershire
    Director
    Kingsbury House
    Arlington
    GL7 5ND Bibury
    Gloucestershire
    EnglandBritish169886380001
    MASSOL, Jose Andre
    18 Rue Des Clos Ribauds
    95550 Bessancourt
    FOREIGN France
    Director
    18 Rue Des Clos Ribauds
    95550 Bessancourt
    FOREIGN France
    British40427390001
    MCCREADY, James John
    Fairways
    28b Barnton Avenue West
    EH4 6DE Edinburgh
    Director
    Fairways
    28b Barnton Avenue West
    EH4 6DE Edinburgh
    United KingdomBritish426750003
    MCKINNEY, David
    11 Gordon Road
    SL4 3RG Windsor
    Berkshire
    Director
    11 Gordon Road
    SL4 3RG Windsor
    Berkshire
    British75154230001
    MORAUD, Jean-Louis
    8 Les Passereaux
    La Celle St Cloud
    78170
    France
    Director
    8 Les Passereaux
    La Celle St Cloud
    78170
    France
    French93664700001
    PALMER, Stuart Justin
    213 Arethusa Way
    Bisley
    GU24 9BT Woking
    Surrey
    Director
    213 Arethusa Way
    Bisley
    GU24 9BT Woking
    Surrey
    EnglandUnited Kingdom80123680001
    PRICE, Trevor Sheldon
    Garden Flat
    50a Elmgrove Road
    KT13 8PD Weybridge
    Surrey
    Director
    Garden Flat
    50a Elmgrove Road
    KT13 8PD Weybridge
    Surrey
    British47797870005
    RICHARDSON, Martin Roger
    The Old Rectory Mill Lane
    HP27 9LG Monks Risborough
    Buckinghamshire
    Director
    The Old Rectory Mill Lane
    HP27 9LG Monks Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish46804640002
    ROBERTS, Simon
    3 Conygree Close
    Lower Earley
    RG6 4XE Reading
    Berkshire
    Director
    3 Conygree Close
    Lower Earley
    RG6 4XE Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish43241480001
    SUGDEN, Neil
    Speranza
    1 Downs Road Compton
    RG20 6RE Newbury
    Berkshire
    Director
    Speranza
    1 Downs Road Compton
    RG20 6RE Newbury
    Berkshire
    British30962840002
    WILLIAMS, Nicholas
    Cybit Holdings Plc Cybit House
    Kingfisher Way Hinchingbrooke
    PE29 6FN Business Park Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    Cybit Holdings Plc Cybit House
    Kingfisher Way Hinchingbrooke
    PE29 6FN Business Park Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritish160931630001
    WOOD, Brian Richard
    Hillgate 5 Pilgrims Way
    RH2 9LE Reigate
    Surrey
    Director
    Hillgate 5 Pilgrims Way
    RH2 9LE Reigate
    Surrey
    United KingdomBritish2475940001

    ¿Tiene CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rent deposit deed
    Creado el 23 ago 2011
    Entregado el 06 sept 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    £5,774 see image for full details.
    Personas con derecho
    • Cheshire West and Chester Borough Council
    Transacciones
    • 06 sept 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 04 sept 2012Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Debenture
    Creado el 07 mar 2008
    Entregado el 14 mar 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 14 mar 2008Registro de un cargo (395)
    • 04 sept 2012Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Debenture
    Creado el 15 feb 1999
    Entregado el 24 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 24 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 18 ene 1999
    Entregado el 20 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in relation to service provider agreements in relation to subscribers or the subscriber base of the company or in relation to other agreements
    Breve descripción
    All chose in action, book and other debts now or in future owing to the company by subscribers of the company in relation to the subscriber base. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Telecom Securicor Cellular Radio Limited
    Transacciones
    • 20 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 03 nov 1997
    Entregado el 08 nov 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the service provider agreement dated 3 november 1997 or otherwise in any manner whatsoever
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all book debts and other debts; by way of first floating charge all book debts other debts and any other rights benefits or interest comprised in the subscriber base.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Vodafone Limited
    Transacciones
    • 08 nov 1997Registro de un cargo (395)
    • 04 sept 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene CYBIT POSITIONING SOLUTIONS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    10 sept 2012Inicio de la liquidación
    18 sept 2014Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    David William Tann
    Bridge House London Bridge
    SE1 9QR London
    Profesional
    Bridge House London Bridge
    SE1 9QR London
    Matthew John Waghorn
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Profesional
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0