BCMGLOBAL (UK) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BCMGLOBAL (UK) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03376447 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BCMGLOBAL (UK) LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra BCMGLOBAL (UK) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1st Floor, Crown House Crown Street IP1 3HS Ipswich England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BCMGLOBAL (UK) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LINK ASSET SERVICES (UK) LIMITED | 06 nov 2017 | 06 nov 2017 |
| CAPITA ASSET SERVICES (UK) LIMITED | 01 jul 2009 | 01 jul 2009 |
| CAPMARK SERVICES UK LIMITED | 15 may 2006 | 15 may 2006 |
| GMAC COMMERCIAL MORTGAGE LIMITED | 02 may 2002 | 02 may 2002 |
| GMAC COMMERCIAL MORTGAGE SERVICING (UNITED KINGDOM)LIMITED | 13 feb 2001 | 13 feb 2001 |
| UCB HEALTHCARE SERVICE COMPANY LIMITED | 23 oct 1997 | 23 oct 1997 |
| ASHJET LIMITED | 27 may 1997 | 27 may 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BCMGLOBAL (UK) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BCMGLOBAL (UK) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 31 mar 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 abr 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 31 mar 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BCMGLOBAL (UK) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cambio de datos del director Simon Gerardus Fitness el 02 sept 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 27 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Wilfrid Mark Richard Davies como director el 31 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Link Asset Services (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 may 2024 | 2 páginas | PSC05 | ||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 jun 2024 au 31 dic 2024 | 1 páginas | AA01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2023 | 27 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Simon Gerardus Fitness como director el 09 feb 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Adrian Richard Cloake como director el 31 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Selina Lee Burdell como director el 31 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Peter Charles Walker como director el 31 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Adrian Richard Cloake como director el 31 ago 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Selina Lee Burdell como director el 31 ago 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Link Group Corporate Director Limited como director el 31 ago 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Link Group Corporate Secretary Limited como secretario el 31 ago 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 6th Floor 65 Gresham Street London EC2V 7NQ United Kingdom a 1st Floor, Crown House Crown Street Ipswich IP1 3HS el 08 ago 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2022 | 26 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Grant Robert Tough como director el 01 abr 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Lisa Burns como director el 01 abr 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2021 | 25 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Wilfrid Mark Richard Davies como director el 30 jun 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Simon Fitness como director el 30 jun 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de BCMGLOBAL (UK) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURNS, Lisa | Director | Crown Street IP1 3HS Ipswich 1st Floor, Crown House England | Northern Ireland | Irish | 294315360001 | |||||||||
| FITNESS, Simon Gerardus | Director | Crown Street IP1 3HS Ipswich 1st Floor, Crown House England | England | New Zealander | 320228990002 | |||||||||
| CONWAY, Rory | Secretario | Neifinn Grange IRISH Dunboyne Meath Ireland | Irish | 113364860001 | ||||||||||
| KENNEDY, Margaret Catherine | Secretario | 42 Fisherman's Wharf Ringsend Dublin4 Irreland | Irish | 105849180001 | ||||||||||
| MALONEY, Lisa | Secretario | 157 Edenmore Crescent IRISH Raheny Dublin 5 Ireland | American | 75874850001 | ||||||||||
| REDDY, Vishnu | Secretario | 19 Breakspear Avenue AL1 5EJ St Albans Hertfordshire | British Australian | 114967920001 | ||||||||||
| CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED | Secretario corporativo | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom |
| 138426340001 | ||||||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 200 Aldersgate Street EC1A 4JJ London | 38508390002 | |||||||||||
| FLEETSIDE LEGAL REPRESENTATIVE SERVICES LTD | Secretario corporativo | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 74815810001 | |||||||||||
| LINK GROUP CORPORATE SECRETARY LIMITED | Secretario corporativo | 65 Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor United Kingdom |
| 239784340001 | ||||||||||
| AARONSON, Glenn Hunter | Director | Wild Strawberry House Love Lane GU31 4BU Petersfield Hampshire | American | 61193890002 | ||||||||||
| ALLATT, Gareth Geoffrey | Director | Rochester Row Westminster SW1P 1QT London 17 | United Kingdom | British | 195492410001 | |||||||||
| BELLEZZA, Karen | Director | 225 Mimosa Lane Hatboro Pa 19040 Usa | United States | 98079540002 | ||||||||||
| BURDELL, Selina Lee | Director | 5 Wilton Road SW1V 1AN London The Peak England | United Kingdom | British | 313920020001 | |||||||||
| CHARLTON, Peter John | Director | 17 Kirkdale Road AL5 2PT Harpenden Hertfordshire | British | 40726920001 | ||||||||||
| CLOAKE, Adrian Richard | Director | 5 Wilton Road SW1V 1AN London The Peak England | United Kingdom | British | 313920080001 | |||||||||
| COYLE, Robert Charles | Director | Rochester Row Westminster SW1P 1QT London 17 | British | 72913450003 | ||||||||||
| CREAMER, David E | Director | 490 Anna Lynn Lane Horsham Pa 19044 Usa | Usa | 74816310001 | ||||||||||
| DALTON, James Anthony | Director | Flat No 11 36 Eaton Square SW1W 9DH London | Irish | 85215070002 | ||||||||||
| DAVIES, Wilfrid Mark Richard | Director | Crown Street IP1 3HS Ipswich 1st Floor, Crown House England | England | British | 140234630003 | |||||||||
| DOOLEY, Clare | Director | 22 Hawthorn Lodge Castlebrook Dublin 15 | Irish | 83187480001 | ||||||||||
| DUNLEAVY, Charles E | Director | 4384 Meehanicsville Road 18937 Mechanicsville Pennsylvania Usa | American | 74987640001 | ||||||||||
| FARRAGHER, Siobhan | Director | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | Ireland | Irish | 161551130001 | |||||||||
| FITNESS, Simon | Director | 65 Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor United Kingdom | United Kingdom | New Zealander | 228732430002 | |||||||||
| HOCH, Wayne | Director | 1450 Sackettsford Road Ivyland Pennsylvania Pa 18974 Usa | American | 83187900001 | ||||||||||
| HUGHES, Robert | Director | 235 Collinswood, IRISH Dublin 9 Ireland | Ireland | Irish | 158509370001 | |||||||||
| KEARNEY, Peter David | Director | 22 Avondale Crescent Killiney IRISH Dublin Ireland | Ireland | Irish | 265676560001 | |||||||||
| LAWRENCE, Garry Anthony | Director | Flat 2 44 Fellows Road NW3 3LH London | British | 59475920001 | ||||||||||
| MILLAN, Jacqueline | Director | 65 Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 187383940002 | |||||||||
| MOORE, Barry Alan | Director | 23 Aylesbury Road IRISH Dublin 4 4 Eire | American | 74816340001 | ||||||||||
| NASH, Jeffrey Frederick | Director | The Coach House St Matthews Road Ealing W5 3JT London | United Kingdom | British | 53992520001 | |||||||||
| O'BRIEN, Conor | Director | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | Ireland | Irish | 164041710001 | |||||||||
| O'LEARY, James Michael | Director | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | Ireland | Irish | 158509540001 | |||||||||
| PATRICK, Christopher John | Director | 8 High Park Road Kew TW9 4BH Richmond Surrey | Usa | 48804210003 | ||||||||||
| REDDY, Vishnu | Director | 19 Breakspear Avenue AL1 5EJ St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British Australian | 114967920001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BCMGLOBAL (UK) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bcm Asset Services (Holdings) Limited | 06 abr 2016 | Wilton Road SW1V 1AN London The Peak, 5, England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0