THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | 03376501 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED?
- Actividades de museos (91020) / Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
¿Dónde se encuentra THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED?
| Dirección de la sede social | Beaulieu Drive Waltham Abbey EN9 1JY Essex United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| THE OPERATING CHARITABLE COMPANY LIMITED | 21 may 1997 | 21 may 1997 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2027 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 21 may 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 04 jun 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 21 may 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2025 | 28 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 may 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 20 páginas | MA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Grahame Seymour Browne como director el 31 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2024 au 30 jun 2025 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Column House London Road Shrewsbury Shropshire SY2 6NN United Kingdom a Beaulieu Drive Waltham Abbey Essex EN9 1JY el 13 nov 2024 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Mark Pemberton como director el 31 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Rosanna Lawes como director el 31 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2023 | 31 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jill Amador como director el 22 jun 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Geoffrey Hooper como director el 10 mar 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Len Stuart como director el 29 nov 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Darrell Egan como director el 11 oct 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2022 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 20 páginas | MA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 may 2023 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew David Macdonald como director el 31 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jeremy John Brown como director el 09 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Rosanna Lawes como director el 29 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Andrew David Macdonald como director el 29 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Peter Darrell Egan como director el 27 feb 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Suite 407 Grosvenor House Central Park Telford TF2 9TW England a Column House London Road Shrewsbury Shropshire SY2 6NN el 05 oct 2022 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAXTER, Fiona Elizabeth Ann | Director | Waltham Abbey EN9 1JY Essex Beaulieu Drive United Kingdom | United Kingdom | British | 175985510001 | |||||
| MCIVER, Andrew Ross | Director | Waltham Abbey EN9 1JY Essex Beaulieu Drive United Kingdom | United Kingdom | British | 69125840004 | |||||
| RICHARDSON, James Andrew | Director | Waltham Abbey EN9 1JY Essex Beaulieu Drive United Kingdom | United Kingdom | British | 193813560001 | |||||
| DAVIES, Ian | Secretario | 66 High Street Dawley TF4 2HD Telford Shropshire | 200932520001 | |||||||
| LOWE, Michael John | Secretario | The Manor House Admaston TF5 0AD Telford Shropshire | British | 2729860001 | ||||||
| HALCO SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 8-10 New Fetter Lane EC4A 1RS London | 42871950001 | |||||||
| ABBEY, Ian Edward, Councillor | Director | 35 Oak Piece North Weald Bassett CM16 6JH Epping Essex | British | 45351230001 | ||||||
| ADAMS, Peter Robin | Director | 2 Highview Close IG10 3EG Loughton | Great Britain | British | 57421510002 | |||||
| AMADOR, Jill | Director | London Road SY2 6NN Shrewsbury Column House Shropshire United Kingdom | England | Irish | 245832080001 | |||||
| AMADOR, Jill | Director | 66 High Street Dawley TF4 2HD Telford Shropshire | England | Irish | 245832080001 | |||||
| BARNARD, Paul Robert | Director | Grosvenor House Central Park TF2 9TW Telford Suite 407 England | England | British | 282007990001 | |||||
| BOURNE, Lance Cedric | Director | Trinity Lane EN8 7EW Waltham Cross 137 Hertfordshire England | Britain | British | 200973050001 | |||||
| BOWLES, John Huw | Director | 9 Humber Road SE3 7LS London | England | British | 96154420001 | |||||
| BROWN, Jeremy John | Director | London Road SY2 6NN Shrewsbury Column House Shropshire United Kingdom | England | British | 284749460001 | |||||
| BROWNE, Grahame Seymour | Director | Waltham Abbey EN9 1JY Essex Beaulieu Drive United Kingdom | United Kingdom | British | 205076270001 | |||||
| BROWNE, Grahame Seymour | Director | Heron Close IG9 5TP Buckhurst Hill 8 Essex England | United Kingdom | British | 205076270001 | |||||
| CROCKER, Alan Godfrey, Dr | Director | 6 Burwood Close Merrow GU1 2SB Guildford Surrey | United Kingdom | British | 15839570001 | |||||
| CROSBY, Anthony Barry | Director | 66 High Street Dawley TF4 2HD Telford Shropshire | England | British | 183109980001 | |||||
| CROWE, Frances Mary | Director | Little Goddards Hunsdon Road, Widford SG12 8SE Ware Hertfordshire | British | 70706650001 | ||||||
| DENHAM, Richard Antony | Director | 35 Winters Way EN9 3HR Waltham Abbey Essex | British | 76192780001 | ||||||
| EARLE, James Christopher Reginald St John | Director | 1 Temple Close Duxford CB2 4PX Cambridge | United Kingdom | British | 175935710001 | |||||
| EDEN, Keith Leslie | Director | 6 Friends Walk CB11 4EA Saffron Walden Essex | United Kingdom | British | 53429470001 | |||||
| EGAN, Peter Darrell | Director | London Road SY2 6NN Shrewsbury Column House Shropshire United Kingdom | England | British | 193634760001 | |||||
| EYRE, Karen Fiona | Director | 14 Norfolk Road NW8 6HE London | British | 50065100001 | ||||||
| FREEMAN, Jennifer Margaret, Dr | Director | Kensington Gate W8 5NA London 8 England | England | British | 43387130001 | |||||
| GAMBLE, Terence Joel | Director | Penman Close AL2 3DJ St. Albans 7 Hertfordshire England | United Kingdom | British | 45396650001 | |||||
| GOODWIN, Timothy Robert Thomas | Director | 33 Kent Avenue Ealing W13 8BE London | England | British | 97546570001 | |||||
| GREEN, Norma Lea | Director | Highfields Wellington Hill High Beech IG10 4AH Loughton Essex | British | 51580310001 | ||||||
| HARVEY, Brian | Director | Dark Lane Cheshunt EN7 5ED Waltham Cross 3 Hertfordshire England | England | British | 185586290001 | |||||
| HOOPER, Geoffrey, Dr | Director | Beaulieu Drive EN9 1JY Waltham Abbey Royal Gunpowder Mills England | England | British | 57156930001 | |||||
| HOOPER, Geoffrey, Dr | Director | 17 Stonyshotts EN9 3DF Waltham Abbey Essex | England | British | 57156930001 | |||||
| IVES, Martin Victor | Director | Liberty Close SG13 8JY Hertford 34 England | England | British | 206055210001 | |||||
| JONES, Philippa Whiston | Director | 97a Moray Road N4 3LB London | England | British | 57157500001 | |||||
| KENT, Douglas David | Director | Wendens Ambo CB11 4JL Saffron Walden The Outspan Essex England | England | British | 128394080001 | |||||
| KNAPP, Trevor | Director | 32 Hawthorne Road BR1 2HH Bickley Kent | England | British | 57156890001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Dr Jennifer Margaret Freeman | 01 jun 2016 | 66 High Street Dawley TF4 2HD Telford Shropshire | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS COMPANY LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 12 ago 2021 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0