BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED

BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBORDER RADIO HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03376590
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Media House Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 27 may 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 27 may 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Paul Anthony Keenan el 25 sept 2018

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 27 may 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 27 may 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mrs Deidre Ann Ford el 30 sept 2016

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mrs Sarah Jane Vickery el 30 sept 2016

    2 páginasCH01

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2016 au 31 dic 2016

    1 páginasAA01

    Nombramiento de Bauer Group Secretariat Limited como secretario el 05 may 2016

    2 páginasAP04

    Déclaration annuelle établie au 27 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    15 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 jul 2016

    Estado de capital el 28 jul 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cambio de datos del director Mrs Sarah Jane Vickery el 14 jul 2016

    3 páginasCH01

    Nombramiento de Mrs Sarah Jane Vickery como director el 05 may 2016

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Deidre Ann Ford como director el 05 may 2016

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Paul Anthony Keenan como director el 05 may 2016

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Philip Stephen Riley como director el 05 may 2016

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark Roy Evans como secretario el 05 may 2016

    2 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Mark Roy Evans como director el 05 may 2016

    2 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Section 172 10/06/2016
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    13 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    ¿Quiénes son los directivos de BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro00944753
    159023720001
    FORD, Deidre Ann
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Director
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United KingdomBritish109666380002
    KEENAN, Paul Anthony
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Director
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritish243390510001
    VICKERY, Sarah Jane
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Director
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritish119137220004
    CUSICK, Nicholas Jonathan Paul
    30 Longlands Road
    CA3 9AD Carlisle
    Secretario
    30 Longlands Road
    CA3 9AD Carlisle
    British50942120001
    EVANS, Mark Roy
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    Secretario
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    British54693600002
    FITZJOHN, Julie
    Basement Flat
    78 Elgin Avenue
    W9 2HB London
    Secretario
    Basement Flat
    78 Elgin Avenue
    W9 2HB London
    British92875290001
    FLUET, Cliff
    11 Rokesly Avenue
    N8 8NS London
    Secretario
    11 Rokesly Avenue
    N8 8NS London
    British97684290001
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    Secretario designado
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    MCGARTOLL, Owen Raphael
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Secretario
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Irish116537370001
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Secretario
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Secretario
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    SCHWARZ, Nathalie Esther
    Flat 10
    28 Belsize Avenue
    NW3 4AU London
    Secretario
    Flat 10
    28 Belsize Avenue
    NW3 4AU London
    British59245010001
    BROWNLOW, Peter
    Quarry Bank Capon Hill
    CA8 1QN Brampton
    Cumbria
    Director
    Quarry Bank Capon Hill
    CA8 1QN Brampton
    Cumbria
    British4459070001
    BURGESS, Robert Lawie Frederick
    Hall Flatt
    Scaleby
    CA6 4LE Carlisle
    Cumbria
    Director
    Hall Flatt
    Scaleby
    CA6 4LE Carlisle
    Cumbria
    United KingdomBritish61711750001
    CORLEY, Paul
    3 Willoughby Street
    WC1A 1JD London
    Director
    3 Willoughby Street
    WC1A 1JD London
    British60591660003
    EVANS, Mark Roy
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Director
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritish54693600002
    EVANS, Mark Roy
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    Director
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish54693600002
    FAIRBURN, Paul Martin
    9 Tansley Gardens
    Dorridge
    B93 8UB Solihull
    West Midlands
    Director
    9 Tansley Gardens
    Dorridge
    B93 8UB Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish43039880003
    FITZJOHN, Julie
    Basement Flat
    78 Elgin Avenue
    W9 2HB London
    Director
    Basement Flat
    78 Elgin Avenue
    W9 2HB London
    United KingdomBritish92875290001
    GRAHAM, James Lowery
    Oak House
    Great Corby
    CA4 8NE Carlisle
    Cumbria
    Director
    Oak House
    Great Corby
    CA4 8NE Carlisle
    Cumbria
    British2014530001
    HARRIS, Peter Jonathan
    381 Wimbledon Park Road
    SW19 6PE London
    Director
    381 Wimbledon Park Road
    SW19 6PE London
    EnglandBritish40917640001
    MANSFIELD, David James
    16 Sudbrooke Road
    SW12 8TG London
    Director
    16 Sudbrooke Road
    SW12 8TG London
    United KingdomBritish32585450001
    MCGARTOLL, Owen Raphael
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Director
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Irish116537370001
    MYERS, John Frederick
    21 Middle Drive
    Darras Hal
    NE20 9DH Ponteland
    Northumberland
    Director
    21 Middle Drive
    Darras Hal
    NE20 9DH Ponteland
    Northumberland
    British70386430001
    PARK, Richard Francis Jackson
    55 Gloucester Crescent
    NW1 7EG London
    Director
    55 Gloucester Crescent
    NW1 7EG London
    EnglandBritish75081070002
    QUINN, Andrew
    Kilnholme
    Penton
    CA6 5QZ Carlisle
    Director
    Kilnholme
    Penton
    CA6 5QZ Carlisle
    British42394270002
    RILEY, Philip Stephen
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Director
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritish140085310001
    TABOR, Ashley Daniel
    Apartment 11-02
    The Knightsbridge Apartments, 199 Knightsbridge
    SW17 1RH London
    Director
    Apartment 11-02
    The Knightsbridge Apartments, 199 Knightsbridge
    SW17 1RH London
    United KingdomBritish56313240002
    THOMSON, Donald Alexander
    Shelley Lodge
    104 West Street
    SL7 2BP Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    Shelley Lodge
    104 West Street
    SL7 2BP Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish37668550003
    TRIMBLE, David William
    Deepdale
    Dalston
    CA5 7BH Carlisle
    Cumbria
    Director
    Deepdale
    Dalston
    CA5 7BH Carlisle
    Cumbria
    British11476910001
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Director designado corporativo
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    06 abr 2016
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3050677
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 20 may 2011
    Entregado el 27 may 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the note issuer and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Andrew Price
    Transacciones
    • 27 may 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 25 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 05 may 2010
    Entregado el 20 may 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from orion media limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Matthew Paul Ramsbottom
    Transacciones
    • 20 may 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 29 abr 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 05 may 2010
    Entregado el 20 may 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from orion media limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Robert John Norman
    Transacciones
    • 20 may 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 25 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 05 may 2010
    Entregado el 18 may 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the note issuer to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Geoffrey Percy
    Transacciones
    • 18 may 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 25 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 05 may 2010
    Entregado el 13 may 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from orion media holdings limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Global Radio Group Limited
    Transacciones
    • 13 may 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 25 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 31 jul 2009
    Entregado el 06 ago 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transacciones
    • 06 ago 2009Registro de un cargo (395)
    • 25 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 31 jul 2009
    Entregado el 06 ago 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Philip Riley
    Transacciones
    • 06 ago 2009Registro de un cargo (395)
    • 25 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 31 jul 2009
    Entregado el 06 ago 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery a specific equitable charge over all freehold & leasehold properties &/or the proceeds of sale thereof, fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present & future including goodwill, book debts & the benefit of any licences.
    Personas con derecho
    • Antony Thomas Lloyd
    Transacciones
    • 06 ago 2009Registro de un cargo (395)
    • 25 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 31 jul 2009
    Entregado el 05 ago 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All land vested in or charged to the chargor, all fixtures and fittings attached to the land and all rents, all plant & machinery, contacts goodwill uncalled capital stocks shares patents copyrights and all other intellectual property rights. A floating charge over all the other property assets and rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 05 ago 2009Registro de un cargo (395)
    • 29 abr 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage debenture
    Creado el 31 mar 1999
    Entregado el 09 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0